RETAIL PROFILE HOLDINGS LIMITED

RETAIL PROFILE HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRETAIL PROFILE HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06139685
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RETAIL PROFILE HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova RETAIL PROFILE HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o SHERRARDS SOLICITORS
    1-3 Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RETAIL PROFILE HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AMERY CAPITAL III (RPEL) LIMITED13 mar 200713 mar 2007
    FLOORBULB LIMITED06 mar 200706 mar 2007

    Quali sono gli ultimi bilanci di RETAIL PROFILE HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per RETAIL PROFILE HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2022

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    16 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Memorandum e Statuto

    28 pagineMA

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    16 pagineAA

    Cessazione della carica di Matthew John Bending come amministratore in data 17 set 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    2 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 061396850005, creata il 30 nov 2018

    51 pagineMR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 mar 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di RETAIL PROFILE HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DUNLAY, Gregor Rankin
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    United Kingdom
    Segretario
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    United Kingdom
    161956550001
    CULLEN, Nancy Jane
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector72926330002
    DUNLAY, Gregor Rankin
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant113318710001
    BENNETT, Maurice
    Kirkman House
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    United Kingdom
    Segretario
    Kirkman House
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    United Kingdom
    154562230001
    BENNETT, Michael
    12-14
    Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    England
    Segretario
    12-14
    Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    England
    154563570001
    LEE, Benjamin Graham
    Berwin Leighton Paisner Llp
    Adelaide House London Bridge
    EC4R 9HA London
    Segretario
    Berwin Leighton Paisner Llp
    Adelaide House London Bridge
    EC4R 9HA London
    British121579520001
    THOMSON, Thomas Andrew
    14 South Drive
    RG40 2DH Wokingham
    Berkshire
    Segretario
    14 South Drive
    RG40 2DH Wokingham
    Berkshire
    BritishDirector121508200001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BENDING, Matthew John
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Sherrards Solicitors
    Pemberton Row
    EC4A 3BG London
    1-3
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Executive75953430001
    BENNETT, Maurice
    9 Ingram Avenue
    NW11 6TG London
    Amministratore
    9 Ingram Avenue
    NW11 6TG London
    EnglandEnglishDirector96696270001
    BENNETT, Michael
    Bedegars Lea Kenwood Close
    NW3 7JL London
    Amministratore
    Bedegars Lea Kenwood Close
    NW3 7JL London
    EnglandBritishDirector2673650001
    HELFGOTT, Maurice Harold
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3 Kirkman House
    Amministratore
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3 Kirkman House
    United KingdomBritishCompany Director141820660001
    KEMP, Martin Dunlop
    Kirkman House
    10-12 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    United Kingdom
    Amministratore
    Kirkman House
    10-12 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector133534260001
    LANGKRAEHR, Julia
    Kirkman House
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    England
    Amministratore
    Kirkman House
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    England
    United KingdomBritishCompany Director105467470001
    THOMSON, Thomas Andrew
    Kirkman House
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    England
    Amministratore
    Kirkman House
    12-14 Whitfield Street
    W1T 2RF London
    Level 3
    England
    United KingdomBritishDirector121508200001
    WILSON, Kathleen
    60f Oxford Gardens
    W10 5UN London
    Amministratore
    60f Oxford Gardens
    W10 5UN London
    AmericanDirector91838490003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di RETAIL PROFILE HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Spaceandpeople Plc
    West Regent Street
    G2 2QD Glasgow
    100
    Scotland
    06 apr 2016
    West Regent Street
    G2 2QD Glasgow
    100
    Scotland
    No
    Forma giuridicaPlc
    Paese di registrazioneScotland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneComanies House
    Numero di registrazioneSc212277
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    RETAIL PROFILE HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 30 nov 2018
    Consegnato il 03 dic 2018
    In corso
    Breve descrizione
    N/A.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Santander UK PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 03 dic 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 07 lug 2011
    Consegnato il 09 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 09 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Trust debenture
    Creato il 24 mag 2010
    Consegnato il 28 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Maurice Helfgott (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 28 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of assignment and charge relating to contracts
    Creato il 20 apr 2007
    Consegnato il 28 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All rights title and interest in the charged contracts and the contract proceeds,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 apr 2007
    Consegnato il 28 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 28 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0