SOUTH HAMS COMMUNITY ACTION LTD

SOUTH HAMS COMMUNITY ACTION LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOUTH HAMS COMMUNITY ACTION LTD
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale
    Numero di società 06215893
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di SOUTH HAMS COMMUNITY ACTION LTD?

    • Attività di altre organizzazioni di categoria n.c.a. (94990) / Altre attività di servizi

    Dove si trova SOUTH HAMS COMMUNITY ACTION LTD?

    Indirizzo della sede legale
    30 Fore Street
    TQ9 5RP Totnes
    Devon
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOUTH HAMS COMMUNITY ACTION LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SOUTH HAMS COMMUNITY & VOLUNTARY SERVICES17 apr 200717 apr 2007

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTH HAMS COMMUNITY ACTION LTD?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al30 giu 2025
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2024

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per SOUTH HAMS COMMUNITY ACTION LTD?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al09 apr 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma23 apr 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al09 apr 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per SOUTH HAMS COMMUNITY ACTION LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 apr 2025 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Follaton House Plymouth Road Totnes TQ9 5NE England a 30 Fore Street Totnes Devon TQ9 5RP in data 22 apr 2025

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Penny Ann Elghady. come amministratore in data 03 set 2024

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Maudie Spurrier come amministratore in data 31 mar 2025

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 mar 2025 al 30 giu 2025

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Claire Hill come amministratore in data 22 gen 2025

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2024

    24 pagineAA

    Nomina di Ms Maudie Spurrier come amministratore in data 24 lug 2024

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Jane Abbey come amministratore in data 30 apr 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Mark Howard Peter Spiers come amministratore in data 08 mag 2024

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 apr 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2023

    23 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed south hams community & voluntary services\certificate issued on 27/10/23
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name27 ott 2023

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 17 ott 2023

    RES15

    Indirizzo della sede legale modificato da The Mansion 36 Fore Street Totnes TQ9 5RP England a Follaton House Plymouth Road Totnes TQ9 5NE in data 09 ago 2023

    1 pagineAD01

    Nomina di Mrs Jackie Wesley come segretario in data 01 ago 2023

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Darran Hill come segretario in data 23 giu 2023

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 16 apr 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Mark Howard Peter Spiers come amministratore in data 14 mar 2023

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Barbara Anne Price come amministratore in data 14 mar 2023

    2 pagineAP01

    Nomina di Ms Claire Hill come amministratore in data 14 mar 2023

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Tessa Mary Blight come amministratore in data 15 mar 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Darran Hill come segretario in data 13 feb 2023

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Susan Mary Bladon come amministratore in data 19 gen 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jill Frances Davies come segretario in data 31 gen 2023

    1 pagineTM02

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2022

    21 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SOUTH HAMS COMMUNITY ACTION LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WESLEY, Jackie
    New Road
    TQ5 8NL Brixham
    Melville
    England
    Segretario
    New Road
    TQ5 8NL Brixham
    Melville
    England
    311971730001
    ABBEY, Jane
    TQ9 5RP Totnes
    30 Fore Street
    Devon
    United Kingdom
    Amministratore
    TQ9 5RP Totnes
    30 Fore Street
    Devon
    United Kingdom
    EnglandBritishRetired323701340001
    PETERS, Timothy
    Follaton, Plymouth Road
    TQ9 5ND Totnes
    47
    England
    Amministratore
    Follaton, Plymouth Road
    TQ9 5ND Totnes
    47
    England
    United KingdomBritishPart Time Retail225161360001
    PRICE, Barbara Anne
    Poundwell Street
    Modbury
    PL21 0QJ Ivybridge
    1
    England
    Amministratore
    Poundwell Street
    Modbury
    PL21 0QJ Ivybridge
    1
    England
    EnglandBritishRetired91444550002
    TRIGGER, David James
    Loddiswell
    TQ7 4SJ Kingsbridge
    Courtledge House
    Devon
    Amministratore
    Loddiswell
    TQ7 4SJ Kingsbridge
    Courtledge House
    Devon
    EnglandBritishRetired52678150002
    DAVIES, Jill Frances
    36 Fore Street
    TQ9 5RP Totnes
    The Mansion
    England
    Segretario
    36 Fore Street
    TQ9 5RP Totnes
    The Mansion
    England
    British132851890002
    HILL, Darran
    36 Fore Street
    TQ9 5RP Totnes
    The Mansion
    England
    Segretario
    36 Fore Street
    TQ9 5RP Totnes
    The Mansion
    England
    305607810001
    BRIGHTON SECRETARY LIMITED
    Midstall
    Randolph's Farm, Brighton Road
    BN6 9EL Hurstpierpoint
    West Sussex
    Segretario
    Midstall
    Randolph's Farm, Brighton Road
    BN6 9EL Hurstpierpoint
    West Sussex
    119868160001
    BATES, Ronald
    Rotherdene Kiln Lane
    Stokenham
    TQ7 2SQ Kingsbridge
    Devon
    Amministratore
    Rotherdene Kiln Lane
    Stokenham
    TQ7 2SQ Kingsbridge
    Devon
    EnglandBritishRetired40950780001
    BENZIES, Claudia Mary
    Blackawton
    TQ9 7BN Totnes
    Myrtle Cottage
    Devon
    Amministratore
    Blackawton
    TQ9 7BN Totnes
    Myrtle Cottage
    Devon
    EnglandBritishCharity Worker138489880001
    BLADON, Susan Mary
    36 Fore Street
    TQ9 5RP Totnes
    The Mansion
    England
    Amministratore
    36 Fore Street
    TQ9 5RP Totnes
    The Mansion
    England
    EnglandBritishN/A281771470001
    BLIGHT, Tessa Mary
    36 Fore Street
    TQ9 5RP Totnes
    The Mansion
    England
    Amministratore
    36 Fore Street
    TQ9 5RP Totnes
    The Mansion
    England
    EnglandBritishN/A281771210001
    DREDGE, Philip Frank
    36 Fore Street
    TQ9 5RP Totnes
    The Mansion
    England
    Amministratore
    36 Fore Street
    TQ9 5RP Totnes
    The Mansion
    England
    EnglandUnited KingdomRetired85582770001
    EDWARDS, Mary
    Follaton House
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    The Cottage
    Devon
    Amministratore
    Follaton House
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    The Cottage
    Devon
    United KingdomBritishConsultancy60214870001
    ELGHADY., Penny Ann
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    Follaton House
    England
    Amministratore
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    Follaton House
    England
    EnglandBritishCharity Worker228501270001
    FRASER, Helen Mary Catherine
    14 Ebrington Street
    TQ7 1DE Kingsbridge
    Devon
    Amministratore
    14 Ebrington Street
    TQ7 1DE Kingsbridge
    Devon
    Great BritainBritishManager88895060002
    HARVEY, Amanda Kate
    Follaton House
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    The Cottage
    Devon
    Amministratore
    Follaton House
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    The Cottage
    Devon
    EnglandBritishLocal Government Officer149847900001
    HARVEY, Amanda Kate
    Follaton House
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    The Cottage
    Devon
    Amministratore
    Follaton House
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    The Cottage
    Devon
    EnglandBritishLocal Government Officer149847900001
    HAWKE, Francis John
    69 Britannia Avenue
    TQ6 9JZ Dartmouth
    Devon
    Amministratore
    69 Britannia Avenue
    TQ6 9JZ Dartmouth
    Devon
    United KingdomBritishSole Trader123745760001
    HILL, Charlotte
    Plymouth Road
    Follaton House
    TQ9 5NE Totnes
    The Cottage
    Devon
    England
    Amministratore
    Plymouth Road
    Follaton House
    TQ9 5NE Totnes
    The Cottage
    Devon
    England
    EnglandBritishSelf Employed Consultant187982000001
    HILL, Claire
    Dunstone View
    PL9 8QJ Plymouth
    141
    England
    Amministratore
    Dunstone View
    PL9 8QJ Plymouth
    141
    England
    EnglandBritishChief Executive307738370001
    LAITY, Ann
    36 Fore Street
    TQ9 5RP Totnes
    The Mansion
    England
    Amministratore
    36 Fore Street
    TQ9 5RP Totnes
    The Mansion
    England
    EnglandBritishRetired225169860001
    LINGARD, David Malcolm Hood, Commander
    Archway Cottage
    Old Mill Lane
    TQ6 9JQ Dartmouth
    Devon
    Amministratore
    Archway Cottage
    Old Mill Lane
    TQ6 9JQ Dartmouth
    Devon
    EnglandBritishRetired125952260001
    MCCAHILL, Hugh Mclellan
    16 Lansdowne Park
    TQ9 5UP Totnes
    Devon
    Amministratore
    16 Lansdowne Park
    TQ9 5UP Totnes
    Devon
    EnglandBritishRtd125951950001
    NUTT, Deirdre
    Follaton House
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    The Cottage
    Devon
    Amministratore
    Follaton House
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    The Cottage
    Devon
    United KingdomBritishRetired173433700001
    ROLFE, Jane
    17 Keyberry Park
    TQ12 1DF Newton Abbot
    Devon
    Amministratore
    17 Keyberry Park
    TQ12 1DF Newton Abbot
    Devon
    BritishOutreach Worker125952130001
    ROSATI, Victor James
    16 Saint Katherines Mews
    Saint Katherines Way
    TQ9 5DN Totnes
    Devon
    Amministratore
    16 Saint Katherines Mews
    Saint Katherines Way
    TQ9 5DN Totnes
    Devon
    EnglandBritishRetired105977680001
    ROYLE, Gwendoline Ann
    Follaton House
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    The Cottage
    Devon
    Amministratore
    Follaton House
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    The Cottage
    Devon
    United KingdomBritishRetired149848340001
    SMERDON, Peter Courtnay, Cllr
    36 Fore Street
    TQ9 5RP Totnes
    The Mansion
    England
    Amministratore
    36 Fore Street
    TQ9 5RP Totnes
    The Mansion
    England
    EnglandBritishFarmer162564680001
    SPIERS, Mark Howard Peter
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    Follaton House
    England
    Amministratore
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    Follaton House
    England
    EnglandBritishConsultant237572190001
    SPURRIER, Maudie
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    Follaton House
    England
    Amministratore
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    Follaton House
    England
    EnglandBritishSenior Advisor, The Environment Agency325647520001
    SQUIRE, John William
    Follaton House
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    The Cottage
    Devon
    Amministratore
    Follaton House
    Plymouth Road
    TQ9 5NE Totnes
    The Cottage
    Devon
    EnglandBritishRetired152569250001
    BRIGHTON DIRECTOR LIMITED
    Midstall
    Randolph's Farm, Brighton Road
    BN6 9EL Hurstpierpoint
    West Sussex
    Amministratore
    Midstall
    Randolph's Farm, Brighton Road
    BN6 9EL Hurstpierpoint
    West Sussex
    119868010001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per SOUTH HAMS COMMUNITY ACTION LTD?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    16 apr 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0