FOUR SEASONS ENERGY MANAGEMENT GROUP LIMITED

FOUR SEASONS ENERGY MANAGEMENT GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFOUR SEASONS ENERGY MANAGEMENT GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06233973
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FOUR SEASONS ENERGY MANAGEMENT GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova FOUR SEASONS ENERGY MANAGEMENT GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Four Seasons House Astley Lane Trading
    Estate Swillington
    LS26 8XT Leeds
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di FOUR SEASONS ENERGY MANAGEMENT GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COBCO 835 LIMITED02 mag 200702 mag 2007

    Quali sono gli ultimi bilanci di FOUR SEASONS ENERGY MANAGEMENT GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per FOUR SEASONS ENERGY MANAGEMENT GROUP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per FOUR SEASONS ENERGY MANAGEMENT GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di James Lawrie come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Maurice Mcbride come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital11 giu 2013

    Stato del capitale al 11 giu 2013

    • Capitale: GBP 3,086,200
    SH01

    Dimissioni del revisore

    2 pagineAUD

    Varie

    Section 519
    1 pagineMISC

    Dimissioni del revisore

    1 pagineAUD

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2011

    32 pagineAA

    Cessazione della carica di Timothy Hall come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Timothy Hall come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Timothy Stevenson Hall il 09 mag 2012

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Mr James Stuart Lawrie il 09 mag 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Stevenson Hall il 09 mag 2012

    2 pagineCH01

    Memorandum e Statuto

    60 pagineMEM/ARTS

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2010

    33 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed cobco 835 LIMITED\certificate issued on 29/09/11
    2 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name29 set 2011

    Risoluzione di cambio di nome della società il 27 set 2011

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    1 pagineCONNOT

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 02 set 2011

    • Capitale: GBP 3,086,200.00
    33 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    61 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Secondo deposito di SH01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio

    21 pagineRP04
    Note
    DataNota
    08 lug 2011This is a second filing of the SH01 registered on 17/06/2011.

    Risoluzioni

    Resolutions
    60 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 09 giu 2011

    • Capitale: GBP 3,138,100.00
    20 pagineSH01
    Note
    DataNota
    08 lug 2011This document was second filed on 08/07/2011

    Chi sono gli amministratori di FOUR SEASONS ENERGY MANAGEMENT GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HALL, Timothy Stevenson
    Astley Lane Trading
    Estate Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Four Seasons House
    West Yorkshire
    Segretario
    Astley Lane Trading
    Estate Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Four Seasons House
    West Yorkshire
    British125313360002
    THOMAS-KEEPING, Lindsay Charles
    The Wing House
    The Old Vicarage Ledsham
    LS25 5LT Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    The Wing House
    The Old Vicarage Ledsham
    LS25 5LT Leeds
    West Yorkshire
    British108057370003
    BUTCHER, Adrian John
    Ruthen Cottage Marians Walk
    Berry Hill
    GL16 8QW Coleford
    Gloucestershire
    Amministratore
    Ruthen Cottage Marians Walk
    Berry Hill
    GL16 8QW Coleford
    Gloucestershire
    United KingdomBritishCompany Director107942510001
    HALL, Timothy Stevenson
    Astley Lane Trading
    Estate Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Four Seasons House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Astley Lane Trading
    Estate Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Four Seasons House
    West Yorkshire
    EnglandBritishAccountant125313360002
    LAWRIE, James Stuart
    Astley Lane Trading
    Estate Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Four Seasons House
    West Yorkshire
    Amministratore
    Astley Lane Trading
    Estate Swillington
    LS26 8XT Leeds
    Four Seasons House
    West Yorkshire
    Great BritainBritishDirector138754390001
    MCBRIDE, Maurice
    c/o Dundas & Wilson Cs Llp (Ref:Djc)
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Amministratore
    c/o Dundas & Wilson Cs Llp (Ref:Djc)
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    ScotlandBritishDirector84209480001
    SINGH, Harjinder Peter
    6 Mayfield View
    Wyke
    BD12 9PY Bradford
    West Yorkshire
    Amministratore
    6 Mayfield View
    Wyke
    BD12 9PY Bradford
    West Yorkshire
    BritishCompany Director108207210001
    THOMAS-KEEPING, Lindsay Charles
    The Wing House
    The Old Vicarage Ledsham
    LS25 5LT Leeds
    West Yorkshire
    Amministratore
    The Wing House
    The Old Vicarage Ledsham
    LS25 5LT Leeds
    West Yorkshire
    BritishManaging Director108057370003

    FOUR SEASONS ENERGY MANAGEMENT GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 04 dic 2009
    Consegnato il 12 dic 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any resent or future account of the company with the bank see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 17 giu 2008
    Consegnato il 24 giu 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee acting as security trustee for itself and the beneficiaries on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Unquoted Investments Limited
    Transazioni
    • 24 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 17 giu 2008
    Consegnato il 20 giu 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Omnibus guarantee and set- off agreement
    Creato il 17 giu 2008
    Consegnato il 20 giu 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 08 mag 2007
    Consegnato il 15 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 08 mag 2007
    Consegnato il 12 mag 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Unquoted Investments Limited (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 12 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0