PRACTICE PLUS GROUP H4H LIMITED
Panoramica
| Nome della società | PRACTICE PLUS GROUP H4H LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 06239911 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di PRACTICE PLUS GROUP H4H LIMITED?
- Attività di medicina generale (86210) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova PRACTICE PLUS GROUP H4H LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Hawker House 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Berkshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di PRACTICE PLUS GROUP H4H LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| CARE UK (H4H) LIMITED | 22 mag 2013 | 22 mag 2013 |
| HARMONI FORHEALTH LTD | 22 lug 2009 | 22 lug 2009 |
| FORHEALTH LIMITED | 08 mag 2007 | 08 mag 2007 |
Quali sono gli ultimi bilanci di PRACTICE PLUS GROUP H4H LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per PRACTICE PLUS GROUP H4H LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2021 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2020 | 21 pagine | AA | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Practice Plus Group Health and Rehabilitation Services Limited come persona con controllo significativo il 05 ott 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 062399110002 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Nomina di Mr Lee Stafford Gage come segretario in data 14 apr 2021 | 2 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jonathan David Calow come segretario in data 14 apr 2021 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Care Uk Health & Rehabilitation Services Limited come persona con controllo significativo il 01 ott 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Hawker House 5-6 Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW England a Hawker House 5-6 Napier Court Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW in data 05 ago 2020 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Care Uk Health & Rehabilitation Services Limited come persona con controllo significativo il 08 ott 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Jonathan David Calow il 08 ott 2019 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2019 | 28 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr David George Stickland come amministratore in data 25 nov 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew James Mackenzie Prosser come amministratore in data 25 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Robert Parish come amministratore in data 31 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Philip James Whitecross come amministratore in data 31 ott 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Connaught House 850 the Crescent Colchester Business Park Colchester Essex CO4 9QB a Hawker House 5-6 Napier Road Reading Berkshire RG1 8BW in data 06 nov 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2018 | 31 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 27 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di PRACTICE PLUS GROUP H4H LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAGE, Lee Stafford | Segretario | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | 282030060001 | |||||||
| EASTON, James William | Amministratore | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | United Kingdom | British | 118320980001 | |||||
| STICKLAND, David George | Amministratore | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | United Kingdom | British | 130704670001 | |||||
| CALOW, Jonathan David | Segretario | 5-6 Napier Court Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | British | 173893010001 | ||||||
| RIDLEY, David Anthony | Segretario | 6 Upper Golf Links Road BH18 8BU Broadstone Dorset | British | 71205180002 | ||||||
| WHITTICASE, James Edward, Dr | Segretario | Dell House 17 Water Tower Road BH18 8LL Broadstone Dorset | British | 121330970002 | ||||||
| BARKER, Bernadette Dolores | Amministratore | The Avenue BH13 6AB Poole 9 Lingfield Grange 9 Dorset | England | Irish | 139502300001 | |||||
| DAVIES, Jane Bethan, Dr | Amministratore | 244 Leigh Road BH21 2BZ Wmborne Dorset | British | 121282890001 | ||||||
| GORDON, Alan Nicholas Chesterfield | Amministratore | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | United Kingdom | British | 83904050001 | |||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Amministratore | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | United Kingdom | British | 33223550003 | |||||
| LAWRENCE-PARR, Carole Ann | Amministratore | The Green Cottage The Green Stratton DT2 9WE Dorchester Dorset | England | British | 120819820001 | |||||
| LLOYD, David, Dr | Amministratore | Castlebar Park Ealing W5 1DA London 31 United Kingdom | United Kingdom | British | 48955810002 | |||||
| PARISH, Michael Robert | Amministratore | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | England | British | 78828750003 | |||||
| PROSSER, Andrew James Mackenzie | Amministratore | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | England | British | 151240810001 | |||||
| ROBERTS, Gerard, Dr | Amministratore | 14 Eaton Road Branksome Park BH13 6DG Poole Dorset | United Kingdom | British | 58004220001 | |||||
| SCHUSTER BRUCE, Robert Maurice Charles, Dr | Amministratore | Revelstoke 24 Spencer Road Canford Cliffs BH13 7EU Poole Dorset | England | British | 61972700001 | |||||
| TURNER, Stephen Edward | Amministratore | 13 Bassett Dale Bassett SO16 7GS Southampton "Carrick" Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 139232340001 | |||||
| WHITECROSS, Philip James | Amministratore | 5-6 Napier Road RG1 8BW Reading Hawker House Berkshire England | England | British | 193730760001 | |||||
| WHITTICASE, James Edward, Dr | Amministratore | Dell House 17 Water Tower Road BH18 8LL Broadstone Dorset | United Kingdom | British | 121330970002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di PRACTICE PLUS GROUP H4H LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Practice Plus Group Health And Rehabilitation Services Limited | 06 apr 2016 | 5-6 Napier Road Napier Court RG1 8BW Reading Hawker House England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
PRACTICE PLUS GROUP H4H LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 26 set 2014 Consegnato il 01 ott 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione The company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge for intellectual property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(b)(vii) of the charge.. The company listed above charged by way of first legal mortgage all its real property (although no further details are specified in the charge for real property owned by this company). For further detail, see clause 3.1(a) of the charge. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 07 feb 2011 Consegnato il 23 feb 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill,uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0