OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED

OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06265141
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bupa Dental Care Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DUKE STREET CAPITAL OASIS HOLDINGS LIMITED31 mag 200731 mag 2007

    Quali sono gli ultimi bilanci di OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mag 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    29 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Stato del capitale al 12 dic 2019

    • Capitale: GBP 2.00
    6 pagineSH02

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 12 dic 2019

    • Capitale: GBP 151,285.32
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share prem/cap redempt res cancelled 12/12/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 12 dic 2019

    • Capitale: GBP 117,782,222.89
    4 pagineSH01

    Cessazione della carica di Ian David Wood come amministratore in data 19 nov 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Robin James Bryant come amministratore in data 19 nov 2019

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Steven John Preddy come amministratore in data 19 nov 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2018

    19 pagineAA

    legacy

    48 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Gabriela Pueyo Roberts come amministratore in data 01 feb 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Catherine Elizabeth Barton come amministratore in data 05 dic 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Dr Steven John Preddy come amministratore in data 14 set 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Edward Joseph Coyle come amministratore in data 14 set 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2017

    19 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUPA SECRETARIES LIMITED
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Angel Court
    EC2R 7HJ London
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3155937
    162768400001
    PUEYO ROBERTS, Gabriela
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    Amministratore
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    SpainSpanish254904830001
    WRIGHT, Jake Hockley
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    Amministratore
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    United KingdomBritish184341770001
    BRADSHAW, Paula Kirsten
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Segretario
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    179393760001
    BRADSHAW, Paula
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Segretario
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    156233190001
    CAMERON, Charles Donald Ewen
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Segretario
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    169813810001
    HOLDCROFT, Andrew Darren
    9 Samford Court
    Tattingstone
    IP9 2NQ Ipswich
    Suffolk
    Segretario
    9 Samford Court
    Tattingstone
    IP9 2NQ Ipswich
    Suffolk
    British83074650002
    MATHARU, Manmohan Singh
    46 Warren Lane
    Leicester Forest East
    LE3 3LW Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    46 Warren Lane
    Leicester Forest East
    LE3 3LW Leicester
    Leicestershire
    British49500020001
    OWEN, Jennifer Margaret
    Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    138
    Hertfordshire
    Segretario
    Clarence Road
    AL1 4NW St Albans
    138
    Hertfordshire
    English188565910001
    TAYLOR, Peter Lance
    Almack House
    28 King Street
    SW1Y 6XA London
    Segretario
    Almack House
    28 King Street
    SW1Y 6XA London
    British92125620001
    TINDALL, Zoe
    Portbury Lane
    Portbury
    BS20 7SN Bristol
    Higher Farm Barn
    North Somerset
    Segretario
    Portbury Lane
    Portbury
    BS20 7SN Bristol
    Higher Farm Barn
    North Somerset
    British138730340001
    QUAYSECO LTD
    Glass Wharf
    BS2 0ZX Bristol
    One
    United Kingdom
    Segretario
    Glass Wharf
    BS2 0ZX Bristol
    One
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02287256
    163574790001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ADAMS, Paul James
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Amministratore
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    EnglandBritish161490290001
    ASH, Justinian Joseph
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Amministratore
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    EnglandBritish188659180001
    BARTON, Catherine Elizabeth
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    Amministratore
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    EnglandBritish243693740001
    BELKIN, Jeffrey Philip
    10a Sherriff Road
    NW6 2AU West Hampstead
    London
    Amministratore
    10a Sherriff Road
    NW6 2AU West Hampstead
    London
    United KingdomBritish79906460001
    BRYANT, Robin James, Dr
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    Amministratore
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    United KingdomBritish169089950001
    CAMERON, Charles Donald Ewen
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Amministratore
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    EnglandBritish113187140001
    COLVIN, William
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Amministratore
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    United KingdomBritish51697890002
    COX, Grahame Philip
    Crooked Cottage
    Chapel Allerton
    BS26 2PH Axbridge
    Somerset
    Amministratore
    Crooked Cottage
    Chapel Allerton
    BS26 2PH Axbridge
    Somerset
    EnglandBritish54310790001
    COYLE, Edward Joseph, Dr
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    Amministratore
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    United KingdomBritish200405130002
    GONZALEZ, Jordi
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Amministratore
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    United KingdomBritish183345110001
    HARPER, John David
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Amministratore
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    United KingdomBritish193479730001
    HARPER, John
    30 Holmside Road
    SW12 8RJ London
    Amministratore
    30 Holmside Road
    SW12 8RJ London
    British109430090001
    HOFF, Lilimarlen
    Flat 7
    23 Queensgate Terrace
    SW7 5PR London
    Amministratore
    Flat 7
    23 Queensgate Terrace
    SW7 5PR London
    British121879120001
    HOLDCROFT, Andrew Darren
    9 Samford Court
    Tattingstone
    IP9 2NQ Ipswich
    Suffolk
    Amministratore
    9 Samford Court
    Tattingstone
    IP9 2NQ Ipswich
    Suffolk
    EnglandBritish83074650002
    JOHNSON, Allan
    2 Church Cottages
    OX20 1DZ Wootton
    Oxfordshire
    Amministratore
    2 Church Cottages
    OX20 1DZ Wootton
    Oxfordshire
    EnglandBritish159246050001
    LAMBERT, Stephen David
    High House 36 South Avenue
    NR7 0EZ Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    High House 36 South Avenue
    NR7 0EZ Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish99698180001
    LEATHERBARROW, David Jon
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    Amministratore
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    EnglandBritish135618280010
    LEATHERBARROW, David Jon
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Amministratore
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    EnglandBritish135618280002
    MATHARU, Manmohan Singh
    46 Warren Lane
    Leicester Forest East
    LE3 3LW Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    46 Warren Lane
    Leicester Forest East
    LE3 3LW Leicester
    Leicestershire
    EnglandBritish49500020001
    MULLORD, Kathleen
    11 St Stephens Walk
    SW7 4RP London
    Amministratore
    11 St Stephens Walk
    SW7 4RP London
    United KingdomSouth African118838430001
    PERRY, Julian Francis
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Amministratore
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    EnglandBritish84437900002
    PHILIPPS, Corinne
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    Amministratore
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road
    BS16 1GW Hambrook
    Building E
    Bristol
    United KingdomFrench,British109733120002

    Chi sono le persone con controllo significativo di OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Vantage Office Park
    Old Gloucester Road, Hambrook
    BS16 1GW Bristol
    Bupa Dental Care
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione08405885
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 25 lug 2014
    Consegnato il 31 lug 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale, London Branch as Security Agent
    Transazioni
    • 31 lug 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 10 feb 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security agreement
    Creato il 13 giu 2007
    Consegnato il 22 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 22 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0