OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED
Panoramica
| Nome della società | OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 06265141 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?
- Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Bupa Dental Care Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DUKE STREET CAPITAL OASIS HOLDINGS LIMITED | 31 mag 2007 | 31 mag 2007 |
Quali sono gli ultimi bilanci di OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 mag 2020 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 29 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale al 12 dic 2019
| 6 pagine | SH02 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 12 dic 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 12 dic 2019
| 4 pagine | SH01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Ian David Wood come amministratore in data 19 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Robin James Bryant come amministratore in data 19 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Steven John Preddy come amministratore in data 19 nov 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2018 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 48 pagine | PARENT_ACC | ||||||||||||||
legacy | 1 pagine | AGREEMENT2 | ||||||||||||||
legacy | 3 pagine | GUARANTEE2 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 mag 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Nomina di Gabriela Pueyo Roberts come amministratore in data 01 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Catherine Elizabeth Barton come amministratore in data 05 dic 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Dr Steven John Preddy come amministratore in data 14 set 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Edward Joseph Coyle come amministratore in data 14 set 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 mag 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||||||
Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2017 | 19 pagine | AA | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUPA SECRETARIES LIMITED | Segretario | Angel Court EC2R 7HJ London 1 United Kingdom |
| 162768400001 | ||||||||||
| PUEYO ROBERTS, Gabriela | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | Spain | Spanish | 254904830001 | |||||||||
| WRIGHT, Jake Hockley | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 184341770001 | |||||||||
| BRADSHAW, Paula Kirsten | Segretario | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | 179393760001 | |||||||||||
| BRADSHAW, Paula | Segretario | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | 156233190001 | |||||||||||
| CAMERON, Charles Donald Ewen | Segretario | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | 169813810001 | |||||||||||
| HOLDCROFT, Andrew Darren | Segretario | 9 Samford Court Tattingstone IP9 2NQ Ipswich Suffolk | British | 83074650002 | ||||||||||
| MATHARU, Manmohan Singh | Segretario | 46 Warren Lane Leicester Forest East LE3 3LW Leicester Leicestershire | British | 49500020001 | ||||||||||
| OWEN, Jennifer Margaret | Segretario | Clarence Road AL1 4NW St Albans 138 Hertfordshire | English | 188565910001 | ||||||||||
| TAYLOR, Peter Lance | Segretario | Almack House 28 King Street SW1Y 6XA London | British | 92125620001 | ||||||||||
| TINDALL, Zoe | Segretario | Portbury Lane Portbury BS20 7SN Bristol Higher Farm Barn North Somerset | British | 138730340001 | ||||||||||
| QUAYSECO LTD | Segretario | Glass Wharf BS2 0ZX Bristol One United Kingdom |
| 163574790001 | ||||||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||||||
| ADAMS, Paul James | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | England | British | 161490290001 | |||||||||
| ASH, Justinian Joseph | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | England | British | 188659180001 | |||||||||
| BARTON, Catherine Elizabeth | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | England | British | 243693740001 | |||||||||
| BELKIN, Jeffrey Philip | Amministratore | 10a Sherriff Road NW6 2AU West Hampstead London | United Kingdom | British | 79906460001 | |||||||||
| BRYANT, Robin James, Dr | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 169089950001 | |||||||||
| CAMERON, Charles Donald Ewen | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | England | British | 113187140001 | |||||||||
| COLVIN, William | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | United Kingdom | British | 51697890002 | |||||||||
| COX, Grahame Philip | Amministratore | Crooked Cottage Chapel Allerton BS26 2PH Axbridge Somerset | England | British | 54310790001 | |||||||||
| COYLE, Edward Joseph, Dr | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | United Kingdom | British | 200405130002 | |||||||||
| GONZALEZ, Jordi | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | United Kingdom | British | 183345110001 | |||||||||
| HARPER, John David | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | United Kingdom | British | 193479730001 | |||||||||
| HARPER, John | Amministratore | 30 Holmside Road SW12 8RJ London | British | 109430090001 | ||||||||||
| HOFF, Lilimarlen | Amministratore | Flat 7 23 Queensgate Terrace SW7 5PR London | British | 121879120001 | ||||||||||
| HOLDCROFT, Andrew Darren | Amministratore | 9 Samford Court Tattingstone IP9 2NQ Ipswich Suffolk | England | British | 83074650002 | |||||||||
| JOHNSON, Allan | Amministratore | 2 Church Cottages OX20 1DZ Wootton Oxfordshire | England | British | 159246050001 | |||||||||
| LAMBERT, Stephen David | Amministratore | High House 36 South Avenue NR7 0EZ Norwich Norfolk | United Kingdom | British | 99698180001 | |||||||||
| LEATHERBARROW, David Jon | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | England | British | 135618280010 | |||||||||
| LEATHERBARROW, David Jon | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | England | British | 135618280002 | |||||||||
| MATHARU, Manmohan Singh | Amministratore | 46 Warren Lane Leicester Forest East LE3 3LW Leicester Leicestershire | England | British | 49500020001 | |||||||||
| MULLORD, Kathleen | Amministratore | 11 St Stephens Walk SW7 4RP London | United Kingdom | South African | 118838430001 | |||||||||
| PERRY, Julian Francis | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | England | British | 84437900002 | |||||||||
| PHILIPPS, Corinne | Amministratore | Vantage Office Park Old Gloucester Road BS16 1GW Hambrook Building E Bristol | United Kingdom | French,British | 109733120002 |
Chi sono le persone con controllo significativo di OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oasis Healthcare Bidco Limited | 06 apr 2016 | Vantage Office Park Old Gloucester Road, Hambrook BS16 1GW Bristol Bupa Dental Care United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
OASIS HEALTHCARE INTERNATIONAL LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 25 lug 2014 Consegnato il 31 lug 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A security agreement | Creato il 13 giu 2007 Consegnato il 22 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0