STOFORD VENTURES LIMITED

STOFORD VENTURES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSTOFORD VENTURES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06277945
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di STOFORD VENTURES LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova STOFORD VENTURES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Lancaster House
    67 Newhall Street
    B3 1NQ Birmingham
    West Midlands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di STOFORD VENTURES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DUNWILCO (1476) LIMITED13 giu 200713 giu 2007

    Quali sono gli ultimi bilanci di STOFORD VENTURES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per STOFORD VENTURES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di David Andrew Brown come amministratore in data 13 lug 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Dominic Peter Stokes come amministratore in data 13 lug 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrew Brown come amministratore in data 13 lug 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 13 giu 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 giu 2016

    Stato del capitale al 22 giu 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Julie Craig il 15 giu 2016

    1 pagineCH03

    Nomina di Mr Matthew John Burgin come amministratore in data 15 giu 2016

    2 pagineAP01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Brown il 15 giu 2016

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Jonathan William Andrews come amministratore in data 15 giu 2016

    1 pagineTM01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2015

    5 pagineAA

    Stato del capitale al 17 lug 2015

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 13 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 giu 2015

    Stato del capitale al 16 giu 2015

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2014 al 31 mar 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 30 set 2013

    5 pagineAA

    legacy

    29 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Bilancio annuale redatto al 13 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 giu 2014

    Stato del capitale al 16 giu 2014

    • Capitale: GBP 1,000,000
    SH01

    Chi sono gli amministratori di STOFORD VENTURES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CRAIG, Julie
    Lancaster House
    67 Newhall Street
    B3 1NQ Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    Lancaster House
    67 Newhall Street
    B3 1NQ Birmingham
    West Midlands
    British178975020001
    BURGIN, Matthew John
    Lancaster House
    67 Newhall Street
    B3 1NQ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Lancaster House
    67 Newhall Street
    B3 1NQ Birmingham
    West Midlands
    EnglandEnglish209278580001
    CRAIG, Julie
    Lancaster House
    67 Newhall Street
    B3 1NQ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Lancaster House
    67 Newhall Street
    B3 1NQ Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish178975020001
    D.W. COMPANY SERVICES LIMITED
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Segretario
    4th Floor, Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    613080003
    ANDREWS, Jonathan William
    Lancaster House
    67 Newhall Street
    B3 1NQ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Lancaster House
    67 Newhall Street
    B3 1NQ Birmingham
    West Midlands
    EnglandBritish79190540003
    BELL, Simon Harold
    Ravelston Dykes
    EH4 3JE Edinburgh
    17
    Amministratore
    Ravelston Dykes
    EH4 3JE Edinburgh
    17
    British128941230001
    BROWN, David Andrew
    Lancaster House
    67 Newhall Street
    B3 1NQ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    Lancaster House
    67 Newhall Street
    B3 1NQ Birmingham
    West Midlands
    United KingdomBritish152209770004
    BURNETT, Neil Scott
    Hermitage Gardens
    EH10 6DL Edinburgh
    1
    Scotland
    United Kingdom
    Amministratore
    Hermitage Gardens
    EH10 6DL Edinburgh
    1
    Scotland
    United Kingdom
    ScotlandBritish93937250003
    CHUNG, Che Yep Colin
    Flat 4
    45 Hornsey Lane Gardens
    N6 5NY London
    Amministratore
    Flat 4
    45 Hornsey Lane Gardens
    N6 5NY London
    United KingdomBritish126468350001
    HEWITT, Alistair James Neil
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    Amministratore
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritish113081830001
    MACDONALD, Gary
    23 Hillview Drive
    EH12 8QP Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    23 Hillview Drive
    EH12 8QP Edinburgh
    Midlothian
    British127023890001
    STOKES, Dominic Peter
    Britannia Square
    WR1 3HP Worcester
    49
    England
    Amministratore
    Britannia Square
    WR1 3HP Worcester
    49
    England
    United KingdomBritish88206250003
    D.W. DIRECTOR 1 LIMITED
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    Amministratore
    4th Floor Saltire Court
    20 Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Lothian
    83454900001

    STOFORD VENTURES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental debenture
    Creato il 11 lug 2008
    Consegnato il 16 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the oligors to the finance parties to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Land at the junction of paycocke road and honywood road basildon t/no EX794811 together with all buildings and fixtures thereon, the proceeds of sale of all or any part thereof and the benefit of any covenants see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 16 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture
    Creato il 15 feb 2008
    Consegnato il 20 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at fairway business park, sunningdale road, leicester t/no LT398800 together with all buildings and fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 20 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture
    Creato il 01 feb 2008
    Consegnato il 08 feb 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that land at mansfield road, south yardley, birmingham t/no. WM650394 together with all buildings and fixtures thereon, the proceeds of sale thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental debenture
    Creato il 02 gen 2008
    Consegnato il 04 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at the junction of paycocke road and honywood road, basildon t/no EX648245 together with all buildings and fixtures. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 nov 2007
    Consegnato il 12 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 12 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0