ARTHOUSE HOLDING LIMITED

ARTHOUSE HOLDING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàARTHOUSE HOLDING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06304788
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ARTHOUSE HOLDING LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ARTHOUSE HOLDING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O ERNST & YOUNG LLP
    2 St. Peters Square
    M2 3EY Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ARTHOUSE HOLDING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INHOCO 3406 LIMITED06 lug 200706 lug 2007

    Quali sono gli ultimi bilanci di ARTHOUSE HOLDING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per ARTHOUSE HOLDING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    19 pagineAM23

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    18 pagineAM10

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA/AM02SOC

    10 pagineAM02

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    5 pagineAM06

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    52 pagineAM03

    Indirizzo della sede legale modificato da St James Church Bacup Road Waterfoot Rossendale Lancashire BB4 7JU a 2 st. Peters Square Manchester M2 3EY in data 04 gen 2023

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Iscrizione dell'ipoteca 063047880009, creata il 14 nov 2022

    49 pagineMR01

    Cessazione della carica di Daniel Howarth come amministratore in data 16 set 2022

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Paul James Mullan come amministratore in data 15 ott 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 07 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2020

    19 pagineAA

    Bilancio redatto al 28 dic 2019

    21 pagineAA

    Nomina di Rebecca Louise Shellard come amministratore in data 20 lug 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 063047880008, creata il 14 lug 2020

    46 pagineMR01

    Cessazione della carica di Anita Rae Kenyon come amministratore in data 20 mag 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Stephanie Avril Carroll come amministratore in data 31 ott 2019

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    18 pagineAA

    Nomina di Mr Daniel Howarth come amministratore in data 18 set 2019

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Waqas Ahmed Butt come amministratore in data 18 set 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Paul James Mullan come amministratore in data 02 set 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di ARTHOUSE HOLDING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BATE, Clare Louise
    St. Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    Amministratore
    St. Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    United KingdomBritishDirector253489570001
    SHELLARD, Rebecca Louise
    St. Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    Amministratore
    St. Peters Square
    M2 3EY Manchester
    2
    EnglandBritishFinance Director272229360001
    LEWIS, Rupert Peter Awdas
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    Segretario
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    192350250001
    SCOTT, Steven
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    Segretario
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    235223490001
    TODD, Gillian Tracy
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    Segretario
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    BritishAccountant93887120001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BANCROFT, Robin Spencer
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director126034240001
    BURROWS, Rachel Deborah
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    EnglandBritishDirector148818620001
    BUTT, Waqas Ahmed
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    EnglandBritishDirector312659980001
    CARROLL, Stephanie Avril
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    United KingdomBritishCreative Director215123020001
    CLARKE, Caryn Elizabeth
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    EnglandBritishSales And Marketing Director241495860001
    EASTHAM, Natalie Jane
    Bryher
    HP4 2QF Berkhamsted
    The Common
    Amministratore
    Bryher
    HP4 2QF Berkhamsted
    The Common
    EnglandBritishInvestment Banker133819670001
    HOWARTH, Daniel
    Bacup Road
    Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    St James Church
    United Kingdom
    Amministratore
    Bacup Road
    Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    St James Church
    United Kingdom
    EnglandBritishOperations Director253683730001
    JOSEPH, Steven Falcon
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector130124020002
    KENYON, Anita Rae
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director126034170001
    LEWIS, Rupert Peter Awdas
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    United KingdomBritishFinance Director131940350002
    MULLAN, Paul James
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    EnglandBritishManaging Director262346860001
    TODD, Gillian Tracy
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    United KingdomBritishAccountant93887120001
    WHITELAW, Andrew
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    Amministratore
    St James Church
    Bacup Road Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    Lancashire
    United KingdomBritishCompany Director126034330001
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Amministratore delegato nominato
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ARTHOUSE HOLDING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Arthouse Group Limited
    Bacup Road
    Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    St James Church
    Lancashire
    England
    06 apr 2016
    Bacup Road
    Waterfoot
    BB4 7JU Rossendale
    St James Church
    Lancashire
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUk Law
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione06304737
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ARTHOUSE HOLDING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 14 nov 2022
    Consegnato il 21 nov 2022
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Both Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 21 nov 2022Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 14 lug 2020
    Consegnato il 17 lug 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Northedge Capital LLP
    Transazioni
    • 17 lug 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 09 feb 2016
    Consegnato il 17 feb 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Clydesdale Bank and Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 17 feb 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 17 ott 2015
    Consegnato il 21 ott 2015
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Northedge Capital LLP
    Transazioni
    • 21 ott 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 16 apr 2015
    Consegnato il 21 apr 2015
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 28 dic 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Key-man life policy deed of assignment
    Creato il 27 feb 2009
    Consegnato il 14 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the assignee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Keyman policies - insurer: aegon/scottish equitable life assured: anita kenyon date of policy: 1/2/08 p/no. L0195033403 life: £1,000.000.00 critical illness: £500,000.00, insurer: aegon/scottish equitable life assured: robin bancroft date of policy: 1/2/08 p/no. L0192113403 life: £1,000.000.00 critical illness: £500,000.00, insurer: aegon/scottish equitable life assured: gillian todd date of policy: 21/12/07 p/no. L0195323403 life: £1,000.000.00 critical illness: £500,000.00, insurer: aegon/scottish equitable life assured: andrew whitelaw date of policy: 21/12/07 p/no. L0191813403 life: £1,000.000.00 critical illness: £500,000.00 all security created by the assignor under the key-man assignment is: a continuing security for the payment and discharge, granted with full title guarantee see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Total Capital Partners Fund I LP Acting by Its General Partner Total Capital Partners General Partner LP Acting by Its General Partner Total Capital Partners Gp Limited
    Transazioni
    • 14 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 mar 2009
    • 09 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 27 feb 2009
    Consegnato il 14 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Total Capital Partners Fund I LP Acting by Its General Partner Total Capital Partners General Partner LP Acting by Its General Partner Total Capital Partners Gp Limited
    Transazioni
    • 14 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 mar 2009
    • 25 mar 2009
    • 09 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Key-man life policy deed of assignment
    Creato il 26 giu 2008
    Consegnato il 09 lug 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The key-man policies; insurer: aegon/scottish equitable, life assured: anita kenyon, date of policy: 01/02/2008, p/no. L0195033403 amount of cover: life - £1,000,000.00 critical illness - £500,000.00; insurer: aegon/scottish equitable, life assured: robin bancroft, date of policy: 01/02/2008, p/no. L0192113403 amount of cover: life - £1,000,000.00 critical illness - £500,000.00 & insurer: aegon/scottish equitable, life assured: gillian todd, date of policy: 21/12/2007, p/no. L0195323403 amount of cover: life - £1,000,000.00 critical illness - £500,000.00 for details of further policies charged please refer to form 395 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Glitnir H.F.
    Transazioni
    • 09 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 06 nov 2007
    Consegnato il 15 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Glitnir Banki H.F
    Transazioni
    • 15 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mar 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ARTHOUSE HOLDING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 dic 2022Inizio dell'amministrazione
    19 dic 2023Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Timothy Vance
    12 Wellington Place
    LS1 4AP Leeds
    Praticante
    12 Wellington Place
    LS1 4AP Leeds
    Samuel James Woodward
    2 St Peters Square
    M2 3DF Manchester
    Praticante
    2 St Peters Square
    M2 3DF Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0