APBE NO.2 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | APBE NO.2 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 06328935 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di APBE NO.2 LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova APBE NO.2 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Finsgate 5-7 Cranwood Street EC1V 9EE London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di APBE NO.2 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BUSINESS ENVIRONMENT ALFRED PLACE LIMITED | 11 set 2007 | 11 set 2007 |
| BUSINESS ENVIRONMENT ALFRED PLACE NO.1 LIMITED | 31 lug 2007 | 31 lug 2007 |
Quali sono gli ultimi bilanci di APBE NO.2 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per APBE NO.2 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 giu 2020 | 5 pagine | AA | ||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 lug 2020 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2019 | 7 pagine | AA | ||
Modifica dei dettagli di Apbe No. 1 Limited come persona con controllo significativo il 22 ago 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 10 Queen Street Place London EC4R 1AG United Kingdom a Finsgate 5-7 Cranwood Street London EC1V 9EE in data 15 ago 2019 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 lug 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di Haysmacintyre Company Secretaries Limited come segretario in data 21 mag 2019 | 2 pagine | TM02 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2018 | 8 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 18 lug 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2017 | 11 pagine | AA | ||
Modifica dei dettagli di Apbe No. 1 Limited come persona con controllo significativo il 18 dic 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dettagli del segretario cambiati per Haysmacintyre Company Secretaries Limited il 18 dic 2017 | 1 pagine | CH04 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 26 Red Lion Square London WC1R 4AG United Kingdom a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG in data 18 dic 2017 | 1 pagine | AD01 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 150 Minories London EC3N 1LS a Central Point 45 Beech Street London EC2Y 8AD | 1 pagine | AD02 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Melvyn Stephen Gilbert il 07 ago 2017 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2016 | 14 pagine | AA | ||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||
Nomina di Haysmacintyre Company Secretaries Limited come segretario in data 16 ago 2016 | 2 pagine | AP04 | ||
Cessazione della carica di Simon Michael Rusk come segretario in data 16 ago 2016 | 1 pagine | TM02 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 31 lug 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||
Chi sono gli amministratori di APBE NO.2 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GILBERT, Melvyn Stephen, Mr | Amministratore | 45 Beech Street EC2Y 8AD London Central Point United Kingdom | United Kingdom | British | 6395630003 | |||||||||
| RUSK, Simon Michael, Mr. | Segretario | Minories EC3N 1LS London 150 United Kingdom | British | 123853770003 | ||||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom |
| 89121630002 | ||||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Fairfax House 15 Fulwood Place WC1V 6AY London | 89121630002 | |||||||||||
| EMDEN, Andrew Marc | Amministratore | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 126685040002 | |||||||||
| GANDY, Nicolas Sean | Amministratore | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 135709440001 | |||||||||
| GERSHINSON, Colin Anthony | Amministratore | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 21890030001 | |||||||||
| HEFFERMAN, Graham Anthony | Amministratore | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | England | British | 77838960004 | |||||||||
| HODGES, Edwin Charles | Amministratore | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 83077420001 | |||||||||
| JENKINS, Jayson | Amministratore | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 126305070001 | |||||||||
| KLUG, Bernard Philip | Amministratore | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | England | British | 15387060004 | |||||||||
| MERCER, Graham Paul | Amministratore | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | England | British | 108922930002 | |||||||||
| RUSK, Simon Michael, Mr. | Amministratore | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 123853770003 | |||||||||
| SAUL, David Gary | Amministratore | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 57597480002 | |||||||||
| STEWART, Andrew Lawrence | Amministratore | Groveland Court Bow Lane EC4M 9EH London 12 | United Kingdom | British | 23329410002 | |||||||||
| HAYSMACINTYRE COMPANY DIRECTORS LIMITED | Amministratore | Fairfax House 15 Fulwood Place WC1V 6AY London | 96074930001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di APBE NO.2 LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apbe No. 1 Limited | 06 apr 2016 | 5-7 Cranwood Street EC1V 9EE London Finsgate England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
APBE NO.2 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 06 ott 2008 Consegnato il 10 ott 2008 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Its credit balances see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 13 mar 2008 Consegnato il 15 mar 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sum or sums for the time being standing to the credit of a bank account specified in the agreement with the bank in the name of the company held at the banks city office branch. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An omnibus guarantee and set-off agreement | Creato il 10 dic 2007 Consegnato il 12 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Any sums or sums standing to the credit if any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 24 ago 2007 Consegnato il 29 ago 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 33 and 34 alfred place london together with all fixtures and fittings and chattels floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 10 ago 2007 Consegnato il 11 ago 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 31-32 alfred place, london together with all fixtures and fittings and chattelsthereon and the goodwill of any trades or business carried on by the company at. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 10 ago 2007 Consegnato il 11 ago 2007 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0