MALTHURST PROPERTIES LIMITED

MALTHURST PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMALTHURST PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06360537
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MALTHURST PROPERTIES LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MALTHURST PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Gladstone Place
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Hertfordshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MALTHURST PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per MALTHURST PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 set 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 ago 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Modifica dei dettagli di Lupo Limited come persona con controllo significativo il 16 lug 2019

    2 paginePSC05

    Nomina di Thomas Mckenzie Biggart come amministratore in data 11 mar 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Pinsent Masons Secretarial Limited come segretario in data 07 mar 2019

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di David Hathaway come segretario in data 07 mar 2019

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Graham Paul Timbers come amministratore in data 12 feb 2019

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Simon Paul Lane come amministratore in data 19 dic 2018

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr William Bahlsen Bannister come amministratore in data 19 dic 2018

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da Vincent House, 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH a Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU in data 20 dic 2018

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Steven John Back come amministratore in data 15 ott 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Graham Paul Timbers come amministratore in data 12 ott 2018

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2018 al 31 dic 2018

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 set 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Karen Juanita Dickens come amministratore in data 22 giu 2018

    1 pagineTM01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 01 ott 2017

    7 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2017 al 30 set 2017

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 set 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di MALTHURST PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Segretario
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02318923
    76579530001
    BANNISTER, William Bahlsen
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish252731900001
    BIGGART, Thomas Mckenzie
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    ScotlandBritish215843640001
    LANE, Simon Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish252862090001
    HATHAWAY, David
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Segretario
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    British117227730001
    IQBAL, Damian Shameem
    Vincent House, 4 Grove Lane
    Epping
    CM16 4LH Essex
    Segretario
    Vincent House, 4 Grove Lane
    Epping
    CM16 4LH Essex
    British126363060001
    D & D SECRETARIAL LTD
    Linden House
    Court Lodge Farm, Warren Road
    BR6 6ER Chelsfield
    Kent
    Segretario
    Linden House
    Court Lodge Farm, Warren Road
    BR6 6ER Chelsfield
    Kent
    114884700001
    BACK, Steven John
    Vincent House, 4 Grove Lane
    Epping
    CM16 4LH Essex
    Amministratore
    Vincent House, 4 Grove Lane
    Epping
    CM16 4LH Essex
    United KingdomBritish205661380001
    DICKENS, Karen Juanita, Dr
    Vincent House, 4 Grove Lane
    Epping
    CM16 4LH Essex
    Amministratore
    Vincent House, 4 Grove Lane
    Epping
    CM16 4LH Essex
    United KingdomBritish124061360001
    DWYER, Daniel James
    Clovers End
    Patcham
    BN1 8PJ Brighton
    2
    East Sussex
    Amministratore
    Clovers End
    Patcham
    BN1 8PJ Brighton
    2
    East Sussex
    United KingdomBritish86094440001
    LYNN, John Charles
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    Amministratore
    4 Grove Lane
    CM16 4LH Epping
    Vincent House
    Essex
    United KingdomBritish29838790004
    PEACOCK, Graham Frederick
    Vincent House, 4 Grove Lane
    Epping
    CM16 4LH Essex
    Amministratore
    Vincent House, 4 Grove Lane
    Epping
    CM16 4LH Essex
    United KingdomBritish5133310002
    SCOTT, Richard Antony Cargill
    Vincent House, 4 Grove Lane
    Epping
    CM16 4LH Essex
    Amministratore
    Vincent House, 4 Grove Lane
    Epping
    CM16 4LH Essex
    EnglandBritish107002130001
    TIMBERS, Graham Paul
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St. Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish127888240001
    TOBBELL, Susan Margaret
    Vincent House, 4 Grove Lane
    Epping
    CM16 4LH Essex
    Amministratore
    Vincent House, 4 Grove Lane
    Epping
    CM16 4LH Essex
    United KingdomBritish17957620003

    Chi sono le persone con controllo significativo di MALTHURST PROPERTIES LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Lupo Limited
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    36-38 Upper Marlborough Road
    AL1 3UU St Albans
    Gladstone Place
    Hertfordshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione05166720
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    MALTHURST PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Supplemental legal charge
    Creato il 03 dic 2010
    Consegnato il 14 dic 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    South norwood service station corner south norwood hill and holmesdale road london t/no P33581, station road garage station road stow-on-the-wold cheltenham t/no GR260783; all buildings, fixtures, fixed plant and machinery, all easements, rights, agreements, all rents, proceeds of sale. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited
    Transazioni
    • 14 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental legal charge
    Creato il 24 set 2009
    Consegnato il 01 ott 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under or in connection with any finance document
    Brevi particolari
    All the company's present and future right title and interest in and to the acquired property and the charged assets subject to the charges see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited
    Transazioni
    • 01 ott 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rents
    Creato il 28 mag 2009
    Consegnato il 18 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Lease between malthurst fuels limited and bp oil UK limited dated 1 and 6 april both months 2009 and registered in the books of council and session on 15 april 2009.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (the Security Agent)
    Transazioni
    • 18 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security
    Creato il 21 mag 2009
    Consegnato il 10 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due
    Brevi particolari
    All the whole the subjects lying on the north side craiglinn park road known as the petrol filling station at black o' hill roundabout cumbernauld glasgow t/no:DMB56956.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I) Limited
    Transazioni
    • 10 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 16/11/07 and
    Creato il 24 ott 2007
    Consegnato il 06 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    South west of queen's drive kilmarnock t/no AYR16084. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (the Security Agent)
    Transazioni
    • 06 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 23/11/07 and
    Creato il 24 ott 2007
    Consegnato il 06 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Millfield service station main street polmont falkirk t/no STG46730. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (the Security Agent)
    Transazioni
    • 06 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 23/11/07 and
    Creato il 24 ott 2007
    Consegnato il 06 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Crossroads filling station 90 dean road bo'ness t/no WLN39354. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (the Security Agent)
    Transazioni
    • 06 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 19/11/07 and
    Creato il 24 ott 2007
    Consegnato il 06 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    North side of hamilton road carmyle t/no LAN42692. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (the Security Agent)
    Transazioni
    • 06 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 16/11/07 and
    Creato il 24 ott 2007
    Consegnato il 06 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Newbridge service station cliftonhall road newbridge t/no MID82379. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (the Security Agent)
    Transazioni
    • 06 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 14/11/2007 and
    Creato il 24 ott 2007
    Consegnato il 04 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Mountfleurie service station windygates road leven t/no FFE75324.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited
    Transazioni
    • 04 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security presented for registration in scotland on 15 november 2007 and
    Creato il 24 ott 2007
    Consegnato il 05 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    565 north anderson drive aberdeen t/n ABN45487.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (Security Agent)
    Transazioni
    • 05 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating security document
    Creato il 24 ott 2007
    Consegnato il 09 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (the Security Agent)
    Transazioni
    • 09 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 dic 2010Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 06 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share mortgage
    Creato il 24 ott 2007
    Consegnato il 09 nov 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all present and future shares and dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (the Security Agent)
    Transazioni
    • 09 nov 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mar 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0