MALTHURST PROPERTIES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | MALTHURST PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 06360537 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MALTHURST PROPERTIES LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova MALTHURST PROPERTIES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Hertfordshire England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di MALTHURST PROPERTIES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2018 |
Quali sono le ultime deposizioni per MALTHURST PROPERTIES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 set 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||
Stato del capitale al 30 ago 2019
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Modifica dei dettagli di Lupo Limited come persona con controllo significativo il 16 lug 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Nomina di Thomas Mckenzie Biggart come amministratore in data 11 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Pinsent Masons Secretarial Limited come segretario in data 07 mar 2019 | 2 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Hathaway come segretario in data 07 mar 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Graham Paul Timbers come amministratore in data 12 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Simon Paul Lane come amministratore in data 19 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr William Bahlsen Bannister come amministratore in data 19 dic 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Vincent House, 4 Grove Lane Epping Essex CM16 4LH a Gladstone Place 36-38 Upper Marlborough Road St. Albans Hertfordshire AL1 3UU in data 20 dic 2018 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven John Back come amministratore in data 15 ott 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Graham Paul Timbers come amministratore in data 12 ott 2018 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2018 al 31 dic 2018 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 set 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Karen Juanita Dickens come amministratore in data 22 giu 2018 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 01 ott 2017 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2017 al 30 set 2017 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 04 set 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di MALTHURST PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED | Segretario | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England |
| 76579530001 | ||||||||||
| BANNISTER, William Bahlsen | Amministratore | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | United Kingdom | British | 252731900001 | |||||||||
| BIGGART, Thomas Mckenzie | Amministratore | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | Scotland | British | 215843640001 | |||||||||
| LANE, Simon Paul | Amministratore | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | England | British | 252862090001 | |||||||||
| HATHAWAY, David | Segretario | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | British | 117227730001 | ||||||||||
| IQBAL, Damian Shameem | Segretario | Vincent House, 4 Grove Lane Epping CM16 4LH Essex | British | 126363060001 | ||||||||||
| D & D SECRETARIAL LTD | Segretario | Linden House Court Lodge Farm, Warren Road BR6 6ER Chelsfield Kent | 114884700001 | |||||||||||
| BACK, Steven John | Amministratore | Vincent House, 4 Grove Lane Epping CM16 4LH Essex | United Kingdom | British | 205661380001 | |||||||||
| DICKENS, Karen Juanita, Dr | Amministratore | Vincent House, 4 Grove Lane Epping CM16 4LH Essex | United Kingdom | British | 124061360001 | |||||||||
| DWYER, Daniel James | Amministratore | Clovers End Patcham BN1 8PJ Brighton 2 East Sussex | United Kingdom | British | 86094440001 | |||||||||
| LYNN, John Charles | Amministratore | 4 Grove Lane CM16 4LH Epping Vincent House Essex | United Kingdom | British | 29838790004 | |||||||||
| PEACOCK, Graham Frederick | Amministratore | Vincent House, 4 Grove Lane Epping CM16 4LH Essex | United Kingdom | British | 5133310002 | |||||||||
| SCOTT, Richard Antony Cargill | Amministratore | Vincent House, 4 Grove Lane Epping CM16 4LH Essex | England | British | 107002130001 | |||||||||
| TIMBERS, Graham Paul | Amministratore | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St. Albans Gladstone Place Hertfordshire England | England | British | 127888240001 | |||||||||
| TOBBELL, Susan Margaret | Amministratore | Vincent House, 4 Grove Lane Epping CM16 4LH Essex | United Kingdom | British | 17957620003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di MALTHURST PROPERTIES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupo Limited | 06 apr 2016 | 36-38 Upper Marlborough Road AL1 3UU St Albans Gladstone Place Hertfordshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
MALTHURST PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental legal charge | Creato il 03 dic 2010 Consegnato il 14 dic 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari South norwood service station corner south norwood hill and holmesdale road london t/no P33581, station road garage station road stow-on-the-wold cheltenham t/no GR260783; all buildings, fixtures, fixed plant and machinery, all easements, rights, agreements, all rents, proceeds of sale. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Supplemental legal charge | Creato il 24 set 2009 Consegnato il 01 ott 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee under or in connection with any finance document | |
Brevi particolari All the company's present and future right title and interest in and to the acquired property and the charged assets subject to the charges see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Assignation of rents | Creato il 28 mag 2009 Consegnato il 18 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Lease between malthurst fuels limited and bp oil UK limited dated 1 and 6 april both months 2009 and registered in the books of council and session on 15 april 2009. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 21 mag 2009 Consegnato il 10 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due | |
Brevi particolari All the whole the subjects lying on the north side craiglinn park road known as the petrol filling station at black o' hill roundabout cumbernauld glasgow t/no:DMB56956. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 16/11/07 and | Creato il 24 ott 2007 Consegnato il 06 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari South west of queen's drive kilmarnock t/no AYR16084. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 23/11/07 and | Creato il 24 ott 2007 Consegnato il 06 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Millfield service station main street polmont falkirk t/no STG46730. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 23/11/07 and | Creato il 24 ott 2007 Consegnato il 06 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Crossroads filling station 90 dean road bo'ness t/no WLN39354. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 19/11/07 and | Creato il 24 ott 2007 Consegnato il 06 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari North side of hamilton road carmyle t/no LAN42692. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security which was presented for registration in scotland on 16/11/07 and | Creato il 24 ott 2007 Consegnato il 06 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Newbridge service station cliftonhall road newbridge t/no MID82379. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A standard security which was presented for registration in scotland on the 14/11/2007 and | Creato il 24 ott 2007 Consegnato il 04 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Mountfleurie service station windygates road leven t/no FFE75324. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security presented for registration in scotland on 15 november 2007 and | Creato il 24 ott 2007 Consegnato il 05 dic 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company or any other obligor to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari 565 north anderson drive aberdeen t/n ABN45487. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Fixed and floating security document | Creato il 24 ott 2007 Consegnato il 09 nov 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Share mortgage | Creato il 24 ott 2007 Consegnato il 09 nov 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage all present and future shares and dividends. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0