WHITEHOUSE ESTATES LIMITED

WHITEHOUSE ESTATES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWHITEHOUSE ESTATES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06403814
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WHITEHOUSE ESTATES LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova WHITEHOUSE ESTATES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Aprirose House
    48a High Street
    HA8 7EQ Edgware
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di WHITEHOUSE ESTATES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WHITEHOUSE ESTATES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per WHITEHOUSE ESTATES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Cessazione della carica di James Edmund Russell come amministratore in data 13 apr 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di First Names Secretaries (Isle of Man) Limited come segretario in data 13 apr 2016

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Mark Jonathan Lewin come amministratore in data 13 apr 2016

    1 pagineTM01

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 dic 2015

    Stato del capitale al 22 dic 2015

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2014

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 ott 2014

    Stato del capitale al 20 ott 2014

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2013

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 ott 2013

    Stato del capitale al 21 ott 2013

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Bilancio redatto al 05 lug 2012

    12 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Ifg International (Secretaries) Limited il 01 feb 2013

    3 pagineCH04

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 apr 2012 al 30 giu 2012

    3 pagineAA01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Apricot House High Street, 48a Edgware Middlesex HA8 7EQ* in data 05 nov 2012

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 19 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2013 al 05 apr 2013

    3 pagineAA01

    Nomina di James Edmund Russell come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Mark Jonathan Lewin come amministratore

    3 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Ground Floor 30 City Road London EC1Y 2AB* in data 12 ott 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di Ifg International (Secretaries) Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Cessazione della carica di Michael Keidan come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Andris Jansons come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Pamela Jansons come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Pears come amministratore

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di WHITEHOUSE ESTATES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KEIDAN, Michael David Alan
    15 Crooked Usage
    Finchley
    N3 3HD London
    Segretario
    15 Crooked Usage
    Finchley
    N3 3HD London
    Other1447490001
    FIRST NAMES SECRETARIES (ISLE OF MAN) LIMITED
    Castle Hill
    Victoria Road
    IM2 4RB Douglas
    International House
    Isle Of Man
    Segretario
    Castle Hill
    Victoria Road
    IM2 4RB Douglas
    International House
    Isle Of Man
    Forma giuridicaPRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
    Tipo di documento di identificazioneExtra-SEE
    Autorità legaleISLE OF MAN COMPANIES ACT 1931-2004
    Numero di registrazione28391C
    203287500001
    QA REGISTRARS LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    Segretario
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    118891220001
    JANSONS, Andris
    Beacon Hill
    HP10 8NH Penn
    Lavender Cottage
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beacon Hill
    HP10 8NH Penn
    Lavender Cottage
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director41741070002
    JANSONS, Pamela Jane
    Beacon Hill
    HP10 8NH Penn
    Lavender Cottage
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Beacon Hill
    HP10 8NH Penn
    Lavender Cottage
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director89459990004
    LEWIN, Mark Jonathan
    Agneash
    IM4 7NP Lonan
    Ballacowle Bungalow
    Isle Of Man
    Amministratore
    Agneash
    IM4 7NP Lonan
    Ballacowle Bungalow
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishTrust Practitioner150917780001
    PEARS, David Alan
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Amministratore
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    United KingdomBritishCompany Director65200910001
    PEARS, Mark Andrew
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Amministratore
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    United KingdomBritishCompany Director1447500008
    PEARS, Trevor Steven, Sir
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    Amministratore
    2 Old Brewery Mews
    Hampstead
    NW3 1PZ London
    United KingdomBritishCompany Director40036010005
    RUSSELL, James Edmund
    Castlemona Avenue
    IM2 4EA Douglas
    6 Villa Court
    Isle Of Man
    Amministratore
    Castlemona Avenue
    IM2 4EA Douglas
    6 Villa Court
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishChartered Secretary150562410002
    QA NOMINEES LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    Amministratore
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    118891210001
    WPG REGISTRARS LIMITED
    Ground Floor
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    Amministratore
    Ground Floor
    30 City Road
    EC1Y 2AB London
    106986280001

    WHITEHOUSE ESTATES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security assignment
    Creato il 08 lug 2011
    Consegnato il 15 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assigned documents being- the pre-let agreement and all collateral instruments arising therefrom see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security assignment
    Creato il 08 lug 2011
    Consegnato il 15 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assigned property being the building contract, the performance bond and all collateral instruments arising therefrom see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of legal charge
    Creato il 08 lug 2011
    Consegnato il 15 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property k/a plant area, lavington house, lavington street, southwark, london t/no TGL339967 all fixtures & fittings & all fixed plant & machinery (not being chattels within the meaning of the bills of sales acts). A floating charge over all unfixed plant & machinery & other chattels & equipment, & assigns the goodwill of the business carried on at or from the property & the benefit of the licence or certificate. The right to recover & receive any compensation payable in respect of the licence or the certificate.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Deed of legal charge
    Creato il 08 lug 2011
    Consegnato il 15 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H property k/a part of lavington house, lavington street, southwark, london t/no TGL319641 all fixtures & fittings & all fixed plant & machinery (not being chattels within the meaning of the bills of sales acts). A floating charge over all unfixed plant & machinery & other chattels & equipment, & assigns the goodwill of the business carried on at or from the property & the benefit of the licence or certificate. The right to recover & receive any compensation payable in respect of the licence or the certificate.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 08 lug 2011
    Consegnato il 15 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transazioni
    • 15 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0