WHITEHOUSE ESTATES LIMITED
Panoramica
Nome della società | WHITEHOUSE ESTATES LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 06403814 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di WHITEHOUSE ESTATES LIMITED?
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
Dove si trova WHITEHOUSE ESTATES LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Aprirose House 48a High Street HA8 7EQ Edgware Middlesex |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di WHITEHOUSE ESTATES LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 30 giu 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WHITEHOUSE ESTATES LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per WHITEHOUSE ESTATES LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Cessazione della carica di James Edmund Russell come amministratore in data 13 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di First Names Secretaries (Isle of Man) Limited come segretario in data 13 apr 2016 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Mark Jonathan Lewin come amministratore in data 13 apr 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2014 | 10 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2013 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 05 lug 2012 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ifg International (Secretaries) Limited il 01 feb 2013 | 3 pagine | CH04 | ||||||||||
Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 apr 2012 al 30 giu 2012 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Apricot House High Street, 48a Edgware Middlesex HA8 7EQ* in data 05 nov 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 30 apr 2013 al 05 apr 2013 | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Nomina di James Edmund Russell come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mark Jonathan Lewin come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Ground Floor 30 City Road London EC1Y 2AB* in data 12 ott 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Ifg International (Secretaries) Limited come segretario | 3 pagine | AP04 | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Keidan come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andris Jansons come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Pamela Jansons come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Pears come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di WHITEHOUSE ESTATES LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEIDAN, Michael David Alan | Segretario | 15 Crooked Usage Finchley N3 3HD London | Other | 1447490001 | ||||||||||||||
FIRST NAMES SECRETARIES (ISLE OF MAN) LIMITED | Segretario | Castle Hill Victoria Road IM2 4RB Douglas International House Isle Of Man |
| 203287500001 | ||||||||||||||
QA REGISTRARS LIMITED | Segretario | The Studio St Nicholas Close WD6 3EW Elstree Hertfordshire | 118891220001 | |||||||||||||||
JANSONS, Andris | Amministratore | Beacon Hill HP10 8NH Penn Lavender Cottage Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | Company Director | 41741070002 | ||||||||||||
JANSONS, Pamela Jane | Amministratore | Beacon Hill HP10 8NH Penn Lavender Cottage Buckinghamshire United Kingdom | England | British | Company Director | 89459990004 | ||||||||||||
LEWIN, Mark Jonathan | Amministratore | Agneash IM4 7NP Lonan Ballacowle Bungalow Isle Of Man | Isle Of Man | British | Trust Practitioner | 150917780001 | ||||||||||||
PEARS, David Alan | Amministratore | 2 Old Brewery Mews Hampstead NW3 1PZ London | United Kingdom | British | Company Director | 65200910001 | ||||||||||||
PEARS, Mark Andrew | Amministratore | 2 Old Brewery Mews Hampstead NW3 1PZ London | United Kingdom | British | Company Director | 1447500008 | ||||||||||||
PEARS, Trevor Steven, Sir | Amministratore | 2 Old Brewery Mews Hampstead NW3 1PZ London | United Kingdom | British | Company Director | 40036010005 | ||||||||||||
RUSSELL, James Edmund | Amministratore | Castlemona Avenue IM2 4EA Douglas 6 Villa Court Isle Of Man | Isle Of Man | British | Chartered Secretary | 150562410002 | ||||||||||||
QA NOMINEES LIMITED | Amministratore | The Studio St Nicholas Close WD6 3EW Elstree Hertfordshire | 118891210001 | |||||||||||||||
WPG REGISTRARS LIMITED | Amministratore | Ground Floor 30 City Road EC1Y 2AB London | 106986280001 |
WHITEHOUSE ESTATES LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Security assignment | Creato il 08 lug 2011 Consegnato il 15 lug 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The assigned documents being- the pre-let agreement and all collateral instruments arising therefrom see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Security assignment | Creato il 08 lug 2011 Consegnato il 15 lug 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The assigned property being the building contract, the performance bond and all collateral instruments arising therefrom see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of legal charge | Creato il 08 lug 2011 Consegnato il 15 lug 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari L/H property k/a plant area, lavington house, lavington street, southwark, london t/no TGL339967 all fixtures & fittings & all fixed plant & machinery (not being chattels within the meaning of the bills of sales acts). A floating charge over all unfixed plant & machinery & other chattels & equipment, & assigns the goodwill of the business carried on at or from the property & the benefit of the licence or certificate. The right to recover & receive any compensation payable in respect of the licence or the certificate. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Deed of legal charge | Creato il 08 lug 2011 Consegnato il 15 lug 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H property k/a part of lavington house, lavington street, southwark, london t/no TGL319641 all fixtures & fittings & all fixed plant & machinery (not being chattels within the meaning of the bills of sales acts). A floating charge over all unfixed plant & machinery & other chattels & equipment, & assigns the goodwill of the business carried on at or from the property & the benefit of the licence or certificate. The right to recover & receive any compensation payable in respect of the licence or the certificate. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 08 lug 2011 Consegnato il 15 lug 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0