ELECTRA-NET GROUP LIMITED

ELECTRA-NET GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàELECTRA-NET GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06408650
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ELECTRA-NET GROUP LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova ELECTRA-NET GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ELECTRA-NET GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HALLCO 1545 LIMITED25 ott 200725 ott 2007

    Quali sono gli ultimi bilanci di ELECTRA-NET GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per ELECTRA-NET GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 29 set 2023

    10 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 65 Gresham Street London EC2V 7NQ England a 1 More London Place London SE1 2AF in data 17 ott 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 30 set 2022

    LRESSP

    Seconda presentazione della Dichiarazione di conformità datata 30 set 2022

    3 pagineRP04CS01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato 65 Gresham Street London EC2V 7NQ

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 65 Gresham Street London EC2V 7NQ

    2 pagineAD02

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2022 con aggiornamenti

    6 pagineCS01
    Note
    DataNota
    17 ott 2022Clarification A second filed CS01 (Shareholder information) was registered on 17/10/2022

    Stato del capitale al 29 set 2022

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Cessazione della carica di Francesca Anne Todd come amministratore in data 10 dic 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Elizabeth Helen Brownell come amministratore in data 10 dic 2021

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    7 pagineAA

    Nomina di Mrs Francesca Anne Todd come amministratore in data 28 mag 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Nicholas Siegfried Dale come amministratore in data 28 mag 2021

    1 pagineTM01

    Modifica dei dettagli di Electra-Net Holdings Limited come persona con controllo significativo il 24 set 2020

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Capita Corporate Director Limited il 24 set 2020

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Capita Group Secretary Limited il 24 set 2020

    1 pagineCH04

    Chi sono gli amministratori di ELECTRA-NET GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7NQ London
    65
    England
    Segretario
    Gresham Street
    EC2V 7NQ London
    65
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione2376959
    135207160001
    BROWNELL, Elizabeth Helen
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritish272617670001
    CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Gresham Street
    EC2V 7NQ London
    65
    England
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7NQ London
    65
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione5641516
    129795770003
    RICHARDS, Karen Louise
    Coxhill
    Boldre
    SO41 8PS Lymington
    Fernbrake
    Hants
    England
    Segretario
    Coxhill
    Boldre
    SO41 8PS Lymington
    Fernbrake
    Hants
    England
    British135121780001
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Segretario nominato
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    DALE, Nicholas Siegfried
    EC2V 7NQ London
    65 Gresham Street
    England
    Amministratore
    EC2V 7NQ London
    65 Gresham Street
    England
    EnglandBritish240399690001
    DICKIN, Anthony John
    7 Ferndown Gardens
    KT11 2BH Cobham
    Surrey
    Amministratore
    7 Ferndown Gardens
    KT11 2BH Cobham
    Surrey
    EnglandBritish127212770001
    FAZAKERLEY, Edmund
    12 Heaton Close
    Heaton Moor
    SK4 4DQ Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    12 Heaton Close
    Heaton Moor
    SK4 4DQ Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish125160350001
    FIRTH, Graham Stuart
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish57134400002
    GILCHRIST, Peter, Major General (Retired)
    Netherhope Lane
    NP16 7JD Tidenham
    Chapel Cottage
    Chepstow
    Amministratore
    Netherhope Lane
    NP16 7JD Tidenham
    Chapel Cottage
    Chepstow
    WalesBritish71169230001
    HANDS, Peter Edward
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish177131690001
    JARVIS, Ian Edward
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish184235890001
    OXLEY, Lisa Ann
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish199132100001
    RICHARDS, Andrew Jonathon
    Coxhill
    Boldre
    SO41 8PS Lymington
    Fernbrake
    Hants
    England
    Amministratore
    Coxhill
    Boldre
    SO41 8PS Lymington
    Fernbrake
    Hants
    England
    EnglandBritish134634200003
    RICHARDS, Karen Louise
    Coxhill
    Boldre
    SO41 8PS Lymington
    Fernbrake
    Hants
    England
    Amministratore
    Coxhill
    Boldre
    SO41 8PS Lymington
    Fernbrake
    Hants
    England
    UkBritish135121780003
    SHEARER, Richard John
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish132651920002
    TARRANT, Justin James
    Maddoxford Farm
    Maddoxford Lane Boorley Green
    SO32 2DB Botley
    Hampshire
    Amministratore
    Maddoxford Farm
    Maddoxford Lane Boorley Green
    SO32 2DB Botley
    Hampshire
    United KingdomBritish127281230001
    TODD, Francesca Anne
    EC2V 7NQ London
    65 Gresham Street
    England
    Amministratore
    EC2V 7NQ London
    65 Gresham Street
    England
    EnglandBritish72249980016
    WINKS, Nicholas Paul David
    The George Business Centre
    Christchurch Road
    BH25 6QJ New Milton
    Hampshire
    Amministratore
    The George Business Centre
    Christchurch Road
    BH25 6QJ New Milton
    Hampshire
    United KingdomBritish151282040001
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Amministratore delegato nominato
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ELECTRA-NET GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Gresham Street
    EC2V 7NQ London
    65
    England
    06 apr 2016
    Gresham Street
    EC2V 7NQ London
    65
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06408649
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    ELECTRA-NET GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 25 feb 2011
    Consegnato il 04 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of them by any group company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Palatine Private Equity LLP (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of shares
    Creato il 06 mag 2010
    Consegnato il 14 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All stock, shares, bonds, debenture, debenture stock, loan stock, unit trust investments, certificates of deposit and other securities of any description and in whatever form. All dividends interest or other distributions paid or payable in respect of them. All allotments accretions offers rights benefits and advantages whatever at any time arising in respect of them. All stocks shares rights money or property accruing to them or offered at any time by way of conversion redemption bonus preference option or otherwise in respect of them and all cash debentures or other obligations shares stocks securities or other valuable consideration of the items held.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 14 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 06 mag 2010
    Consegnato il 12 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Zeus Private Equity LLP (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 12 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage of shares
    Creato il 05 feb 2010
    Consegnato il 16 feb 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All stock shares bonds and other securities including dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 16 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 12 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee & debenture
    Creato il 15 gen 2008
    Consegnato il 23 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Zeus Private Equity LLP (The Security Trustee")
    Transazioni
    • 23 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 15 gen 2008
    Consegnato il 19 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage of shares
    Creato il 15 gen 2008
    Consegnato il 19 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All stock shares bonds and other securities including dividends,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 19 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 15 gen 2008
    Consegnato il 18 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and any other group company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Crouch
    Transazioni
    • 18 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 15 gen 2008
    Consegnato il 18 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Richards and the Noteholders
    Transazioni
    • 18 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    ELECTRA-NET GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 mag 2024Data prevista di scioglimento
    30 set 2022Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0