COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED

COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06473281
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRITTON FLEXIBLES LIMITED15 gen 200815 gen 2008

    Quali sono gli ultimi bilanci di COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    9 pagineLIQ13

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    18 pagineLIQ10

    Soddisfazione dell'onere 064732810007 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 064732810006 in pieno

    4 pagineMR04

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato C/O Coveris Lealand Way Riverside Industrial Estate Boston Lincolnshire PE21 7SW

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 20 Road One Winsford Industrial Estate Winsford Cheshire CW7 3rd England a C/O Coveris Lealand Way Riverside Industrial Estate Boston Lincolnshire PE21 7SW

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 20 Road One Winsford Industrial Estate Winsford Cheshire CW7 3rd a 1 More London Place London SE1 2AF in data 21 ott 2016

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 29 set 2016

    LRESSP

    Nomina di Mr Glen Philip Harte come amministratore in data 22 set 2016

    2 pagineAP01

    Iscrizione dell'ipoteca 064732810007, creata il 18 ago 2016

    74 pagineMR01

    Nomina di Mr Mark Edward Lapping come amministratore in data 25 lug 2016

    2 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 gen 2016

    Stato del capitale al 27 gen 2016

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Britton Taco Ltd Road One Winsford Industrial Estate, Winsford Cheshire CW7 3rd a Unit 20 Road One Winsford Industrial Estate Winsford Cheshire CW7 3rd in data 27 gen 2016

    1 pagineAD01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 25 set 2015

    • Capitale: GBP 10,001.00
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    16 pagineAA

    Cessazione della carica di Mark Edward Lapping come amministratore in data 31 ago 2015

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Paul Malcolm Toby come amministratore in data 30 giu 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 15 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 gen 2015

    Stato del capitale al 21 gen 2015

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Lee David Richardson come amministratore in data 30 giu 2014

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOSTOCK, Karl Robert
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Coveris Flexibles
    Lincolnshire
    England
    Amministratore
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Coveris Flexibles
    Lincolnshire
    England
    United KingdomBritishFinance Director188188900001
    HARTE, Glen Philip
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritishFinancial Controller177938030001
    LAPPING, Mark Edward
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Amministratore
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    EnglandBritishPresident, Coveris Uk Food & Consumer179783440001
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    Segretario
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    British42598360003
    RICHARDSON, Lee
    c/o Britton Taco Limited
    Road One
    The Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Unit 20
    Cheshire
    Segretario
    c/o Britton Taco Limited
    Road One
    The Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Unit 20
    Cheshire
    British177380190002
    ATALLA, Mahmoud Riyad
    Elizabeth Street
    Belgravia
    SW1W 9PP London
    43a
    Amministratore
    Elizabeth Street
    Belgravia
    SW1W 9PP London
    43a
    EnglandBritishInvestor Director128482790001
    CLARK, Michael
    Grand Manor Drive
    FY8 4FY Lytham St. Annes
    21
    Lancashire
    England
    Amministratore
    Grand Manor Drive
    FY8 4FY Lytham St. Annes
    21
    Lancashire
    England
    EnglandBritishCompany Director92294570002
    DEAN, Darren William
    c/o Britton Taco Ltd
    Road One
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Britton Taco Ltd
    Road One
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director114199420001
    DURSTON, John
    The Chimes
    Chantry
    BA11 3LQ Frome
    Somerset
    Amministratore
    The Chimes
    Chantry
    BA11 3LQ Frome
    Somerset
    EnglandBritishInvestor Director2538220001
    FINNERAN, Mark James
    Curtis Close
    DN18 6LE Barton Upon Humber
    Celebration
    North Lincolnshire
    Amministratore
    Curtis Close
    DN18 6LE Barton Upon Humber
    Celebration
    North Lincolnshire
    United KingdomBritishDirector128482390002
    FOX, Thomas
    c/o Britton Taco Ltd
    Road One
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Britton Taco Ltd
    Road One
    Winsford Industrial Estate
    CW7 3RD Winsford
    Cheshire
    United Kingdom
    GermanyGermanCompany Director161682620001
    GILL, Christopher Paul
    Silvertrees 18 Burntwood Road
    TN13 1PT Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Silvertrees 18 Burntwood Road
    TN13 1PT Sevenoaks
    Kent
    EnglandBritishInvestor Director43569560001
    GOODMAN, Stephen Tony
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    Amministratore
    2 Ladyacre
    Bamber Bridge
    PR5 6XN Preston
    Lancashire
    UkBritishCompany Director42598360003
    GREIG, William
    9 The Park
    HR1 1TF Hereford
    Amministratore
    9 The Park
    HR1 1TF Hereford
    EnglandBritishDirector62943430001
    LAPPING, Mark Edward
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Coveris Flexibles
    Lincolnshire
    England
    Amministratore
    Wardentree Park
    Pinchbeck
    PE11 3ZN Spalding
    Coveris Flexibles
    Lincolnshire
    England
    United KingdomBritishCompany Director188189180001
    MAWBY, Allen
    Priors Court
    Aylton
    HR8 2QE Ledbury
    Herefordshire
    Amministratore
    Priors Court
    Aylton
    HR8 2QE Ledbury
    Herefordshire
    United KingdomBritishInvestor Director68092340002
    RICHARDSON, Lee David
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Winsford Industrial
    CW7 3RD Estate, Winsford
    Cheshire
    Amministratore
    C/O Britton Taco Ltd
    Road One Winsford Industrial
    CW7 3RD Estate, Winsford
    Cheshire
    WalesWelshAccountant217305230001
    TOBY, Paul Malcolm
    14 Foxglove Bank
    SG8 9TH Royston
    Hertfordshire
    Amministratore
    14 Foxglove Bank
    SG8 9TH Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritishDirector62668470002
    TURNER, Barry John
    Bridge House
    Newby Wiske
    DL7 9EX Northallerton
    North Yorkshire
    Amministratore
    Bridge House
    Newby Wiske
    DL7 9EX Northallerton
    North Yorkshire
    EnglandBritishDirector178909830001

    COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 ago 2016
    Consegnato il 23 ago 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs Bank Usa as Collateral Agent
    Transazioni
    • 23 ago 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 08 nov 2013
    Consegnato il 15 nov 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Goldman Sachs Bank Usa as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 15 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 19 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 01 giu 2011
    Consegnato il 08 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Investec Bank PLC
    Transazioni
    • 08 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 nov 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debentures
    Creato il 25 mar 2009
    Consegnato il 31 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any present or future group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interest the excluded proceeds the relevant contracts the insurances the charged accounts and all monies see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (Security Agent)
    Transazioni
    • 31 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 25 feb 2008
    Consegnato il 13 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Michael Clark, as Security Agent for the Secured Parties
    Transazioni
    • 13 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 25 feb 2008
    Consegnato il 05 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including buildings fixtures fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Investment Bank Holdings PLC
    Transazioni
    • 05 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 25 feb 2008
    Consegnato il 01 mar 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any group company to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (Security Agent)
    Transazioni
    • 01 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    COVERIS BRAVO FLEXIBLES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 mar 2018Data di scioglimento
    29 set 2016Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Derek Hyslop
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Angela Swarbrick
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    Ernst & Young Llp 1 More London Place
    SE1 2AF London
    Samantha Keen
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0