GHG 2008 3A PROPCO LIMITED
Panoramica
| Nome della società | GHG 2008 3A PROPCO LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 06480421 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di GHG 2008 3A PROPCO LIMITED?
- Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari
Dove si trova GHG 2008 3A PROPCO LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 10 Queen Street Place EC4R 1AG London United Kingdom |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di GHG 2008 3A PROPCO LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per GHG 2008 3A PROPCO LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2019 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 gen 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Gary Hughes come amministratore in data 11 mar 2019 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Steven Lewis Dyson come amministratore in data 11 mar 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Bmi Healthcare House 3 Paris Garden Southwark London SE1 8nd a 10 Queen Street Place London EC4R 1AG in data 09 apr 2019 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 gen 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2018 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 064804210006, creata il 21 feb 2019 | 43 pagine | MR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Catherine Mary Jane Vickery come segretario in data 30 nov 2018 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2017 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 gen 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 064804210005, creata il 10 gen 2018 | 52 pagine | MR01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Ms Catherine Mary Jane Vickery il 16 nov 2017 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2016 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 gen 2017 con aggiornamenti | 6 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr Leonard Kevin Chandran Sebastian come amministratore in data 22 giu 2016 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Edward Richard Charles Watkins-Wright come amministratore in data 03 giu 2016 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2015 | 17 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 22 gen 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Edward Richard Charles Watkins-Wright come amministratore in data 15 apr 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Brian Roy Cole come amministratore in data 31 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di GHG 2008 3A PROPCO LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIBSON, Keith Norman | Amministratore | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom | South Africa | South African | 167976070001 | |||||||||
| HUGHES, Gary | Amministratore | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 257884480001 | |||||||||
| JAMMINE, Azar Paul Hindelly, Dr | Amministratore | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom | South Africa | South African | 167975930001 | |||||||||
| KUSCUS, Martin John | Amministratore | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom | South Africa | South African | 167976190001 | |||||||||
| SACKS, Bradley Jonathan | Amministratore | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom | United States | American,South African | 167961490001 | |||||||||
| SEBASTIAN, Leonard Kevin Chandran | Amministratore | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom | England | Swiss | 127493570001 | |||||||||
| VICKERY, Catherine Mary Jane | Segretario | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House | 197410360001 | |||||||||||
| VICKERY, Catherine Mary Jane | Segretario | Clarence Road SW19 8QD London 142 | British | 102009810002 | ||||||||||
| CITCO MANAGEMENT (UK) LIMITED | Segretario | Albemarle Street W1S 4HQ London 7 England |
| 74414520001 | ||||||||||
| BLANK, Jason Marshall | Amministratore | Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford 4 Middlesex | United Kingdom | British | 168014170001 | |||||||||
| COLE, Brian Roy | Amministratore | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House England | England | British | 174237830001 | |||||||||
| COLLIER, Stephen John | Amministratore | Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford 4 Middlesex | United Kingdom | British | 18350160001 | |||||||||
| DA COSTA, Melanie Sandra Fernandes | Amministratore | Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford 4 Middlesex | South Africa | South African | 149453860001 | |||||||||
| DAVIS, Ingrid Marion | Amministratore | 35 Lotus Street, Gallo Manor Sandton South Africa | South African | 114245720001 | ||||||||||
| DYSON, Steven Lewis | Amministratore | Queen Street Place EC4R 1AG London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 101370280002 | |||||||||
| FIRMAN, Vaughan Erris | Amministratore | Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford 4 Middlesex | South Africa | South African | 138091940001 | |||||||||
| FRIEDLAND, Richard Harold, Dr | Amministratore | Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford 4 Middlesex | South Africa | South African | 113140810001 | |||||||||
| JONES, Ian Martin Lloyd | Amministratore | Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford 4 Middlesex | United Kingdom | British | 114746480001 | |||||||||
| KING, Christopher | Amministratore | Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford 4 Middlesex | United Kingdom | British | 77423330002 | |||||||||
| LEVIN, Hymie Reuvin | Amministratore | Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford 4 Middlesex | South Africa | South African | 113182440002 | |||||||||
| LIVINGSTONE, Richard John | Amministratore | Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford 4 Middlesex | United Kingdom | British | 156147470001 | |||||||||
| MANN, Muhammad Khawar Amin | Amministratore | Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford 4 Middlesex | United Kingdom | British | 112155980002 | |||||||||
| MARKS, David Benjamin | Amministratore | Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford 4 Middlesex | England | British | 141674900001 | |||||||||
| NELSON, Peter | Amministratore | 7 Bedford Avenue Craighall Park Johannesburg 2196 South Africa | South African | 113141300001 | ||||||||||
| NIEHAUS, Charles Jacobus Gysbertus, Dr | Amministratore | Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford 4 Middlesex | United Kingdom | British | 170908100001 | |||||||||
| SACKS, Michael Ivan | Amministratore | Thameside Centre Kew Bridge Road TW8 0HF Brentford 4 Middlesex | South Africa | South African | 114251390001 | |||||||||
| WARRENER, Peter | Amministratore | 20 Mount Royal Kopje Street Morningside Johannesburg 2196 South Africa | South Africa | British | 125692280001 | |||||||||
| WATKINS-WRIGHT, Edward Richard Charles | Amministratore | 3 Paris Garden Southwark SE1 8ND London Bmi Healthcare House | England | British | 199086260001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di GHG 2008 3A PROPCO LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netcare Limited | 06 apr 2016 | Maude Street Sandton 2196 36 South Africa | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
| Ghg 2008 3a (Bvi Property Holdings) Limited | 06 apr 2016 | Road Town 71 Tortola Craigmuir Chambers Virgin Islands, British | No | ||||
| |||||||
Natura del controllo
| |||||||
GHG 2008 3A PROPCO LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 21 feb 2019 Consegnato il 01 mar 2019 | In corso | ||
Breve descrizione St edmunds hospital st mary’s square bury st edmunds (title number SK177077). L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 10 gen 2018 Consegnato il 22 gen 2018 | In corso | ||
Breve descrizione St edmunds hospital st mary's square bury st edmunds t/no SK177077. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 28 gen 2015 Consegnato il 05 feb 2015 | In corso | ||
Breve descrizione St edmunds hospital st. Mary's square bury st edmunds t/no. SK177077. For further details, please refer to the instrument. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| An account charge | Creato il 14 ago 2008 Consegnato il 26 ago 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All rights title and interest in and to the accounts and deposits by way of fixed charge see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 01 feb 2008 Consegnato il 14 feb 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Nuffield hospital, st mary's sqaure, bury st edmunds t/no SK177077. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 01 feb 2008 Consegnato il 14 feb 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital book debts subsidiary shares plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0