C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED

C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàC.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06518342
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    International House
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    Merseyside
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    PIMCO 2751 LIMITED29 feb 200829 feb 2008

    Quali sono gli ultimi bilanci di C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 065183420005 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 065183420006 in pieno

    4 pagineMR04

    legacy

    3 pagineSH20

    Stato del capitale al 27 nov 2020

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    3 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share prem a/c and capital redemption reserve cancelled 26/11/2020
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 065183420004 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2018

    39 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 065183420006, creata il 25 giu 2019

    73 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 feb 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 05 nov 2018

    • Capitale: GBP 203,251.84
    8 pagineSH01

    Scissione delle azioni al 05 nov 2018

    6 pagineSH02

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Dettagli della variazione dei diritti legati alle azioni

    2 pagineSH10

    Risoluzioni

    Resolutions
    14 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzioni

    Sub divided 05/11/2018
    RES13
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    26 pagineAR01
    Note
    DataNota
    18 ott 2018Replacement This document replaces the AR01 registered on 29/04/2018 as it was not properly delivered.

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    24 pagineAR01
    Note
    DataNota
    18 ott 2018Replacement This document replaces the AR01 registered on 27/03/2015 as it was not properly delivered.

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    23 pagineAR01
    Note
    DataNota
    18 ott 2018Replacement This document replaces the AR01 registered on 23/04/2014 as it was not properly delivered.

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    21 pagineAR01
    Note
    DataNota
    18 ott 2018Replacement This document replaces the AR01 registered on 01/05/2013 as it was not properly delivered.

    Chi sono gli amministratori di C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUXTON, Matthew Robert
    Millfield Lane
    Haydock
    WA11 9GA St. Helens
    International House
    Merseyside
    England
    Segretario
    Millfield Lane
    Haydock
    WA11 9GA St. Helens
    International House
    Merseyside
    England
    177913450001
    BRAYSHAW, Nicholas Paul
    Millfield Lane
    Haydock
    WA11 9GA St. Helens
    International House
    Merseyside
    England
    Amministratore
    Millfield Lane
    Haydock
    WA11 9GA St. Helens
    International House
    Merseyside
    England
    EnglandBritish96985570003
    BUXTON, Matthew Robert
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    United Kingdom
    EnglandBritish177912050001
    TILSLEY, Neil Andrew
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    Amministratore
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    United KingdomBritish232028330001
    BAKER, Stephen Peter
    37 Rossett Park
    Darland Lane
    LL12 0FB Rossett
    Wrexham
    Segretario
    37 Rossett Park
    Darland Lane
    LL12 0FB Rossett
    Wrexham
    British44068330003
    BOWERBANK, David Christopher
    Deeside Lane
    Sealand
    CH1 6BQ Chester
    1 The Bowery
    Segretario
    Deeside Lane
    Sealand
    CH1 6BQ Chester
    1 The Bowery
    British138170880001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    BAKER, Stephen Peter
    37 Rossett Park
    Darland Lane
    LL12 0FB Rossett
    Wrexham
    Amministratore
    37 Rossett Park
    Darland Lane
    LL12 0FB Rossett
    Wrexham
    United KingdomBritish44068330003
    FRASER, Nicol Roderick Peter
    2 Murrayfield Road
    EH12 6EJ Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    2 Murrayfield Road
    EH12 6EJ Edinburgh
    Midlothian
    United KingdomBritish67603430001
    GEORGE, Lionel Michel
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    England
    Amministratore
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    England
    FranceFrench195550670001
    GOODBURN, Steven John
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    Amministratore
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    United KingdomBritish130123380003
    GUILLOT, Christophe
    Boulevard Arago
    75013
    Paris
    38
    France
    Amministratore
    Boulevard Arago
    75013
    Paris
    38
    France
    FranceFrench129625350002
    JOLLIFFE, David
    Earls Gate
    Bothwell
    G71 8BP Glasgow
    6a
    United Kingdom
    Amministratore
    Earls Gate
    Bothwell
    G71 8BP Glasgow
    6a
    United Kingdom
    ScotlandBritish151826090002
    MILLWARD, Phillip Robert
    The Cottage
    2a Talbot Road
    WA14 3JD Bowdon
    Cheshire
    Amministratore
    The Cottage
    2a Talbot Road
    WA14 3JD Bowdon
    Cheshire
    British97811170001
    ROWAN, Simon
    Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Scotland
    Amministratore
    Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltire Court
    Scotland
    United KingdomBritish167430200002
    STRANG, James Mark Nelson
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    United Kingdom
    Amministratore
    Millfield Lane
    WA11 9GA Haydock
    International House
    Merseyside
    United Kingdom
    United KingdomBritish124509390001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    128143250001

    Chi sono le persone con controllo significativo di C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Millfield Lane
    Haydock
    WA11 9GA Merseyside
    International House
    England
    27 set 2018
    Millfield Lane
    Haydock
    WA11 9GA Merseyside
    International House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEnglish
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione11563023
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltaire Court
    Scotland
    06 apr 2016
    Castle Terrace
    EH1 2EN Edinburgh
    Saltaire Court
    Scotland
    Forma giuridicaPlc
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk Law
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneSc052844
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    32 Gallowgate
    NE1 4SN Newcastle Upon Tyne
    Time Central
    United Kingdom
    06 apr 2016
    32 Gallowgate
    NE1 4SN Newcastle Upon Tyne
    Time Central
    United Kingdom
    Forma giuridicaLlp
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazioneOc392261
    Natura del controllo
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    C.G.I. GROUP HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 25 giu 2019
    Consegnato il 05 lug 2019
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Tc Loans I Limited (As Security Trustee of the Secured Parties)
    Transazioni
    • 05 lug 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 dic 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 set 2018
    Consegnato il 10 ott 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Each chargor charges all its right, title and interest by way of first legal mortgage over all land vested in such chargor and all land acquired by such chargor after the date of the instrument. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Eso Capital Partners UK LLP (As Security Trustee for and on Behalf of the Secured Parties)
    Transazioni
    • 10 ott 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 17 dic 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 set 2016
    Consegnato il 03 ott 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Each security obligor charges and agrees to charge all of its present and future right, title and interest in and to the following assets which are at any time owned by it, or in which it from time to time has an interest:. (A) by way of first legal mortgage the specified real property;. (B) by way of first fixed charge:. (I) all real property and all interests in real property not charged by clause 5.1(a);. (Ii) all licences to enter upon or use land and the benefit of all other agreements relating to land; and. (Iii) the proceeds of sale of all real property other than specified real property;. (C) by way of first fixed charge the intellectual property (if any) specified in part 4 of schedule 3 (details of security assets); and. (D) by way of first fixed charge all intellectual property (if any) not charged by clause 5.1(q).. "Specified real property" means the estates and interests in freehold, leasehold and other immovable property (if any) specified in part 1 of schedule 3 (details of security assets) together with:. (A) all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed p&m at any time thereon;. (B) all easements, rights and agreements in respect thereof;. (C) the benefit of all covenants given in respect thereof; and. (D) any other real property which shawbrook may designate as "specified real property".. All defined terms are as defined in the composite guarantee and debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Shawbrook Bank Limited T/a Shawbrook Business Credit ("Shawbrook")
    Transazioni
    • 03 ott 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 27 set 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 29 ago 2012
    Consegnato il 12 set 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dunedin Enterprise Investment Trust PLC
    Transazioni
    • 12 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 16 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 16 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 giu 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 10 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the stockholders on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Dunedin Enterprise Investment Trust PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 10 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 ott 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0