ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED

ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06576312
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o KAY JOHNSON GEE CORPORATE RECOVERY LIMITED
    1 City Road East
    M15 4PN Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ONEDIN GENERAL PARTNER LIMITED20 giu 200820 giu 2008
    PIMCO 2773 LIMITED25 apr 200825 apr 2008

    Quali sono gli ultimi bilanci di ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    16 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 set 2017

    22 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 03 set 2016

    13 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester Lancashire M3 5EQ a C/O Kay Johnson Gee Corporate Recovery Limited 1 City Road East Manchester M15 4PN in data 15 giu 2016

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Centrix House Crow Lane East Newton Le Willows Merseyside WA12 9UY a Kay Johnson Gee 201 Chapel Street Manchester Lancashire M3 5EQ in data 03 ott 2015

    3 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 04 set 2015

    LRESEX

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 25 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 ago 2015

    Stato del capitale al 21 ago 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Cessazione della carica di Malcolm William Jackson come amministratore in data 29 dic 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Isabel Anne Mulroy come amministratore in data 29 dic 2014

    1 pagineTM01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2014

    14 pagineAA

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 25 apr 2014 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 mag 2014

    Stato del capitale al 16 mag 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2013

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 25 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    8 pagineAR01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2012

    14 pagineAA

    Nomina di Isabel Anne Mulroy come amministratore

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 25 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Cessazione della carica di Trevor Waggett come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2011

    14 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JACKSON, Malcolm William
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    Segretario
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    BritishChartered Accountant62603060001
    DOWNES, John Alfred
    16 Field Lane
    Appleton
    WA4 5JF Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    16 Field Lane
    Appleton
    WA4 5JF Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor59635480003
    GRAHAM, Neil
    Goldcrest Way
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Goldcrest Way
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishSurveyor157234940001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    CRAMOND, David John
    Embleton Drive
    DH2 3JS Chester Le Street
    33
    County Durham
    Amministratore
    Embleton Drive
    DH2 3JS Chester Le Street
    33
    County Durham
    United KingdomBritishDirector Of Capital Development135860150001
    JACKSON, Malcolm William
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    Amministratore
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    United KingdomBritishChartered Accountant62603060001
    MULROY, Isabel Anne
    Kingsway
    Team Valley
    NE11 0NA Gateshead
    Homes And Communities Agency St Georges House
    Tyne And Wear
    Uk
    Amministratore
    Kingsway
    Team Valley
    NE11 0NA Gateshead
    Homes And Communities Agency St Georges House
    Tyne And Wear
    Uk
    UkBritishHead Of Area Homes And Communities Agency170524310001
    PAGE, Malcolm Douglas
    2 Cauldwell Close
    Monkseaton
    NE25 8LP Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Amministratore
    2 Cauldwell Close
    Monkseaton
    NE25 8LP Whitley Bay
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishDirector112804370001
    ROWLEY, Edwin John
    8 Holywell Green
    TS16 9HH Stockton
    Amministratore
    8 Holywell Green
    TS16 9HH Stockton
    BritishDirector97096850001
    WAGGETT, Trevor John
    Goldcrest Way
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Goldcrest Way
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    EnglandBritishDirector Of Finance104786440001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    128143250001

    ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement: agency c loan notes
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 03 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • One Northeast
    Transazioni
    • 03 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2009
    Security agreement: b loan notes
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 03 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • One Northeast
    Transazioni
    • 03 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2009
    Security agreement: agency a loan notes
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 03 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • One Northeast
    Transazioni
    • 03 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2009
    Security agreement psp a loan notes
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 08 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at newburn industrial estate, newburn t/no TY270459. F/h land at shelley road, newburn industrial estate, newburn t/no TY315490. F/h land on the south side of leamington road, newburn industrial estate, newburn t/no TY315503. (For further details of properties charged please refer to form 395) and all plant, machinery or equipment. All benefits in respect of the insurances see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Langtree Northeast Limited (Psp)
    Transazioni
    • 08 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement psp c loan notes
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 08 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at newburn industrial estate, newburn t/n TY270459. F/h land at shelley road, newburn industrial estate, newburn t/n TY315490. F/h land on the south side of leamingon road, newburn industrial estate, newburn t/n TY315503 (for details of further properties charged please refer to form 395) and fixed charge all plant machiney, insurances and shares see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Langtree Northeast Limited
    Transazioni
    • 08 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed charge:c loan designated account
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 03 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge the sums standing from time to time to the credit of the c loan designated account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • One Northeast
    Transazioni
    • 03 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)

    ONSITE NORTH EAST GENERAL PARTNER LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    04 set 2015Inizio della liquidazione
    15 feb 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Peter James Anderson
    Griffin Court 201 Chapel Street
    M3 5EQ Salford
    Lancashire
    Praticante
    Griffin Court 201 Chapel Street
    M3 5EQ Salford
    Lancashire
    Alan David Fallows
    Griffin Court 201 Chapel Street
    Salford
    M3 5EQ Manchester
    Praticante
    Griffin Court 201 Chapel Street
    Salford
    M3 5EQ Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0