ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED

ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06623768
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Centrix House
    Crow Lane East
    WA12 9UY Newton Le Willows
    Merseyside
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ONEDIN (NOMINEES) LIMITED07 lug 200807 lug 2008
    PIMCO 2789 LIMITED18 giu 200818 giu 2008

    Quali sono gli ultimi bilanci di ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 ago 2015

    Stato del capitale al 21 ago 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Malcolm William Jackson come amministratore in data 19 dic 2014

    2 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 ago 2014

    Stato del capitale al 21 ago 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Cessazione della carica di Isabel Anne Mulroy come amministratore in data 18 feb 2014

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 lug 2013

    Stato del capitale al 23 lug 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Nomina di Isabel Anne Mulroy come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Trevor Waggett come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    5 pagineAA

    Nomina di Trevor John Waggett come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Neil Graham come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Cramond come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Malcolm Page come amministratore

    2 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 18 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2009

    5 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed onedin (nominees) LIMITED\certificate issued on 09/07/09
    3 pagineCERTNM

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    395

    Chi sono gli amministratori di ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JACKSON, Malcolm William
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    Segretario
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    BritishChartered Accountant62603060001
    DOWNES, John Alfred
    16 Field Lane
    Appleton
    WA4 5JF Warrington
    Cheshire
    Amministratore
    16 Field Lane
    Appleton
    WA4 5JF Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor59635480003
    GRAHAM, Neil
    Goldcrest Way Newburn
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Goldcrest Way Newburn
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishSurveyor157234940001
    PINSENT MASONS SECRETARIAL LIMITED
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    Segretario
    1 Park Row
    LS1 5AB Leeds
    West Yorkshire
    76579530001
    CRAMOND, David John
    Embleton Drive
    DH2 3JS Chester Le Street
    33
    County Durham
    Amministratore
    Embleton Drive
    DH2 3JS Chester Le Street
    33
    County Durham
    United KingdomBritishDirector Of Capital Development135860150001
    JACKSON, Malcolm William
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    Amministratore
    1 Kingsbury Close
    Appleton
    WA4 5FF Warrington
    United KingdomBritishChartered Accountant62603060001
    MULROY, Isabel Anne
    Kingsway
    Team Valley
    NE11 0NA Gateshead
    Homes And Communities Agency St Georges House
    Tyne And Wear
    Uk
    Amministratore
    Kingsway
    Team Valley
    NE11 0NA Gateshead
    Homes And Communities Agency St Georges House
    Tyne And Wear
    Uk
    UkBritishHead Of Area Hca170524310001
    PAGE, Malcolm Douglas
    2 Cauldwell Close
    Monkseaton
    NE25 8LP Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Amministratore
    2 Cauldwell Close
    Monkseaton
    NE25 8LP Whitley Bay
    Tyne & Wear
    United KingdomBritishDirector112804370001
    WAGGETT, Trevor John
    Goldcrest Way
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    Amministratore
    Goldcrest Way
    Newburn Riverside
    NE15 8NY Newcastle Upon Tyne
    One North East Stella House
    Tyne & Wear
    EnglandBritishDirector Of Finance104786440001
    PINSENT MASONS DIRECTOR LIMITED
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    Amministratore
    Park Row
    LS1 5AB Leeds
    1
    West Yorkshire
    128143250001

    ONSITE NORTH EAST NOMINEES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Security agreement: agency c loan notes
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 06 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • One Northeast (The Agency)
    Transazioni
    • 06 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement: b loan notes
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 06 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Northeast One (The Agency)
    Transazioni
    • 06 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement: agency a loan notes
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 06 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY270459; f/h land at shelley road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315490; f/h land on the south side of leamington road newburn industrial estate newburn newburn haugh newcastle upon tyne t/no. TY315503 for details of further property please see form 395 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • One Northeast (The Agency)
    Transazioni
    • 06 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement psp a loan notes
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 08 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at newburn industrial estate, newburn t/no TY270459. F/h land at shelley road, newburn industrial estate, newburn t/no TY315490. F/h land on the south side of leamington road, newburn industrial estate, newburn t/no TY315503. (For further details of properties charged please refer to form 395) and all plant, machinery or equipment. All benefits in respect of the insurances see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Langtree Northeast Limited (Psp)
    Transazioni
    • 08 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security agreement psp c loan notes
    Creato il 31 mar 2009
    Consegnato il 08 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land at newburn industrial estate, newburn t/n TY270459. F/h land at shelley road, newburn industrial estate, newburn t/n TY315490. F/h land on the south side of leamingon road, newburn industrial estate, newburn t/n TY315503 (for details of further properties charged please refer to form 395) and fixed charge all plant machiney, insurances and shares see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Langtree Northeast Limited
    Transazioni
    • 08 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 apr 2009

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0