CALLSTREAM GROUP LIMITED

CALLSTREAM GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCALLSTREAM GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06706812
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CALLSTREAM GROUP LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova CALLSTREAM GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor, The Anchorage
    34 Bridge Street
    RG1 2LU Reading
    Berkshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CALLSTREAM GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BLUEBELL TELECOM GROUP LIMITED06 ott 201006 ott 2010
    VULCAN SERVICES II LIMITED26 set 200826 set 2008
    VULCAN II LIMITED24 set 200824 set 2008

    Quali sono gli ultimi bilanci di CALLSTREAM GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per CALLSTREAM GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Memorandum e Statuto

    19 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    All directors decisions ratified 23/08/2023
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Cessazione della carica di Andrew Simon Price come amministratore in data 06 giu 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di David Aidan Harpur come amministratore in data 06 giu 2023

    2 pagineAP01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2021

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 set 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2020

    15 pagineAA

    Notifica di Joseph Anthony Liemandt come persona con controllo significativo il 09 feb 2021

    2 paginePSC01

    Cessazione di Dnn Corp. come persona con controllo significativo il 09 feb 2021

    1 paginePSC07

    Dichiarazione di conformità presentata il 25 set 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Annullamento di azioni. Stato del capitale al 20 nov 2014

    • Capitale: GBP 403.04872
    8 pagineSH06

    Nomina di Pitsec Limited come segretario in data 10 feb 2021

    2 pagineAP04

    Notifica di Dnn Corp. come persona con controllo significativo il 09 feb 2021

    2 paginePSC02

    Cessazione di J2 Global Uk Ltd come persona con controllo significativo il 09 feb 2021

    1 paginePSC07

    Nomina di Mr Andrew Simon Price come amministratore in data 09 feb 2021

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Jeremy David Rossen come amministratore in data 09 feb 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Satminder Ramewal come amministratore in data 09 feb 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jeremy David Rossen come segretario in data 09 feb 2021

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da 18 Mansell Street Level 3 London E1 8AA England a 4th Floor, the Anchorage 34 Bridge Street Reading Berkshire RG1 2LU in data 10 feb 2021

    1 pagineAD01

    Nomina di Satminder Ramewal come amministratore in data 19 dic 2020

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di CALLSTREAM GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    PITSEC LIMITED
    34 Bridge Street
    RG1 2LU Reading
    4th Floor, The Anchorage
    Berkshire
    England
    Segretario
    34 Bridge Street
    RG1 2LU Reading
    4th Floor, The Anchorage
    Berkshire
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione02451677
    38734010001
    HARPUR, David Aidan
    34 Bridge Street
    RG1 2LU Reading
    4th Floor, The Anchorage
    Berkshire
    England
    Amministratore
    34 Bridge Street
    RG1 2LU Reading
    4th Floor, The Anchorage
    Berkshire
    England
    EnglandIrish309862860001
    CROSTHWAITE, Michael Tudor
    The Battleship Building
    179 Harrow Road
    W2 6NB London
    Ground & 1st Floor Mezzanine
    Segretario
    The Battleship Building
    179 Harrow Road
    W2 6NB London
    Ground & 1st Floor Mezzanine
    168918340001
    ROSSEN, Jeremy David
    34 Bridge Street
    RG1 2LU Reading
    4th Floor, The Anchorage
    Berkshire
    England
    Segretario
    34 Bridge Street
    RG1 2LU Reading
    4th Floor, The Anchorage
    Berkshire
    England
    206690490001
    WHITTEN, Celia Linda
    Brackendene 15 Hutton Road
    Ash Vale
    GU12 5EY Aldershot
    Hampshire
    Segretario
    Brackendene 15 Hutton Road
    Ash Vale
    GU12 5EY Aldershot
    Hampshire
    British10627780001
    PHILSEC LIMITED
    Colmore Square
    B4 6AA Birmingham
    1
    West Midlands
    United Kingdom
    Segretario
    Colmore Square
    B4 6AA Birmingham
    1
    West Midlands
    United Kingdom
    128114410001
    BANNER, Paul Lancelot
    Meadway
    KT10 9HG Esher
    43
    Surrey
    Amministratore
    Meadway
    KT10 9HG Esher
    43
    Surrey
    EnglandBritish142808820001
    BARRACLOUGH, Nigel Mark
    Asama Court
    Newcastle Business Park
    NE4 7YD Newcastle Upon Tyne
    Panther House
    Tyne And Wear
    Amministratore
    Asama Court
    Newcastle Business Park
    NE4 7YD Newcastle Upon Tyne
    Panther House
    Tyne And Wear
    United KingdomBritish82811620005
    BUSST, Craig Alyn
    The Battleship Building
    179 Harrow Road
    W2 6NB London
    Ground & 1st Floor Mezzanine
    Amministratore
    The Battleship Building
    179 Harrow Road
    W2 6NB London
    Ground & 1st Floor Mezzanine
    EnglandBritish188522930001
    CROSTHWAITE, Michael Tudor
    William James Way
    B95 5GF Henley-In-Arden
    3 Ardent Court
    Warwickshire
    Amministratore
    William James Way
    B95 5GF Henley-In-Arden
    3 Ardent Court
    Warwickshire
    EnglandBritish106412590005
    DAVIS, Benjamin Thomas Kidd
    William James Way
    B95 5GF Henley-In-Arden
    3 Ardent Court
    Warwickshire
    Amministratore
    William James Way
    B95 5GF Henley-In-Arden
    3 Ardent Court
    Warwickshire
    United KingdomNew Zealand114537000001
    DRURY, Mark John
    The Battleship Building
    179 Harrow Road
    W2 6NB London
    Ground & 1st Floor Mezzanine
    Amministratore
    The Battleship Building
    179 Harrow Road
    W2 6NB London
    Ground & 1st Floor Mezzanine
    United KingdomBritish64414570003
    EIKENBERRY, John Davis
    Mansell Street
    Level 3
    E1 8AA London
    18
    England
    Amministratore
    Mansell Street
    Level 3
    E1 8AA London
    18
    England
    EnglandAmerican213599180001
    HARTMAN, Joe Gray
    The Battleship Building
    179 Harrow Road
    W2 6NB London
    Ground & 1st Floor Mezzanine
    Amministratore
    The Battleship Building
    179 Harrow Road
    W2 6NB London
    Ground & 1st Floor Mezzanine
    EnglandBritish187298390001
    HAYNES, David Jack
    William James Way
    B95 5GF Henley-In-Arden
    3 Ardent Court
    Warwickshire
    Amministratore
    William James Way
    B95 5GF Henley-In-Arden
    3 Ardent Court
    Warwickshire
    United KingdomBritish189860590001
    MCGIVERON, Adam Thomas
    Elm Farm
    DE73 7HW Ingleby
    The Byre
    Derbyshire
    Amministratore
    Elm Farm
    DE73 7HW Ingleby
    The Byre
    Derbyshire
    United KingdomBritish134307870001
    NICOL, Stuart
    Angel Court
    EC2R 7HP London
    8
    Amministratore
    Angel Court
    EC2R 7HP London
    8
    United KingdomBritish138168090004
    NORDEN, Michael Robert
    William James Way
    B95 5GF Henley-In-Arden
    3 Ardent Court
    Warwickshire
    Amministratore
    William James Way
    B95 5GF Henley-In-Arden
    3 Ardent Court
    Warwickshire
    EnglandBritish121560410001
    OWENS, Nigel Johnson
    The Battleship Building
    179 Harrow Road
    W2 6NB London
    Ground & 1st Floor Mezzanine
    Amministratore
    The Battleship Building
    179 Harrow Road
    W2 6NB London
    Ground & 1st Floor Mezzanine
    United KingdomBritish163695650001
    PRICE, Andrew Simon
    34 Bridge Street
    RG1 2LU Reading
    4th Floor, The Anchorage
    Berkshire
    England
    Amministratore
    34 Bridge Street
    RG1 2LU Reading
    4th Floor, The Anchorage
    Berkshire
    England
    United StatesAmerican279564380001
    RAMEWAL, Satminder Singh
    34 Bridge Street
    RG1 2LU Reading
    4th Floor, The Anchorage
    Berkshire
    England
    Amministratore
    34 Bridge Street
    RG1 2LU Reading
    4th Floor, The Anchorage
    Berkshire
    England
    EnglandBritish105786300001
    ROSSEN, Jeremy David, Mr.
    34 Bridge Street
    RG1 2LU Reading
    4th Floor, The Anchorage
    Berkshire
    England
    Amministratore
    34 Bridge Street
    RG1 2LU Reading
    4th Floor, The Anchorage
    Berkshire
    England
    United StatesAmerican206558690001
    SAMUEL, Paul Richard Blelock
    4 Saville Street
    NE33 2PR South Shields
    Saville Chambers
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Amministratore
    4 Saville Street
    NE33 2PR South Shields
    Saville Chambers
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    EnglandBritish152601840001
    SMITH, Michael Margetson
    120c Duchy Road
    HG1 2HE Harrogate
    Crystal Springs
    North Yorkshire
    Amministratore
    120c Duchy Road
    HG1 2HE Harrogate
    Crystal Springs
    North Yorkshire
    EnglandBritish81641700001
    SMITH, Simon Mark
    9 Todenham Way
    Hatton Park
    CV35 7UE Warwickshire
    Amministratore
    9 Todenham Way
    Hatton Park
    CV35 7UE Warwickshire
    EnglandEnglish75088610002
    MEAUJO INCORPORATIONS LIMITED
    Colmore Square
    B4 6AA Birmingham
    No 1
    West Midlands
    United Kingdom
    Amministratore
    Colmore Square
    B4 6AA Birmingham
    No 1
    West Midlands
    United Kingdom
    128114420001

    Chi sono le persone con controllo significativo di CALLSTREAM GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Dnn Corp.
    S. State Street Suite B
    19901 Dover
    1675
    Delaware
    United States
    09 feb 2021
    S. State Street Suite B
    19901 Dover
    1675
    Delaware
    United States
    Forma giuridicaPrivate Company
    Paese di registrazioneState Of Delaware
    Autorità legaleState Of Delaware
    Luogo di registrazioneState Of Delaware
    Numero di registrazioneTax Id: 20-5616163
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Mr Joseph Anthony Liemandt
    34 Bridge Street
    RG1 2LU Reading
    4th Floor, The Anchorage
    Berkshire
    England
    09 feb 2021
    34 Bridge Street
    RG1 2LU Reading
    4th Floor, The Anchorage
    Berkshire
    England
    No
    Nazionalità: American
    Paese di residenza: United States
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    The Battleship Building
    Harrow Road
    W2 6NB London
    Ground And 1st Floor Mezzanine
    United Kingdom
    06 apr 2016
    The Battleship Building
    Harrow Road
    W2 6NB London
    Ground And 1st Floor Mezzanine
    United Kingdom
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleLaws Of England
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione3721601
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CALLSTREAM GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 ott 2014
    Consegnato il 08 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    As detailed further in clause 2 of the mortgage of policy, the mortgage of policy assigned to clydesdale bank PLC (trading as yorkshire bank) by callstream group limited a policy held with scottish equitable PLC trading as ‘aegon scottish equitable’ in respect of the life of michael tudor crosthwaite under the policy number L0190167453.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 08 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 07 ago 2018Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 18 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 18 ago 2011
    Consegnato il 07 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 07 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 07 ago 2018Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    • 18 feb 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of accession (and variation)
    Creato il 08 set 2010
    Consegnato il 22 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) or to the trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All monies and liabilities covenanted to be paid or discharged by it, all its property, assets and undertaking see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Investments Limited (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 22 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal assignment of keyman policies
    Creato il 08 set 2010
    Consegnato il 21 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The key man policies - no. Of policy: L0195479343 date: on or about the date of this assignment insurer: aegon scottish equitable life assured: michael crosthwaite sum assured: £1,750,000.00 term: 5 years beneficiary: the company, no. Of policy: L0197579343 date: on or about the date of this assignment insurer: aegon scottish equitable life assured: michael smith sum assured: £1,750,000.00 term: 5 years beneficiary: the company with full title guarantee assigns by way of absolute assignment all the rights, title, interest and benefit to the key man policies see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Investments Limited (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 21 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 08 set 2010
    Consegnato il 18 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Yfm Private Equity Limited
    Transazioni
    • 18 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 set 2010
    Consegnato il 16 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 16 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 08 set 2010
    Consegnato il 16 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from or by any initial charging company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Paul Richard Blelock Samuel
    Transazioni
    • 16 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 08 set 2010
    Consegnato il 11 set 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the trustee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mark John Drury as Trustee for Himself and Gail Brown Drury
    Transazioni
    • 11 set 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 lug 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 27 gen 2010
    Consegnato il 08 feb 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Apollo Vct 1 PLC, Octopus Apollo Vct 2 PLC, Octopus Protected Vct PLC and Octopus Protected Vct 2 PLC (As Trustee for Itself)
    Transazioni
    • 08 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Second deed of variation to a composite guarantee and debenture dated 26 november 2008 and
    Creato il 05 mag 2009
    Consegnato il 19 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Octopus Apollo Vct 1 PLC as Security Trustee for Itself and Octopus Apollo Vct 2 PLC and Octopus Protected Vct PLC
    Transazioni
    • 19 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of variation to a composite guarantee and debenture
    Creato il 12 dic 2008
    Consegnato il 23 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the trustee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Apollo Vct 1 PLC (As Trustee for Itself),Apollo Vct 2 PLC and Octopus Protected Vct PLC
    Transazioni
    • 23 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 nov 2008
    Consegnato il 05 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries (or any of them) or to the trustee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Apollo Vct 1 PLC
    Transazioni
    • 05 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0