LAKESIDE EIS 2 LIMITED

LAKESIDE EIS 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLAKESIDE EIS 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 06866166
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LAKESIDE EIS 2 LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova LAKESIDE EIS 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Pinnacle
    170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LAKESIDE EIS 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NO SAINTS LIMITED20 mag 201020 mag 2010
    LAKESIDE EIS 2 LIMITED01 apr 200901 apr 2009

    Quali sono gli ultimi bilanci di LAKESIDE EIS 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 ott 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per LAKESIDE EIS 2 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per LAKESIDE EIS 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    38 pagine4.72

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:re block transfer replacement of liq
    17 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Indirizzo della sede legale modificato da 34 Clarendon Road Watford WD17 1JJ a The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1BP in data 17 mar 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 18 ago 2014

    26 pagine4.68

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:court order - replacement of liquidator
    13 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Cessazione della carica di Ian Zant-Boer come amministratore

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Seebeck House 1 Seebeck Place Knowlhill Milton Keynes Buckinghamshire MK5 8FR United Kingdom* in data 30 ago 2013

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 19 ago 2013

    LRESEX

    Iscrizione dell'ipoteca 068661660006

    33 pagineMR01

    Nomina di Ian Zant-Boer come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew Marks come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 01 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    23 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 apr 2013

    Stato del capitale al 24 apr 2013

    • Capitale: GBP 4,664.559
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael William Balfour il 28 feb 2013

    2 pagineCH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed no saints LIMITED\certificate issued on 05/12/12
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name05 dic 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 04 dic 2012

    RES15
    change-of-name05 dic 2012

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    legacy

    5 pagineMG02

    legacy

    5 pagineMG01

    Chi sono gli amministratori di LAKESIDE EIS 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    EMW SECRETARIES LIMITED
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3512570
    93910510003
    BALFOUR, Michael William
    Seebeck House
    1 Seebeck Place, Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    C/O Emw
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Seebeck House
    1 Seebeck Place, Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    C/O Emw
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    MalaysiaBritish36866470009
    THOMAS, Stephen Charles
    Seebeck House 1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    C/O Emw Picton Howell Llp
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Seebeck House 1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    C/O Emw Picton Howell Llp
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish66198390011
    ZANT-BOER, Ian
    Seebeck House, 1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Emw Picton Howell Llp
    Buckinghamshire
    Segretario
    Seebeck House, 1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Emw Picton Howell Llp
    Buckinghamshire
    151507360001
    EMW SECRETARIES LIMITED
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    137393100001
    CRAIG, Jane Ann
    Plough Hill
    CO10 8LT Stansfield
    Plough Hill Barn
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    Plough Hill
    CO10 8LT Stansfield
    Plough Hill Barn
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish137517770001
    EMARY, Simon Paul
    Poplar Rise
    NN12 8RR Wappenham, Nr Towcester
    1
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Poplar Rise
    NN12 8RR Wappenham, Nr Towcester
    1
    Northamptonshire
    United Kingdom
    EnglandBritish77109600005
    MARKS, Andrew Geoffrey
    Seebeck House
    1 Seebeck Place, Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    C/O Emw
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Seebeck House
    1 Seebeck Place, Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    C/O Emw
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish98760390001
    MITCHELL, Darren Paul
    19 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    West Midlands
    Amministratore
    19 Stoneton Crescent
    Balsall Common
    CV7 7QG Coventry
    West Midlands
    United KingdomBritish120968310001
    ROBINS, Gary John
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish155402600001
    SAWYER, Christopher John
    Stansfield
    C010 8LT Sudbury
    Plough Hill Barn
    Suffolk
    Amministratore
    Stansfield
    C010 8LT Sudbury
    Plough Hill Barn
    Suffolk
    United KingdomBritish234740930001
    ZANT-BOER, Ian Leslie
    Seebeck House, 1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Emw
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Seebeck House, 1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Emw
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    EnglandBritish141268510001
    ZANT-BOER, Ian Leslie
    Maidford Road
    NN12 8HE Farthingstone
    Garden Cottage Little Court
    Northamptonshire
    Amministratore
    Maidford Road
    NN12 8HE Farthingstone
    Garden Cottage Little Court
    Northamptonshire
    EnglandBritish141268510001
    EMW DIRECTORS LIMITED
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    1 Seebeck Place
    Knowlhill
    MK5 8FR Milton Keynes
    Seebeck House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    137393120001

    LAKESIDE EIS 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 19 ago 2013
    Consegnato il 24 ago 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Brendan Quinn (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 24 ago 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 22 ott 2012
    Consegnato il 25 ott 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hawk Investment Holdings Limited
    Transazioni
    • 25 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 21 set 2012
    Consegnato il 28 set 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first floating charge all the undertaking property assets and rights of the borrower at any time.
    Persone aventi diritto
    • Best Asset Management Limited
    Transazioni
    • 28 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 05 lug 2012
    Consegnato il 13 lug 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company's interest in the amount from time to time standing to the ctredit of a deposit account.
    Persone aventi diritto
    • Packwood Properties Limited
    Transazioni
    • 13 lug 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 15 apr 2011
    Consegnato il 23 apr 2011
    In corso
    Importo garantito
    £42,500.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All monies held within the rent deposit deed. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Darkwood Properties Limited
    Transazioni
    • 23 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal charge
    Creato il 17 feb 2011
    Consegnato il 04 mar 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H 33-35 albion street, cheltenham t/n GR162172, fixed charge all rights in any policies of insurance see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Brode, Simon Lousada and Phase Investments
    Transazioni
    • 04 mar 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 ott 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    LAKESIDE EIS 2 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 ago 2013Inizio della liquidazione
    10 feb 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas Simmonds
    34 Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    Praticante
    34 Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    Peter James Hughes-Holland
    34 Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    Hertfordshire
    Praticante
    34 Clarendon Road
    WD17 1JJ Watford
    Hertfordshire
    Richard Patrick Brewer
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Praticante
    25 Farringdon Street
    EC4A 4AB London
    Christopher Cooke
    The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Praticante
    The Pinnacle 170 Midsummer Boulevard
    MK9 1BP Milton Keynes
    Buckinghamshire

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0