AVONMOUTH BIO POWER CONTRACTING LIMITED

AVONMOUTH BIO POWER CONTRACTING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAVONMOUTH BIO POWER CONTRACTING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 07061917
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AVONMOUTH BIO POWER CONTRACTING LIMITED?

    • Altre attività di servizi n.c.a. (96090) / Altre attività di servizi

    Dove si trova AVONMOUTH BIO POWER CONTRACTING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Blythe House Blythe Park
    Cresswell
    ST11 9RD Stoke-On-Trent
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AVONMOUTH BIO POWER CONTRACTING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NEAT CONTRACTING LIMITED13 ago 201213 ago 2012
    NEE (CANFORD) LIMITED30 ott 200930 ott 2009

    Quali sono gli ultimi bilanci di AVONMOUTH BIO POWER CONTRACTING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 lug 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per AVONMOUTH BIO POWER CONTRACTING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Iscrizione dell'ipoteca 070619170002, creata il 10 dic 2019

    39 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 lug 2018

    4 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 ago 2018 al 31 lug 2018

    1 pagineAA01

    Cessazione della carica di Mark Stephen Scobie come amministratore in data 01 nov 2018

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 ago 2017

    16 pagineAA

    Modifica dei dettagli di Avonmouth Bio Power Limited come persona con controllo significativo il 23 apr 2018

    2 paginePSC05

    Nomina di Mr Ian Young Miller come amministratore in data 29 mar 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Pike come amministratore in data 29 mar 2018

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Ian Charles Brooking il 25 ott 2017

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 ago 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 3rd Floor 86 Brook Street London W1K 5AY a Blythe House Blythe Park Cresswell Stoke-on-Trent ST11 9rd in data 12 lug 2017

    1 pagineAD01

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 3rd Floor 86 Brook Street London W1K 5AY

    1 pagineAD04

    I registri sono stati trasferiti all'indirizzo della sede legale registrata 3rd Floor 86 Brook Street London W1K 5AY

    1 pagineAD04

    Bilancio redatto al 31 ago 2016

    17 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 gen 2017 al 31 ago 2016

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Navyjot Singh Dhillon il 08 feb 2017

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 gen 2016

    19 pagineAA

    Nomina di Mr Steven Wim Blase come amministratore in data 21 set 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Hamish Mcpherson come amministratore in data 21 set 2016

    1 pagineTM01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da 3rd Floor 86 Brook Street London W1K 5AY England a Blythe House Blythe Park Cresswell Stoke-on-Trent ST11 9rd

    1 pagineAD02

    Chi sono gli amministratori di AVONMOUTH BIO POWER CONTRACTING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BLASE, Steven Wim
    Blythe Park
    Cresswell
    ST11 9RD Stoke-On-Trent
    Blythe House
    England
    Amministratore
    Blythe Park
    Cresswell
    ST11 9RD Stoke-On-Trent
    Blythe House
    England
    EnglandDutchDirector201676280001
    BROOKING, Ian Charles
    10 Thornbury Road
    Estover
    PL6 7PP Plymouth
    Airport Business Centre
    England
    Amministratore
    10 Thornbury Road
    Estover
    PL6 7PP Plymouth
    Airport Business Centre
    England
    EnglandBritishCompany Director170505190011
    DHILLON, Navjyot Singh
    Blythe Park
    Cresswell
    ST11 9RD Stoke-On-Trent
    Blythe House
    England
    Amministratore
    Blythe Park
    Cresswell
    ST11 9RD Stoke-On-Trent
    Blythe House
    England
    EnglandBritishDirector165785520002
    MILLER, Ian Young
    Blythe Park
    Cresswell
    ST11 9RD Stoke-On-Trent
    Blythe House
    England
    Amministratore
    Blythe Park
    Cresswell
    ST11 9RD Stoke-On-Trent
    Blythe House
    England
    EnglandBritishDirector207174270001
    JONES, Michael Adrian
    Shaftesbury Drove
    West Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    3
    Wiltshire
    United Kingdom
    Segretario
    Shaftesbury Drove
    West Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    3
    Wiltshire
    United Kingdom
    146591520001
    SHORE, Adam
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    Segretario
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    179347780001
    STOCKLEY, Darren
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    Segretario
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    British61712020003
    QUAYSECO LIMITED
    Glass Wharf
    BS2 0ZX Bristol
    One
    United Kingdom
    Segretario
    Glass Wharf
    BS2 0ZX Bristol
    One
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione02287256
    146837890001
    ASQUITH, Robert James
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    Amministratore
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    EnglandBritishDirector179363590002
    BOOTH, Matthew James Spencer
    Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    28
    England
    Amministratore
    Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    28
    England
    United KingdomBritishBanker167345030001
    COX, Christopher Marthinus
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    Amministratore
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    United KingdomBritishNone40846350001
    FOGG, Jonathan
    Brook Street
    W1K 5AY London
    86
    England
    Amministratore
    Brook Street
    W1K 5AY London
    86
    England
    United KingdomBritishAccountant179320770001
    GOLDEN, Peter Henry
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    Amministratore
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    United KingdomBritishDirector70095920001
    GOULD, Karen Angela
    Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    28
    England
    Amministratore
    Ropemaker Street
    EC2Y 9HD London
    28
    England
    EnglandAustralianBanker199815820001
    HOLDER, Jeff James
    86 Brook Street
    W1K 5AY London
    3rd Floor
    England
    Amministratore
    86 Brook Street
    W1K 5AY London
    3rd Floor
    England
    United KingdomBritishDirector199815490001
    JONES, Adrian
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    Amministratore
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    United KingdomBritishChartered Accountant179347520001
    JONES, Michael Adrian
    Shaftesbury Drove
    West Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    3
    Wiltshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Shaftesbury Drove
    West Harnham
    SP2 8QH Salisbury
    3
    Wiltshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone77984700001
    MCPHERSON, Robert Hamish
    86 Brook Street
    W1K 5AY London
    3rd Floor
    England
    Amministratore
    86 Brook Street
    W1K 5AY London
    3rd Floor
    England
    United KingdomBritishDirector147882310002
    PIKE, David
    Brook Street
    W1K 5AY London
    3rd Floor, 86
    England
    Amministratore
    Brook Street
    W1K 5AY London
    3rd Floor, 86
    England
    EnglandBritishCompany Director106763630001
    RIDDLE, William Edward
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    Amministratore
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    United KingdomBritishDirector99835970001
    SCOBIE, Mark Stephen
    Arena Way
    Magna Road
    BH21 3BW Wimborne
    Energy Site Control Centre
    Dorset
    England
    Amministratore
    Arena Way
    Magna Road
    BH21 3BW Wimborne
    Energy Site Control Centre
    Dorset
    England
    United KingdomBritishCompany Director2047810012
    SCOBIE, Mark Stephen
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    Amministratore
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    United KingdomBritishNone2047810012
    SHORE, Adam
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    Amministratore
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    United KingdomBritishCompany Director179347510001
    STOCKLEY, Darren
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    Amministratore
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    United KingdomBritishCompany Secretary61712020003
    STOCKLEY, Darren
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    Amministratore
    35 Black Moor Road
    Ebblake Industrial Estate
    BH31 6AT Verwood
    Key House
    Dorset
    United KingdomBritishDirector61712020003
    WHITAKER, David John
    Brook Street
    W1K 5AY London
    86
    England
    Amministratore
    Brook Street
    W1K 5AY London
    86
    England
    EnglandBritishDirector95502600001

    Chi sono le persone con controllo significativo di AVONMOUTH BIO POWER CONTRACTING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Avonmouth Bio Power Limited
    Blythe Park
    Cresswell
    ST11 9RD Stoke On Trent
    Blythe House
    Staffordshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Blythe Park
    Cresswell
    ST11 9RD Stoke On Trent
    Blythe House
    Staffordshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House England & Wales
    Numero di registrazione09626128
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    AVONMOUTH BIO POWER CONTRACTING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 10 dic 2019
    Consegnato il 13 dic 2019
    In corso
    Breve descrizione
    All estates and interests in freehold, leasehold and other immovable property (wherever situated) now or in future belonging to the chargor, or in which the chargor has an interest at any time, together with all buildings at any time thereon;. And. All legal and/or equitable interests (including, without limitation, the benefit of all licences in any part of the world) of the chargor in, or relating to: any patents, trade marks, service marks, designs, business names, copyrights, database rights, design rights, domain names, moral rights, inventions, confidential information, know-how and other intellectual property rights and interests (which may now or in the future subsist), whether registered or unregistered; and (b) the benefit of all applications and rights to use such assets of the chargor (which may now or in the future subsist). For further information please see the charging instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Aurium Energy Finance Limited
    Transazioni
    • 13 dic 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 25 lug 2015
    Consegnato il 01 ago 2015
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Aurium Energy Finance Limited
    Transazioni
    • 01 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0