RMD TRAFFORD HOUSE 2000 LIMITED

RMD TRAFFORD HOUSE 2000 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàRMD TRAFFORD HOUSE 2000 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 07146101
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di RMD TRAFFORD HOUSE 2000 LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova RMD TRAFFORD HOUSE 2000 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    BEGBIES TRAYNOR (CENTRAL) LLP
    4th Floor Cathedral Buildings Dean Street
    NE1 1PG Newcastle Upon Tyne
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di RMD TRAFFORD HOUSE 2000 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    COLONNADE MMH (TRAFFORD HOUSE) LIMITED04 feb 201004 feb 2010

    Quali sono gli ultimi bilanci di RMD TRAFFORD HOUSE 2000 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per RMD TRAFFORD HOUSE 2000 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per RMD TRAFFORD HOUSE 2000 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    13 pagine4.71

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Indirizzo della sede legale modificato da 4 Manchester Square London W1A 1AU a 4th Floor Cathedral Buildings Dean Street Newcastle upon Tyne NE1 1PG in data 30 lug 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 lug 2015

    LRESSP

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2014

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 apr 2015

    Stato del capitale al 02 apr 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michele Luzi il 02 feb 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Clifford Jackson il 02 feb 2015

    2 pagineCH01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 mar 2014 al 29 mar 2014

    1 pagineAA01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2014 al 30 mar 2014

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 feb 2014

    Stato del capitale al 28 feb 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Richard Sandor Frischmann il 01 feb 2014

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 28 feb 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Godfrey Bradman come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    12 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2011 al 31 mar 2012

    1 pagineAA01

    legacy

    5 pagineMG01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 29 feb 2012 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed colonnade mmh (trafford house) LIMITED\certificate issued on 29/02/12
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name29 feb 2012

    Risoluzione di cambio di nome della società il 10 feb 2012

    RES15
    change-of-name29 feb 2012

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Chi sono gli amministratori di RMD TRAFFORD HOUSE 2000 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FRISCHMANN, Richard Sandor
    Dean Street
    NE1 1PG Newcastle Upon Tyne
    4th Floor Cathedral Buildings
    Amministratore
    Dean Street
    NE1 1PG Newcastle Upon Tyne
    4th Floor Cathedral Buildings
    EnglandBritish148991010001
    JACKSON, David Clifford
    Dean Street
    NE1 1PG Newcastle Upon Tyne
    4th Floor Cathedral Buildings
    Amministratore
    Dean Street
    NE1 1PG Newcastle Upon Tyne
    4th Floor Cathedral Buildings
    EnglandBritish146695910001
    LUZI, Michele
    Dean Street
    NE1 1PG Newcastle Upon Tyne
    4th Floor Cathedral Buildings
    Amministratore
    Dean Street
    NE1 1PG Newcastle Upon Tyne
    4th Floor Cathedral Buildings
    EnglandItalian47188570002
    BRADMAN, Godfrey Michael
    Berkeley Street
    W1J 8DJ London
    1
    Amministratore
    Berkeley Street
    W1J 8DJ London
    1
    United KingdomBritish2068500004
    DODDS, Graeme James
    Second Avenue
    CO13 9ER Frinton-On-Sea
    16
    Essex
    Amministratore
    Second Avenue
    CO13 9ER Frinton-On-Sea
    16
    Essex
    EnglandBritish146495490001

    RMD TRAFFORD HOUSE 2000 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 21 mag 2012
    Consegnato il 25 mag 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a trafford house 8 station way basildon by way of fixed charge all estates and interests in any f/h and l/h and other property and all trade and other fixtures, all plant and machinery vehicles computers and office and other equipment, all stocks shares debenture bonds notes and loan capital and by way of floating charge the whole of the undertaking and property assets and rights whatsoever present and future.
    Persone aventi diritto
    • Pell Frischmann Group Limited
    Transazioni
    • 25 mag 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 ott 2010
    Consegnato il 30 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Trafford house 8 station way basildon t/n EX231265, fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Property Finance Nominees (No.3) Limited
    Transazioni
    • 30 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 18 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Fixed charge
    Creato il 28 set 2010
    Consegnato il 12 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the chargor's right title and interest from time to time in to and under each of the following present and future assets, the real property all rents receivable and the benefit of all guarantees indemnities rent deposits agreements undertakings and warranties relating to the same see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Many More Homes Limited
    Transazioni
    • 12 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 23 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 05 feb 2010
    Consegnato il 12 feb 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Trafford house, 8 station way basildon essex t/no EX231265 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Rmd Trafford House LLP
    Transazioni
    • 12 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 ott 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    RMD TRAFFORD HOUSE 2000 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 lug 2015Inizio della liquidazione
    16 set 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gillian Margaret Sayburn
    4th Floor Cathedral Buildings Dean Street
    NE1 1PG Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Praticante
    4th Floor Cathedral Buildings Dean Street
    NE1 1PG Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Gerald Maurice Krasner
    Begbies Traynor (Central) Llp 4th Floor Cathedral Buildings
    Dean Street
    NE1 1PG Newcastle Upon Tyne
    Praticante
    Begbies Traynor (Central) Llp 4th Floor Cathedral Buildings
    Dean Street
    NE1 1PG Newcastle Upon Tyne

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0