MPG HOSPITAL PROPERTIES LIMITED

MPG HOSPITAL PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMPG HOSPITAL PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 07179949
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MPG HOSPITAL PROPERTIES LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova MPG HOSPITAL PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Asticus Building
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MPG HOSPITAL PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per MPG HOSPITAL PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    5 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 05 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 mar 2016

    Stato del capitale al 31 mar 2016

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Jeremy Michael Jorgen Malherbe Jensen il 16 dic 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Farhad Mawji Karim il 16 dic 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sanne Group Secretaries (Uk) Limited il 31 lug 2015

    1 pagineCH04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    15 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP a Asticus Building 21 Palmer Street London SW1H 0AD in data 16 dic 2015

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 1 in parte

    4 pagineMR04

    Secondo deposito di TM01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio

    4 pagineRP04
    Note
    DataNota
    13 lug 2015Clarification Second filing TM01 for Nicholas Leslau

    Secondo deposito di TM01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio

    4 pagineRP04
    Note
    DataNota
    13 lug 2015Clarification Second filing TM01 for Sandra Gumm

    Secondo deposito di AP01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio

    5 pagineRP04
    Note
    DataNota
    13 lug 2015Clarification Second filing AP01 for Farhad Karim

    Secondo deposito di AP01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio

    5 pagineRP04
    Note
    DataNota
    13 lug 2015Clarification Second filing AP01 for Michael Pegler

    Secondo deposito di AP04 precedentemente inviato alla Camera di Commercio

    5 pagineRP04
    Note
    DataNota
    13 lug 2015Clarification second filing AP04 for Sanne Group Secretaries (UK) Limited

    Nomina di Mr James Robert Lock come amministratore in data 13 apr 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael John Pegler come amministratore in data 13 apr 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 05 mar 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 mar 2015

    Stato del capitale al 31 mar 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP England a Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP in data 23 gen 2015

    1 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da 40 Berkeley Square London W1J 5AL England a Pollen House 10 Cork Street London W1S 3NP in data 23 gen 2015

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2014

    15 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MPG HOSPITAL PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SANNE GROUP SECRETARIES (UK) LIMITED
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building
    England
    Segretario
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione8334728
    175738460001
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building
    England
    Amministratore
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building
    England
    EnglandBritishConsultant108268030003
    KARIM, Farhad Mawji
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building
    England
    Amministratore
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building
    England
    United KingdomCanadianManaging Director And Coo150892980001
    LOCK, James Robert
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building
    England
    Amministratore
    21 Palmer Street
    SW1H 0AD London
    Asticus Building
    England
    EnglandBritishManaging Director195412690001
    TAYLOR WESSING SECRETARIES LIMITED
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Segretario
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04328885
    84071220002
    BURKE, Paul Simon
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone125660320002
    GUMM, Sandra Louise
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    Pollen House
    Amministratore
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    Pollen House
    EnglandAustralianChartered Accountant57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    Amministratore
    Berkeley Square
    W1J 5AL London
    40
    England
    United KingdomBritishChartered Surveyor6815470021
    PEGLER, Michael John
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    Pollen House
    Amministratore
    10 Cork Street
    W1S 3NP London
    Pollen House
    EnglandBritishManaging Director113065790004
    SCHNIDER, Jayne Elizabeth
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor125660760002
    HUNTSMOOR LIMITED
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2185097
    145994510001
    HUNTSMOOR NOMINEES LIMITED
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Amministratore
    New Street Square
    EC4A 3TW London
    5
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione637246
    145994520001

    MPG HOSPITAL PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Standard security executed on 28 may 2010
    Creato il 03 giu 2010
    Consegnato il 18 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole that plot or area of ground lying in the parish and county of ayr and forming part of glenparks farm ayr t/no AYR82396. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 18 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Standard security executed on 28 may 2010
    Creato il 03 giu 2010
    Consegnato il 18 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole subjects k/a kings park hospital, polmaise road, stirling t/no STG19544.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 18 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rental income
    Creato il 28 mag 2010
    Consegnato il 14 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All sums payable to or for the benefit of propco under or in connection with the leases and each of its call option rights.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transazioni
    • 14 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 mag 2010
    Consegnato il 10 giu 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 10 giu 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 27 ago 2015Soddisfazione parziale di un'ipoteca (MR04)
    • 05 feb 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0