DUNEDIN UK INDUSTRIAL PROPERTY NOMINEE 7 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | DUNEDIN UK INDUSTRIAL PROPERTY NOMINEE 7 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 07404597 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DUNEDIN UK INDUSTRIAL PROPERTY NOMINEE 7 LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
- Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
Dove si trova DUNEDIN UK INDUSTRIAL PROPERTY NOMINEE 7 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 89 Wardour Street W1F 0UB London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DUNEDIN UK INDUSTRIAL PROPERTY NOMINEE 7 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| COLUMBUS INDUSTRIAL NOMINEE LIMITED | 12 ott 2010 | 12 ott 2010 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DUNEDIN UK INDUSTRIAL PROPERTY NOMINEE 7 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DUNEDIN UK INDUSTRIAL PROPERTY NOMINEE 7 LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per DUNEDIN UK INDUSTRIAL PROPERTY NOMINEE 7 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Samuel Andrew Walker come amministratore in data 13 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 12 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Sanjay Sethi come amministratore in data 07 ott 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Memorandum e Statuto | 15 pagine | MA | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 074045970004, creata il 12 mag 2015 | 74 pagine | MR01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Ana-Maria Florina Capraru come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Ana-Maria Florina Capraru come amministratore in data 10 mag 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Sanjay Sethi come amministratore in data 07 mag 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Samuel Andrew Walker come amministratore in data 05 feb 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Charles Richard De Lusignan come amministratore in data 05 feb 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed columbus industrial nominee LIMITED\certificate issued on 10/12/14 | 3 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr James Charles Richard De Lusignan come amministratore in data 03 dic 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Daniel Marks come amministratore in data 03 dic 2014 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Schroders Corporate Secretary Limited come segretario in data 03 dic 2014 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Nicole Bell come amministratore in data 03 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Melinda Lu San Knatchbull come amministratore in data 03 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Laurence John Scott Dowling come amministratore in data 03 dic 2014 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di DUNEDIN UK INDUSTRIAL PROPERTY NOMINEE 7 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPRARU, Ana-Maria Florina | Amministratore | Wardour Street W1F 0UB London 89 England | England | British | 197537490001 | |||||||||
| MARKS, Michael Daniel | Amministratore | Wardour Street W1F 0UB London 89 England | United Kingdom | British | 155565220003 | |||||||||
| HORTON, Helen Marie | Segretario | Gresham Street EC2V 7QA London 31 United Kingdom | 154803360001 | |||||||||||
| STONER, Melanie | Segretario | Gresham Street EC2V 7QA London 31 United Kingdom | 154803350002 | |||||||||||
| SCHRODERS CORPORATE SECRETARY LIMITED | Segretario | Gresham Street EC2V 7QA London 31 England |
| 169523680001 | ||||||||||
| BELL, Nicole | Amministratore | Wardour Street W1F 0UB London 89 England | England | British | 186277340001 | |||||||||
| DE LUSIGNAN, James Charles Richard | Amministratore | Wardour Street W1F 0UB London 89 England | England | British | 176774780001 | |||||||||
| DOWLING, Laurence John Scott | Amministratore | Gresham Street EC2V 7QA London 31 England | England | British | 174404330001 | |||||||||
| GRIFFITHS, Peter John | Amministratore | Gresham Street EC2V 7QA London 31 United Kingdom | United Kingdom | British | 131089730001 | |||||||||
| KNATCHBULL, Melinda Lu San | Amministratore | Wardour Street W1F 0UB London 89 England | United Kingdom | British | 183979180001 | |||||||||
| LEES, Roger Alan | Amministratore | Gresham Street EC2V 7QA London 31 United Kingdom | United Kingdom | British | 150439720001 | |||||||||
| ROANTREE, Gillian Anne | Amministratore | Gresham Street EC2V 7QA London 31 United Kingdom | Jersey | Irish | 104671800001 | |||||||||
| SETHI, Sanjay | Amministratore | Wardour Street W1F 0UB London 89 England | England | British | 183030370001 | |||||||||
| WALKER, Samuel Andrew | Amministratore | Wardour Street W1F 0UB London 89 England | United Kingdom | British | 60019040003 |
DUNEDIN UK INDUSTRIAL PROPERTY NOMINEE 7 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 12 mag 2015 Consegnato il 19 mag 2015 | In corso | ||
Breve descrizione The full circle business centre (f/h title BK248095) and beadle trading estate (f/h title CB74009) please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged. L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 12 mar 2013 Consegnato il 16 mar 2013 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari F/H properties k/a eskdale road industrial estate uxbridge t/n NGL284682, 51, 53, 55 and 57 riverside way cowley uxbridge t/n NGL383803 and l/h property k/a enterprise way 14 maxted close hemel hempstead t/n HD395856 (for further properties charged please refer to form MG01), all plant, machinery, computers, office equipment or vehicles and all rental income see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal charge | Creato il 03 ago 2012 Consegnato il 10 ago 2012 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first legal mortgage, the whole of its right title benefit and interest in and to each charged property, plant machinery, f/h property k/a roundthorn industrial estate, floats road, wythenshawe manchester being the whole of the land under t/no's GM132833 and LA299227. F/h property k/a beadle trading estate, ditton walk, cambridge being the whole of the land under t/no CB74009. F/h property k/a kingsmead industrial estate, princess elizabeth way, cheltenham being the whole of the land under t/no GR159662 and f/h property k/a parkfield industrial estate, culvert road, battersea, london being the whole of the land under t/no TGL117827. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 lug 2011 Consegnato il 04 ago 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari (For details of actual properties charged, please refer to the form MG01); fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, plant & machinery. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0