JUPITER ACQUISITIONS LIMITED

JUPITER ACQUISITIONS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJUPITER ACQUISITIONS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 07577857
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JUPITER AQUISITIONS LIMITED24 mar 201124 mar 2011

    Quali sono gli ultimi bilanci di JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    12 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 16 dic 2021

    9 pagineLIQ03

    Cessazione della carica di David Huw Griffiths come amministratore in data 02 mar 2021

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Connect House 133-137 Alexandra Road Wimbledon London SW19 7JY

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Connect House 133-137 Alexandra Road Wimbledon London SW19 7JY

    2 pagineAD02

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 17 dic 2020

    LRESSP

    Indirizzo della sede legale modificato da Connect House 133-137 Alexandra Road Wimbledon London SW19 7JY United Kingdom a 1 More London Place London SE1 2AF in data 04 gen 2021

    2 pagineAD01

    Nomina di Mr Pablo Andres come amministratore in data 01 nov 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Daniel Joseph Guerin come amministratore in data 31 ott 2020

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mark Richard Jones il 25 set 2020

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Daniel Joseph Guerin il 25 set 2020

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Huw Griffiths il 25 set 2020

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Morton Fraser Llp St Martin's House 16 st Martins Le Grand London EC1A 4EN a Connect House 133-137 Alexandra Road Wimbledon London SW19 7JY in data 25 set 2020

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Mobius Wind Holdings Limited come persona con controllo significativo il 25 set 2020

    2 paginePSC05

    Cessazione della carica di Morton Fraser Secretaries Limited come segretario in data 25 set 2020

    1 pagineTM02

    Nomina di Burness Paull Llp come segretario in data 25 set 2020

    2 pagineAP04

    Nomina di Mr Daniel Joseph Guerin come amministratore in data 01 gen 2020

    2 pagineAP01

    Nomina di Mark Richard Jones come amministratore in data 01 gen 2020

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 29 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di David Mel Zuydam come amministratore in data 01 gen 2020

    1 pagineTM01

    Notifica di Mobius Wind Holdings Limited come persona con controllo significativo il 15 ago 2019

    2 paginePSC02

    Cessazione di Jupiter Acquisitions (Holdings) Limited come persona con controllo significativo il 15 ago 2019

    1 paginePSC07

    Chi sono gli amministratori di JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BURNESS PAULL LLP
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Segretario
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Forma giuridicaLIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
    Tipo di documento di identificazioneAltra persona giuridica o impresa
    Autorità legaleSCOTLAND, SCOTS LAW
    Numero di registrazioneSO300380
    274632090001
    ANDRES, Pablo
    12 Blenheim Place
    EH7 5JH Edinburgh
    4th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    12 Blenheim Place
    EH7 5JH Edinburgh
    4th Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritish276031210001
    JONES, Mark Richard
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Amministratore
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    ScotlandBritish254843030001
    ATTERBURY, Karen Lorraine
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    Segretario
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    201246140001
    BISSET, Graham Ferguson
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500 Pavilion Drive
    Northamptonshire
    United Kingdom
    Segretario
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500 Pavilion Drive
    Northamptonshire
    United Kingdom
    194566770001
    CALDER, Samantha Jane
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    Segretario
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    British75830790003
    LONG, Jacqueline
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500 Pavilion Drive
    United Kingdom
    Segretario
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500 Pavilion Drive
    United Kingdom
    204213400001
    MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED
    2 Lister Square
    Quartermile Two
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor
    Scotland
    Segretario
    2 Lister Square
    Quartermile Two
    EH3 9GL Edinburgh
    5th Floor
    Scotland
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazioneSC262093
    95512800001
    AIKMAN, Elizabeth Jane
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    England
    Amministratore
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    England
    EnglandBritish294355310001
    BOYD, Gordon Alexander
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    Amministratore
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    EnglandBritish148856600001
    BROWN, Katerina
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    Amministratore
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    ScotlandBritish232165890001
    GIBBINS, Stewart Charles
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    England
    Amministratore
    500 Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor
    England
    United KingdomBritish148918290002
    GREGSON, Paul Jonathan
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    Amministratore
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    EnglandBritish154908310001
    GRIFFITHS, David Huw
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Amministratore
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    United KingdomBritish177733400003
    GUERIN, Daniel Joseph
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    Amministratore
    Lothian Road
    Festival Square
    EH3 9WJ Edinburgh
    50
    Scotland
    EnglandIrish210311660001
    HARDMAN, Steven Neville
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    Amministratore
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    UkBritish93743250007
    HINTON, Thomas Edward
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    Amministratore
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    United KingdomBritish238940970001
    LEE, Andrew William
    St. Martin's House
    16 St. Martin's Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    United Kingdom
    Amministratore
    St. Martin's House
    16 St. Martin's Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    United Kingdom
    United KingdomBritish87527870001
    MACHIELS, Eric Philippe Marianne
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    Amministratore
    Pavilion Drive
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor 500
    England
    EnglandBelgian125748990002
    MACKENZIE, Scott Leitch
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    Amministratore
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    United KingdomBritish277478140001
    NAGLE, Michael
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    Amministratore
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    United KingdomBritish29436380007
    PICKERING, Stephen Shane
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    Amministratore
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    United KingdomBritish198076630001
    WALTERS, Mark Alan
    Victoria Embankment
    EC4Y 0JP London
    60
    United Kingdom
    Amministratore
    Victoria Embankment
    EC4Y 0JP London
    60
    United Kingdom
    EnglandBritish317548840001
    WINTER, Robert Guy Stewart
    10 St Paul's Churchyard
    EC4M 8AL London
    Condor House
    England
    Amministratore
    10 St Paul's Churchyard
    EC4M 8AL London
    Condor House
    England
    EnglandBritish158816660001
    ZUYDAM, David Mel
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    Amministratore
    St Martin's House
    16 St Martins Le Grand
    EC1A 4EN London
    C/O Morton Fraser Llp
    EnglandBritish259635370001

    Chi sono le persone con controllo significativo di JUPITER ACQUISITIONS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mobius Wind Holdings Limited
    133-137 Alexandra Road
    Wimbledon
    SW19 7JY London
    Connect House
    United Kingdom
    15 ago 2019
    133-137 Alexandra Road
    Wimbledon
    SW19 7JY London
    Connect House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione07086998
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    06 apr 2016
    Northampton Business Park
    NN4 7YJ Northampton
    First Floor, 500 Pavilion Drive
    England
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07578959
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    JUPITER ACQUISITIONS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 18 dic 2017
    Consegnato il 20 dic 2017
    In corso
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 20 dic 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 15 dic 2017
    Consegnato il 29 dic 2017
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC, 4TH Floor, Citymark, 150 Fountainbridge, Edinburgh, EH3 9PE, United Kingdom as Security Trustee (As Trustee for Each of the Secured Creditors)
    Transazioni
    • 29 dic 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 10 ott 2013
    Consegnato il 17 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 17 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 ott 2013
    Consegnato il 17 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 17 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 10 ott 2013
    Consegnato il 17 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 17 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 09 ott 2013
    Consegnato il 11 ott 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 dic 2017Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    A registered charge
    Creato il 09 ott 2013
    Consegnato il 11 ott 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Intellectual property. The chargor charges, by way of first fixed charge, all of the rights which it now has and all of the rights which it obtains at any time in the future in intellectual property.. Intellectual property means:. (A) all copyright (including rights in computer software), patents, trade marks, trade names, service marks, business names (including internet domain names), design rights, database rights, semi-conductor topography rights and all other intellectual property or similar proprietary rights (whether registered or not and including applications to register or rights to apply for registration) which, in each case, are of a type which are not disposed of in the ordinary course of trading;. (B) any intellectual property that supplements or replaces intellectual property described in (a) above; and. (C) any intellectual property acquired after the date of this deed which is designated as intellectual property by a chargor and the security agent at or about the time of its acquisition. Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 18 dic 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of pledge
    Creato il 14 apr 2011
    Consegnato il 03 mag 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from minsca windfarm (scotland) limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The secured assets being the existing shares, the further shares and the related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 03 mag 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of pledge
    Creato il 14 apr 2011
    Consegnato il 21 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The secured assets being the existing shares, the future shares and the related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of pledge
    Creato il 14 apr 2011
    Consegnato il 21 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from dalswinton windfarm (scotland) limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The secured assets being the existing shares, the future shares and the related rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over shares
    Creato il 14 apr 2011
    Consegnato il 19 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge any shares and any rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transazioni
    • 19 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over shares
    Creato il 14 apr 2011
    Consegnato il 19 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge the shares and any rights see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Securtiy Trustee")
    Transazioni
    • 19 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 13 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over shares
    Creato il 14 apr 2011
    Consegnato il 19 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares in slieve divena wind farm limited and any rights including dividends, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 apr 2011
    Consegnato il 15 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from minsca windfarm (scotland) limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, all copyright, plant and machinery, the specified key accounts. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 apr 2011
    Consegnato il 15 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, all copyright, plant and machinery, the specified key accounts. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 apr 2011
    Consegnato il 15 apr 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from dalswinton windfarm (scotland) limited on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all assets present and future, including goodwill, uncalled capital, all copyright, plant and machinery, the specified key accounts. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 15 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 17 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    JUPITER ACQUISITIONS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    12 mar 2023Data prevista di scioglimento
    17 dic 2020Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Matthew Coomber
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Derek Hyslop
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0