COLONIAL CAPITAL LTD

COLONIAL CAPITAL LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCOLONIAL CAPITAL LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 07849082
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di COLONIAL CAPITAL LTD?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova COLONIAL CAPITAL LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Causeway House
    1 Dane Street
    CM23 3BT Bishop's Stortford
    Hertfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di COLONIAL CAPITAL LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per COLONIAL CAPITAL LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    12 pagineLIQ14

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2022

    14 pagineLIQ03

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:Secretary of state's release of liquidator.
    1 pagineLIQ MISC

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2021

    19 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    14 pagineLIQ10

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:sec of state release of liquidator
    1 pagineLIQ MISC

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    14 pagineLIQ10

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Cessazione della carica di Kevin Anthony Neil come amministratore in data 25 nov 2016

    1 pagineTM01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2020

    16 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 7th Floor Dashwood House 69 Old Broad Street London EC2M 1QS a Causeway House 1 Dane Street Bishop's Stortford Hertfordshire CM23 3BT in data 30 set 2020

    2 pagineAD01

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2019

    17 pagineLIQ03

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 07 nov 2018

    20 pagineLIQ03

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    20 pagineAM22

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    19 pagineAM10

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    34 pagine2.17B

    Certificato modificato di costituzione del comitato dei creditori

    1 pagine2.26B

    Certificato modificato di costituzione del comitato dei creditori

    1 pagine2.26B

    Risultato della riunione dei creditori

    2 pagine2.23B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    13 pagine2.16B

    Risultato della riunione dei creditori

    2 pagine2.23B

    Indirizzo della sede legale modificato da Suite 14 the Aquarium 101 Lower Anchor Street Chelmsford Essex CM2 0AU a 7th Floor Dashwood House 69 Old Broad Street London EC2M 1QS in data 15 dic 2016

    2 pagineAD01

    Chi sono gli amministratori di COLONIAL CAPITAL LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHUTTLEWORTH, Peter Leonard
    101 Lower Anchor Street
    CM2 0AU Chelmsford
    Suite 14 The Aquarium
    Essex
    England
    Amministratore
    101 Lower Anchor Street
    CM2 0AU Chelmsford
    Suite 14 The Aquarium
    Essex
    England
    United KingdomBritish142377950002
    MESSENGER, Iain Ernest Bradley
    The Aquarium
    101 Lower Anchor Street
    CM2 0AU Chelmsford
    Suite 14
    Essex
    England
    Amministratore
    The Aquarium
    101 Lower Anchor Street
    CM2 0AU Chelmsford
    Suite 14
    Essex
    England
    EnglandBritish290808400001
    NEIL, Kevin Anthony
    1 Dane Street
    CM23 3BT Bishop's Stortford
    Causeway House
    Hertfordshire
    Amministratore
    1 Dane Street
    CM23 3BT Bishop's Stortford
    Causeway House
    Hertfordshire
    EnglandBritish70381820002

    Chi sono le persone con controllo significativo di COLONIAL CAPITAL LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Kevin Anthony Neil
    1 Dane Street
    CM23 3BT Bishop's Stortford
    Causeway House
    Hertfordshire
    07 apr 2016
    1 Dane Street
    CM23 3BT Bishop's Stortford
    Causeway House
    Hertfordshire
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    COLONIAL CAPITAL LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 10 feb 2014
    Consegnato il 13 feb 2014
    In corso
    Breve descrizione
    All assets, property and undertaking for the time being subject to any security created by this deed.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Each of the Persons Holding, from Time to Time, Any Bond or Note Issued by the Company
    Transazioni
    • 13 feb 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 08 gen 2014
    Consegnato il 08 gen 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Leena Mewasingh
    • Daniel Centeno
    • Lung Chieh Yu
    • Wang Szu Yung
    Transazioni
    • 08 gen 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • Più di quattro persone aventi diritto
    A registered charge
    Creato il 08 gen 2014
    Consegnato il 08 gen 2014
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • John Riley
    Transazioni
    • 08 gen 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 10 dic 2013
    Consegnato il 10 dic 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Nataliya Nazarova
    • Ninel Chernykh
    Transazioni
    • 10 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 09 dic 2013
    Consegnato il 09 dic 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Tamas Csejtei
    • Richard James
    Transazioni
    • 09 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 09 dic 2013
    Consegnato il 09 dic 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Ian Smith
    • Howard Smith
    • Hsu Hsin Wen
    • Peter Tyler
    Transazioni
    • 09 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • Più di quattro persone aventi diritto
    A registered charge
    Creato il 13 nov 2013
    Consegnato il 13 nov 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Melody Fitsall
    • George Meulen
    • Diana Price
    Transazioni
    • 13 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 13 nov 2013
    Consegnato il 13 nov 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Timothy House
    • Alan Martin
    • Shashikant Patel
    • David Lawrie
    Transazioni
    • 13 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • Più di quattro persone aventi diritto
    A registered charge
    Creato il 13 nov 2013
    Consegnato il 13 nov 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Lee Ay Shyuan
    • Lee Ay Shyuan
    • Geoffrey Dodge
    • Daniel Cabrera
    Transazioni
    • 13 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • Più di quattro persone aventi diritto
    A registered charge
    Creato il 07 nov 2013
    Consegnato il 07 nov 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Mr Ian Mccandless
    • Mr William Burey
    • Mr Andrew Barnes
    • Mr Ian Jobson
    Transazioni
    • 07 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • Più di quattro persone aventi diritto
    A registered charge
    Creato il 07 nov 2013
    Consegnato il 07 nov 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Liu Mei Hueng
    Transazioni
    • 07 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 05 nov 2013
    Consegnato il 05 nov 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Nichola Irwin
    • David Sims
    • David Halliwell
    • Trevor Lucas
    Transazioni
    • 05 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • Più di quattro persone aventi diritto
    A registered charge
    Creato il 24 ott 2013
    Consegnato il 24 ott 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Mr Ronald Suttleworth
    • Mrs Yvonne Shuttleworth
    Transazioni
    • 24 ott 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 12 lug 2013
    Consegnato il 31 lug 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Ms Chen Xin
    Transazioni
    • 31 lug 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 20 giu 2013
    Consegnato il 20 giu 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Dr & Mrs Dilip Gandhi
    Transazioni
    • 20 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 15 giu 2013
    Consegnato il 19 giu 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Kelsombee Wilson
    • Claire Lloyd Vine
    • Chieh-Yu Lung
    Transazioni
    • 19 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 07 giu 2013
    Consegnato il 19 giu 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Hong Tan Yee
    • Sylvia Griffiths
    Transazioni
    • 19 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 19 giu 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Ay-Shyuan Lee
    • Jie Liang
    • Fabrice Laureti
    • Resham Chand
    Transazioni
    • 19 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • Più di quattro persone aventi diritto
    A registered charge
    Creato il 20 mag 2013
    Consegnato il 03 giu 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Neville Oakes
    • William Burey
    • Jeffrey Benton
    • Charles Marsh
    Transazioni
    • 03 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 apr 2013
    Consegnato il 03 mag 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Jonathan Wang
    • Louise Orpin
    • George Rothschild
    • Glynn Nash
    Transazioni
    • 03 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • Più di quattro persone aventi diritto
    A registered charge
    Creato il 30 apr 2013
    Consegnato il 03 mag 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Ay-Shuan Lee
    • Toi Lam
    Transazioni
    • 03 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 apr 2013
    Consegnato il 03 mag 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Paula Gladden
    • Claire Leech
    • John Woodward
    Transazioni
    • 03 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 apr 2013
    Consegnato il 03 mag 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Adrian Clark
    Transazioni
    • 03 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 30 apr 2013
    Consegnato il 03 mag 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Simon Wise
    Transazioni
    • 03 mag 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Deed of floating charge
    Creato il 05 apr 2013
    Consegnato il 13 apr 2013
    In corso
    Importo garantito
    £180,000 due or to become due
    Brevi particolari
    Assets of colonial capital limited UK from time to time.
    Persone aventi diritto
    • Heather Button, Marco Capaldi and Anthony Ellis for Further Details of Mortgagees Please See Form MG01
    Transazioni
    • 13 apr 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)

    COLONIAL CAPITAL LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    25 nov 2016Inizio dell'amministrazione
    08 nov 2017Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul James Pittman
    7th Floor Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Praticante
    7th Floor Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Paul Anthony Higley
    7th Floor Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Praticante
    7th Floor Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    2
    DataTipo
    08 nov 2017Inizio della liquidazione
    22 ott 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul James Pittman
    7th Floor Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Praticante
    7th Floor Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Paul Anthony Higley
    7th Floor Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Praticante
    7th Floor Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Paul James Pittman
    7th Floor Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Praticante
    7th Floor Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Paul Anthony Higley
    7th Floor Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Praticante
    7th Floor Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Stuart Morton
    Anglia House 6 Central Avenue St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrew
    NR7 0HR Norwich
    Praticante
    Anglia House 6 Central Avenue St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrew
    NR7 0HR Norwich
    Matthew Robert Howard
    Anglia House 6 Central Avenue St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrew
    NR7 0HR Norwich
    Praticante
    Anglia House 6 Central Avenue St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrew
    NR7 0HR Norwich

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0