MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD

MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD
    Stato della societàAttiva
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 07983197
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Suez House
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Berkshire
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    SITA SEMBCORP UK HOLDINGS LIMITED26 giu 201326 giu 2013
    SHUKCO 312 LIMITED09 mar 201209 mar 2012

    Quali sono gli ultimi bilanci di MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    ScadutoNo
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2026
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2026
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2025

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    Ultima dichiarazione di conferma redatta al08 mar 2026
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma22 mar 2026
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al08 mar 2025
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Nomina di Mr. Richard Geoffrey Little come amministratore in data 30 nov 2025

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Daniel Geoffrey North come amministratore in data 30 nov 2025

    1 pagineTM01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2025

    38 pagineAA

    Cessazione della carica di Philip Bruce Sheffer come amministratore in data 25 apr 2025

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr. David Anthony Morris come amministratore in data 07 mag 2025

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mar 2025 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr. Iqbal Singh Sidhu il 20 feb 2025

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr. Iqbal Singh Sidhu come amministratore in data 20 feb 2025

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Michael Thomas Patrick come amministratore in data 20 feb 2025

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr. Philip Bruce Sheffer come amministratore in data 20 feb 2025

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Andrew John Cottrell come amministratore in data 31 dic 2024

    1 pagineTM01

    Notifica di Semperian Ppp Investment Partners No.2 Limited come persona con controllo significativo il 15 ago 2024

    2 paginePSC02

    Notifica di Sembcorp Utilities (Pte) Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Notifica di Suez Recycling and Recovery Uk Ltd come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 16 ott 2024

    2 paginePSC09

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2024

    38 pagineAA

    Nomina di Mr. Daniel North come amministratore in data 15 ago 2024

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr. Neil Rae come amministratore in data 15 ago 2024

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kazuma Fukao come amministratore in data 15 ago 2024

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Rahul Dipinkumar Kadiwar come amministratore in data 15 ago 2024

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 08 mar 2024 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr. Andrew John Cottrell come amministratore in data 01 dic 2023

    2 pagineAP01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2023

    37 pagineAA

    Cessazione della carica di Belinda Faith Knox come amministratore in data 01 set 2023

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Rahul Dipinkumar Kadiwar come amministratore in data 01 set 2023

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SUEZ RECYCLING AND RECOVERY UK LTD
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Segretario
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione02291198
    114869260003
    LITTLE, Richard Geoffrey, Mr.
    4th Floor
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian
    England
    Amministratore
    4th Floor
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian
    England
    EnglandBritish151062990002
    MORRIS, David Anthony, Mr.
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Amministratore
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandBritish335522840001
    PADFIELD, Amanda
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish159090300001
    RAE, Neil, Mr.
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    Amministratore
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    United KingdomBritish119437600003
    SIDHU, Iqbal Singh, Mr.
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Amministratore
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    United KingdomBritish332910240001
    THOMPSON, Mark Hedley
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish162837220002
    THORN, Christopher Derrick, Mr.
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish266799220001
    KNIGHT, Joan
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Segretario
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    167385630001
    AHMAD, Nauman
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandPakistani246516040001
    ANNAN, Douglas Stuart, Dr
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish165609970001
    BONE, Dugald John, Dr
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    Amministratore
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    EnglandBritish84834380001
    CHAPRON, Christophe Andre Bernard
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    EnglandFrench122645500003
    CHONG, Kwong Fatt
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    Amministratore
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    SingaporeSingaporean183833580001
    COTTRELL, Andrew John
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Amministratore
    Wilton International
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    United KingdomBritish334057500001
    FUKAO, Kazuma
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Amministratore
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandJapanese308897090001
    GAVIN, Paul
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish159027960001
    HANDS, Stephen Christopher
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    Amministratore
    Wilton Internation
    TS90 8WS Middlesbrough
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    England
    EnglandBritish205116300001
    HIBINO, Tsuneharu
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandJapanese168730210001
    HIGASHIYAMA, Eiichiro
    The Broadgate Tower, 20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd
    England
    Amministratore
    The Broadgate Tower, 20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd
    England
    EnglandJapanese195916850001
    KADIWAR, Rahul Dipinkumar
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd, The Broadgate Tower
    England
    Amministratore
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    I-Environment Investments Ltd, The Broadgate Tower
    England
    EnglandBritish313395690001
    KANAI, Masashi
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Amministratore
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandJapanese282813470002
    KNOX, Belinda Faith
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Amministratore
    20 Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandBritish190578640001
    MCCLAY, Catherine Isabel, Dr
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish245734420001
    MCKENNA-MAYES, Graham Arthur
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish91435430011
    NG, Meng Poh
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    SingaporeSingaporean150975730001
    NORTH, Daniel Geoffrey
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    Amministratore
    1 Gresham Street
    EC2V 7BX London
    Semperian, 4th Floor
    England
    EnglandBritish259587080001
    PALMER-JONES, David Courtenay
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Sita House
    Berkshire
    England
    United KingdomBritish125070620001
    PATRICK, Michael Thomas
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    Amministratore
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    EnglandBritish293354340001
    SCRIMSHAW, Matthew Giles
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    EnglandBritish265146200001
    SEXTON, Ian Anthony
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Amministratore
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    FranceBritish182259120001
    SHEFFER, Philip Bruce, Mr.
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    Amministratore
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar, Cleveland
    Sembcorp Uk Headquarters
    United Kingdom
    EnglandBritish332909490001
    SUZUKI, Yuji
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    Amministratore
    Primrose Street
    EC2A 2EW London
    The Broadgate Tower
    England
    EnglandJapanese236854110002
    THOMPSON, David Keith
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    Amministratore
    Wilton International Manufacturing Site
    TS90 8WS Redcar
    Sembcorp Uk Headquarters
    Cleveland
    United Kingdom
    EnglandBritish265146580001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Gresham Street
    4th Floor
    EC2V 7BX London
    1
    England
    15 ago 2024
    Gresham Street
    4th Floor
    EC2V 7BX London
    1
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act, 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06250753
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    06 apr 2016
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    Berkshire
    England
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02291198
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Sembcorp Utilitied Pte Limited
    Hill Street
    No 05-04
    Singapore, 179360
    30
    Singapore
    06 apr 2016
    Hill Street
    No 05-04
    Singapore, 179360
    30
    Singapore
    Forma giuridicaPublic Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneSingapore
    Autorità legaleCompanies Act Chapter 50
    Luogo di registrazioneSingapore
    Numero di registrazione197300648h
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    England
    06 apr 2016
    Grenfell Road
    SL6 1ES Maidenhead
    Suez House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act, 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione02291198
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    Sembcorp Utilities (Pte) Limited
    Hill Street
    #05-04
    179360
    Singapore
    30
    Singapore
    06 apr 2016
    Hill Street
    #05-04
    179360
    Singapore
    30
    Singapore
    No
    Forma giuridicaCompany
    Paese di registrazioneSingapore
    Autorità legaleCompanies Act 1967
    Luogo di registrazioneAcra
    Numero di registrazione197300648h
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per MERSEYSIDE ENERGY RECOVERY HOLDINGS LTD?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    17 ott 201916 ott 2024La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0