DB SYMMETRY NORTH LTD
Panoramica
| Nome della società | DB SYMMETRY NORTH LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 07996713 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di DB SYMMETRY NORTH LTD?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova DB SYMMETRY NORTH LTD?
| Indirizzo della sede legale | Grange Park Court Roman Way NN4 5EA Northampton England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di DB SYMMETRY NORTH LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BARWOOD DEVELOPMENTS (NORTH) LIMITED | 20 mar 2012 | 20 mar 2012 |
Quali sono gli ultimi bilanci di DB SYMMETRY NORTH LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 gen 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per DB SYMMETRY NORTH LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Cessazione della carica di Mark Glenn Bridgman Shaw come amministratore in data 07 gen 2020 | 1 pagine | TM01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Bjorn Dominic Hobart il 10 feb 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Colin Richard Godfrey il 10 feb 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Henry Bell Franklin il 10 feb 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr James Angus Dunlop il 10 feb 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mrs Petrina Marie Austin il 10 feb 2020 | 2 pagine | CH01 | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 gen 2019 | 18 pagine | AA | ||
Modifica dei dettagli di Db Symmetry Ltd come persona con controllo significativo il 14 mar 2019 | 2 pagine | PSC05 | ||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 20 mar 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF United Kingdom a Seebeck House 1 Seebeck Place Knowlhill Milton Keynes MK5 8FR | 1 pagine | AD02 | ||
I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AF | 1 pagine | AD03 | ||
Cessazione della carica di Dv4 Administration 1 Uk Limited come amministratore in data 19 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mark Glenn Bridgman Shaw come amministratore in data 19 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mrs Petrina Marie Austin come amministratore in data 19 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr Colin Richard Godfrey come amministratore in data 19 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Mr James Angus Dunlop come amministratore in data 19 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Henry Bell Franklin come amministratore in data 19 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Nomina di Bjorn Dominic Hobart come amministratore in data 19 feb 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Andrew Mark Dickman come amministratore in data 19 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Christian Peter Matthews come amministratore in data 19 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Henry Brian Chapman come amministratore in data 19 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Chi sono gli amministratori di DB SYMMETRY NORTH LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUSTIN, Petrina Marie, Ms. | Amministratore | Roman Way NN4 5EA Northampton Grange Park Court England | England | British | 198857650001 | |||||||||
| BOWEN, Richard William | Amministratore | Roman Way NN4 5EA Northampton Grange Park Court England | United Kingdom | British | 151921790001 | |||||||||
| DUNLOP, James Angus | Amministratore | Roman Way NN4 5EA Northampton Grange Park Court England | England | British | 141588110002 | |||||||||
| FRANKLIN, Henry Bell | Amministratore | Roman Way NN4 5EA Northampton Grange Park Court England | United Kingdom | British | 263209650001 | |||||||||
| GODFREY, Colin Richard | Amministratore | Roman Way NN4 5EA Northampton Grange Park Court England | England | British | 125135720005 | |||||||||
| HOBART, Bjorn Dominic | Amministratore | Roman Way NN4 5EA Northampton Grange Park Court England | United Kingdom | British | 256504410001 | |||||||||
| CHAMBERS, Stephen John | Segretario | Berkeley Square W1J 6ER London 6th Floor, Lansdowne House England | 177311410001 | |||||||||||
| GREENSLADE, Joanna Avril | Segretario | Berkeley Square W1J 6ER London 6th Floor, Lansdowne House England | 177311470001 | |||||||||||
| EMW SECRETARIES LIMITED | Segretario | 1 Seebeck Place Knowlhill MK5 8FR Milton Keynes Seebeck House Buckinghamshire United Kingdom |
| 93910510003 | ||||||||||
| CHAMBERS, Stephen John | Amministratore | Berkeley Square W1J 6ER London 6th Floor, Lansdowne House England | United Kingdom | British | 64382980002 | |||||||||
| CHAPMAN, Henry Brian | Amministratore | Roman Way NN4 5EA Northampton Grange Park Court England | United Kingdom | British | 141650050002 | |||||||||
| DICKMAN, Andrew Mark | Amministratore | 144 Deansgate M3 3EE Manchester Grampian House Greater Manchester United Kingdom | United Kingdom | British | 141548810001 | |||||||||
| GREENSLADE, Joanna Avril | Amministratore | Berkeley Square W1J 6ER London 6th Floor, Lansdowne House England | England | British | 111064630002 | |||||||||
| MATTHEWS, Christian Peter | Amministratore | Roman Way NN4 5EA Northampton Grange Park Court England | United Kingdom | British | 83756390001 | |||||||||
| RUDGE, Alan James | Amministratore | Berkeley Square W1J 6ER London 6th Floor, Lansdowne House England | United Kingdom | British | 9647250002 | |||||||||
| SHAW, Mark Glenn Bridgman | Amministratore | 4th Floor 2-5 Old Bond Street W1S 4PD London Standbrook House United Kingdom | England | British | 220179870001 | |||||||||
| DV4 ADMINISTRATION 1 UK LIMITED | Amministratore | Berkeley Square W1J 6ER London Landowne House England |
| 193835520001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di DB SYMMETRY NORTH LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Db Symmetry Ltd | 06 apr 2016 | Roman Way NN4 5EA Northampton Grange Park Court England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
DB SYMMETRY NORTH LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 23 lug 2014 Consegnato il 30 lug 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione F/H land and buildings of phase 1 venture fields earle road widnes cheshire t/no. CH626863. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 25 apr 2014 Consegnato il 28 apr 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Phase 1 venturefield, earle road, widnes (currently registered at the land registry under title numbers CH539088 and CH564451) being all that land and buildings transferred to the borrower pursuant to a transfer dated 18 february 2014 between (1) halton borough council and (2) the borrower.. A fixed charge by way of legal assignment on all the copyright in all drawings designs specifications plans and other written materials relating to any products from time to time manufactured by the mortgagor and all other intellectual property rights (including but without prejudice to the generality of the foregoing all present or future patents, trademarks, service marks, trade names, designs, copyright, inventions, topographical or similar rights, confidential information and know how and designations on or patterns of the labels and packages of any products from time to time manufactured by the mortgagor and all manufacturing and sales rights in relation to any products from time to time manufactured by the mortgagor) and including all applications and rights to apply for registration and all fees, royalties and other rights derived from, or incidental to, these rights. Debitore che agisce come trustee nudo: Sì L'ipoteca flottante copre tutto: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 25 apr 2014 Consegnato il 28 apr 2014 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione Phase 1 venturefield, earle road, widnes (currently registered at the land registry under title numbers CH539088 and CH564451) being all that land and buildings transferred to the borrower pursuant to a transfer dated 18 february 2014 between (1) halton borough council and (2) the borrower. Debitore che agisce come trustee nudo: Sì Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0