VIRIDIS 178 LIMITED

VIRIDIS 178 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVIRIDIS 178 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 09464998
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di VIRIDIS 178 LIMITED?

    • Produzione di energia elettrica (35110) / Fornitura di elettricità, gas, vapore e aria condizionata

    Dove si trova VIRIDIS 178 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O FRP ADVISORY TRADING LTD (EDINBURGH OFFICE)
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di VIRIDIS 178 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per VIRIDIS 178 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    19 pagineLIQ14

    Dichiarazione delle attività

    8 pagineLIQ02

    Indirizzo della sede legale modificato da 12 Times Court Retreat Road Richmond TW9 1AF England a 110 Cannon Street London EC4N 6EU in data 09 giu 2022

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 31 mag 2022

    LRESEX

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio redatto al 31 mag 2020

    27 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Ts2, Pinewood Business Park Coleshill Road Birmingham B37 7HG England a 12 Times Court Retreat Road Richmond TW9 1AF in data 01 giu 2021

    1 pagineAD01

    Soddisfazione dell'onere 094649980016 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 094649980016, creata il 01 ott 2020

    15 pagineMR01

    Cessazione della carica di Henry Roscoe Townshend come amministratore in data 02 ott 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nicholas Talbot Morgan come amministratore in data 02 ott 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Philip Geoffrey Bates come amministratore in data 02 ott 2020

    1 pagineTM01

    Soddisfazione dell'onere 094649980012 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 094649980001 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 094649980002 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 094649980004 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 094649980003 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 094649980005 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 094649980006 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 094649980007 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 094649980008 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 094649980009 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di VIRIDIS 178 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DUGGINS, David Kenneth
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    Amministratore
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    United KingdomBritish255153930001
    ENTRACT, Jonathan Mark
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    England
    Amministratore
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    England
    EnglandBritish86046470002
    GARCIA, Carlos Abuin
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    England
    Amministratore
    Charles Ii Street
    SW1Y 4QU London
    12
    England
    EnglandSpanish255117650001
    HALL-SMITH, James Edward
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    Amministratore
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    United KingdomBritish128011730001
    BEAUMONT, Neil Geoffrey
    The Courtyard, Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1JA Birmingham
    17
    England
    Segretario
    The Courtyard, Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1JA Birmingham
    17
    England
    195437010001
    BATES, David Philip Geoffrey
    Coleshill Road
    B37 7HG Birmingham
    Ts2, Pinewood Business Park
    England
    Amministratore
    Coleshill Road
    B37 7HG Birmingham
    Ts2, Pinewood Business Park
    England
    United KingdomBritish250911000001
    BEAUMONT, Neil Geoffrey
    The Courtyard, Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1JA Birmingham
    17
    England
    Amministratore
    The Courtyard, Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1JA Birmingham
    17
    England
    EnglandBritish79181260001
    BELLIZIA, Giulio
    The Courtyard, Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1JA Birmingham
    17
    England
    Amministratore
    The Courtyard, Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1JA Birmingham
    17
    England
    United KingdomItalian126613980003
    JONES, Mark Wesley
    The Courtyard, Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1JA Birmingham
    17
    England
    Amministratore
    The Courtyard, Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1JA Birmingham
    17
    England
    EnglandBritish128781930001
    MORGAN, Nicholas Talbot
    Coleshill Road
    B37 7HG Birmingham
    Ts2, Pinewood Business Park
    England
    Amministratore
    Coleshill Road
    B37 7HG Birmingham
    Ts2, Pinewood Business Park
    England
    EnglandBritish260191880001
    STONE, Andrew Peter
    The Courtyard, Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1JA Birmingham
    17
    England
    Amministratore
    The Courtyard, Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1JA Birmingham
    17
    England
    EnglandBritish165340210001
    TAYLOR, Jeremy William Kirwan
    The Courtyard, Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1JA Birmingham
    17
    England
    Amministratore
    The Courtyard, Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1JA Birmingham
    17
    England
    EnglandBritish158053860001
    TOWNSHEND, Henry Roscoe
    Coleshill Road
    B37 7HG Birmingham
    Ts2, Pinewood Business Park
    England
    Amministratore
    Coleshill Road
    B37 7HG Birmingham
    Ts2, Pinewood Business Park
    England
    EnglandBritish224440470001

    Chi sono le persone con controllo significativo di VIRIDIS 178 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Gfpii Limited
    The Courtyard, Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1JA Birmingham
    17
    England
    06 apr 2016
    The Courtyard, Gorsey Lane
    Coleshill
    B46 1JA Birmingham
    17
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneUk Companies Registry
    Numero di registrazione09427160
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    VIRIDIS 178 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 ott 2020
    Consegnato il 16 ott 2020
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Conrad (Emerald) Limited
    Transazioni
    • 16 ott 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 mag 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 apr 2020
    Consegnato il 06 mag 2020
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land on the north-east side of sudmeadow road, gloucester with title number GR403511.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 06 mag 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 07 mag 2019
    Consegnato il 10 mag 2019
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Leasehold land lying to the south-east of baldock road, letchworth garden city demised by a lease dated 14 may 2015 and made between letchworth garden city heritage foundation and gf energy limited (2) registered at the land registry under title number HD544769 and these assets. For more details, please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 10 mag 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 apr 2018
    Consegnato il 17 apr 2018
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Leasehold land lying south-east of baldock road, letchworth garden city demised by a lease dated 14 may 2015 and made between (1) letchworth garden city heritage foundation and (2) gf energy limited, with title number HD544769. For details of further charges see details at part 1 schedule 1 of the charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 17 apr 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 17 nov 2017
    Consegnato il 20 nov 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The chargor charged by way of first legal mortgage its interest in leasehold land lying adjoining telmar house, barton hill way torquay TQ2 8JG given the title number DN677439 and leasehold land lying to the south of barton hill way, torquay given the title number DN677440.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 20 nov 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 20 ott 2017
    Consegnato il 20 ott 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The chargor charged by way of first legal mortgage its interest in land lying on the south west side of faraday road, plymouth given the title number DN675589.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 20 ott 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 28 lug 2017
    Consegnato il 28 lug 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The chargor charged by way of first legal mortgage its interest in all that land being electricity sub station, land at imi titanium works, waunarlwydd swansea as shown edged red on the plan attached to the instrument, and provisionally given the title number CYM707006.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 28 lug 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 03 nov 2016
    Consegnato il 08 nov 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The chargor charged by way of legal mortgage all that leasehold land on the north east side of sudmeadow road, gloucester comprised in a lease dated 24 august 2016 and made between (1) viridis property no.3 Limited and (2) viridis 178 limited.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 08 nov 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 02 nov 2016
    Consegnato il 08 nov 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The charger charged by way of legal mortgage "the freehold land being unit 2 and 3 trafalgar park, victory road, derby DE24 8EJ registered at the land registry with title number DY497651".
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 08 nov 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 16 giu 2016
    Consegnato il 20 giu 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The charger charged by way of legal mortgage the "leasehold land at dowlais penygarnddu industrial estate, merthyr tydfil, CF48 2TA comprised in a lease dated 10 june 2016 and made between (1) green frog 214 limited and (2) viridis 178 limited".
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 20 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 18 mag 2016
    Consegnato il 23 mag 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    The chargor charged by way of legal mortgage the "electricity sub station, land at imi titanium works, waunarlwydd, swansea, registered at the land registry with title number CYM672535".
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 mag 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 11 mar 2016
    Consegnato il 14 mar 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Legal mortgage over the leasehold land known as lester way, wallingford, oxfordshire OX10 9TA. Leasehold interest held pursuant to a lease dated 2 march 2016 and made between (1) a c lester (properties) limited (2) viridis 178 limited, to be registered.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 14 mar 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 20 nov 2015
    Consegnato il 23 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Leasehold premises k/a land at redfield road nottingham.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 23 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 11 nov 2015
    Consegnato il 24 nov 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H premises k/a land at water lane exeter.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 24 nov 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 ago 2015
    Consegnato il 01 set 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    L/H land at the drove bridgwater somerset t/no ST322020.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 01 set 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 lug 2015
    Consegnato il 07 ago 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    T/No HD544769. L/h land lying to the south-east of baldock road letchworth garden city.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 07 ago 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 08 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    VIRIDIS 178 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 mag 2022Inizio della liquidazione
    30 set 2023Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Stuart Robb
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Praticante
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Chad Griffin
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh
    Praticante
    Apex 3, 95 Haymarket Terrace
    EH12 5HD Edinburgh

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0