VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC

VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Società estera
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàVIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaSocietà estera
    Numero di società FC018124
    GiurisdizioneRegno Unito
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Dove si trova VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC?

    Indirizzo della sede legale
    2711 Centreville Road
    Suite 400
    Wilmington
    Delaware De 19808
    Usa
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VIRGIN MEDIA (UK) GROUP, INC07 mag 199707 mag 1997
    CABLETEL UK GROUP, INC.16 feb 199616 feb 1996
    OCOM SUB II, INC.15 dic 199315 dic 1993

    Quali sono gli ultimi bilanci di VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC è una società estera

    Requisiti contabili per le società estere
    Tipo di conto esteroNon si applicano i requisiti contabili del paese di origine
    Condizioni di pubblicazione dei contiData di riferimento contabile assegnata da Companies House
    Attività commercialeTo Engage In Any Legal Activity
    Forma giuridicaLimited Liability Company
    È un istituto di credito o finanziarioNo
    Regolato daGeneral Corporation Law Of State Of Delaware
    Paese di registro di origineUNITED STATES
    Luogo di registrazioneOffice Of The Secretary Of State For Delaware
    Numero di societàN/A

    Quali sono le ultime deposizioni per VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Chiusura dell'istituzione nel Regno Unito BR003964 e della società estera FC018124 il 18 dic 2015

    2 pagineOSDS01

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    3 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    18 pagineAA

    Cambio della denominazione sociale" di una società estera in data 28 feb 2015 da {change_name}

    4 pagineOSNM01

    Modifiche ai documenti costitutivi" in data 17 dic 2014

    14 pagineOSCC01

    Dettagli modificati per una società estera - Change in Legal Form 17/12/14 Private Company Limited by Shares

    pagineOSCH02

    Dettagli modificati per una società estera - Ic Change 17/12/14

    4 pagineOSCH02

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    21 pagineAA

    Nomina di un direttore

    3 pagineOSAP01

    Cessazione della carica di Caroline Withers come amministratore

    2 pagineOSTM01

    Cessazione della carica di Robert Gale come amministratore

    2 pagineOSTM01

    Nomina di un direttore

    3 pagineOSAP01

    Dettagli modificati per una società estera - 160 Greentree Drive, Suite 101 Dover, Delaware 19904 Usa, United States

    4 pagineOSCH02

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    30 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Caroline Bernadette Elizabeth Withers il 14 mar 2013

    3 pagineOSCH03

    Cessazione della carica di Joanne Tillbrook come amministratore

    2 pagineOSTM01

    Nomina di un direttore

    3 pagineOSAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    20 pagineAA

    Nomina di un direttore

    5 pagineOSAP01

    Cessazione della carica di Robert Mackenzie come amministratore

    3 pagineOSTM01

    Modifiche ai dati del segretario per Gillian Elizabeth James in data 16 set 2011

    4 pagineOSCH05

    Dettagli del direttore cambiati per Robert Charles Gale il 16 set 2011

    5 pagineOSCH03

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    21 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    British72139660003
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish179134020002
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish182167230001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Segretario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Amministratore
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    DELLAROCCO, Thoams Stephan
    7a Woodway
    Merrow
    GU1 2TF Guildford
    Surrey
    Amministratore
    7a Woodway
    Merrow
    GU1 2TF Guildford
    Surrey
    American48933280001
    DEW, Bryony
    2 Winton Road
    GU9 9QW Farnham
    Surrey
    Amministratore
    2 Winton Road
    GU9 9QW Farnham
    Surrey
    British70776760001
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    GIESEN, Douglas Henry
    399 Albert Drive
    G41 4SA Glasgow
    Amministratore
    399 Albert Drive
    G41 4SA Glasgow
    Us45775100001
    HEIDARY, Hamid Reza
    Fairways West Hill Golf Course
    Bagshot Road
    GU22 0QZ Worplesdon Hill
    Surrey
    Amministratore
    Fairways West Hill Golf Course
    Bagshot Road
    GU22 0QZ Worplesdon Hill
    Surrey
    American48966390001
    HINDLEY, Alan
    Cedar Lodge Coldmoorholme Lane
    SL8 5PS Bourne End
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Cedar Lodge Coldmoorholme Lane
    SL8 5PS Bourne End
    Buckinghamshire
    EnglandBritish59366960001
    JAIN, Dinesh
    Redcote
    Sheath Lane
    KT22 0RA Oxshott
    Surrey
    Amministratore
    Redcote
    Sheath Lane
    KT22 0RA Oxshott
    Surrey
    American48933260002
    KELHAM, David William
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    Amministratore
    Chastilian
    Gough Road
    GU51 4LJ Fleet
    Hampshire
    EnglandBritish87146390001
    MACDONALD, Stephen
    8 Vale Coppice
    Ramsbotham
    BL0 9FJ Bury
    Lancashire
    Amministratore
    8 Vale Coppice
    Ramsbotham
    BL0 9FJ Bury
    Lancashire
    British71437880001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Amministratore
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    MCKELLAR, Ronald Alexander
    Halstead
    Stratfield Saye
    RG7 2EJ Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Halstead
    Stratfield Saye
    RG7 2EJ Reading
    Berkshire
    British7345780001
    MELLY, Gregory Kevin
    Thistledown
    Abbotswood Chase
    GU1 1XA Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Thistledown
    Abbotswood Chase
    GU1 1XA Guildford
    Surrey
    British48933270001
    PEGELLA, Maurice Vondy
    7 Grays Lane
    KT21 1BS Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    7 Grays Lane
    KT21 1BS Ashtead
    Surrey
    British102510960001
    ROBERTS, Gareth Nigel Christopher
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    Amministratore
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    British145824690001
    ROSS, Stuart
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    Amministratore
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    EnglandBritish20168110001
    RYAN, Terrence Michael
    Penarth House
    Cliff Parade
    CF64 5BP Penarth
    South Glamorgan
    Amministratore
    Penarth House
    Cliff Parade
    CF64 5BP Penarth
    South Glamorgan
    Us Citizen40077290002
    SMITH, Timothy
    Mayfield House Hungerford Hill
    Lambourn
    RG16 7NP Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Mayfield House Hungerford Hill
    Lambourn
    RG16 7NP Newbury
    Berkshire
    British60222820001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164134250001
    WAGNER, Steven
    Wentworth Gate East Drive
    GU25 4JY Virginia Water
    Surrey
    Amministratore
    Wentworth Gate East Drive
    GU25 4JY Virginia Water
    Surrey
    American44170170001
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish140137570002
    WOOD, Leigh
    The Priory 10 Hambledon Park
    Hambledon
    GU8 4ER Godalming
    Surrey
    Amministratore
    The Priory 10 Hambledon Park
    Hambledon
    GU8 4ER Godalming
    Surrey
    American53880530001

    VIRGIN MEDIA (UK) GROUP LLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Confirmation deed
    Creato il 15 apr 2010
    Consegnato il 29 apr 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 29 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Second assignment agreement relating to inter-company loans
    Creato il 27 set 2001
    Consegnato il 08 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations at any time due, owing or incurred by the obligor to any secured party under the finance documents (all terms as defined)
    Brevi particolari
    All its rights title and interest present and future in and to and the benefit of the intra group loans and its right to receive sums thereunder including without limitation all such rights as may revert to the company upon the discharge and release of the ntl UK intra-group loan assignment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited as Security Trustee for the Secured Parties on the Terms and Conditions Set Out in the Second Security Trust Agreement
    Transazioni
    • 08 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An assignment agreement relating to inter-company loans (the "intra-group loan assignment") between the assignor and security trustee.
    Creato il 21 feb 2001
    Consegnato il 22 feb 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations owing to the secured parties or to the security trustee (whether for it's own account or as trustee for the secured parties) by the obligors under or pursuant to the finance documents
    Brevi particolari
    All right title and interest present and future in and to and the benefit of, the intra-group loans (as defined) and all rights to receive sums thereunder.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited as Trustee for the Secured Parties on the Terms and Conditions Set Out in the Security Trust Agreement
    Transazioni
    • 22 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 17 ott 1997
    Consegnato il 30 ott 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    Each and every liability which the company (the "chargor") may now or hereafter have to the chargee (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries (and whether solely or jointly with one or more persons and whether as principal or as surety) under or pursuant to the facility documents including any liability in respect of any further advances made thereunder (the "secured obligations")
    Brevi particolari
    See schedules attached to form M395 for details of all the property). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 ott 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A deposit agreement
    Creato il 20 ago 1997
    Consegnato il 21 ago 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the counter-indemnity or this deposit agreement
    Brevi particolari
    Fixed charge all the chargor's right,title and interest in and to all monies on the date of the deposit agreement or at any time thereafter during the subsistence of the deposit agreement standing to the credit of:(a) any account which may from time to time be opened in order to effect certain time deposits to be made with chase manhattan international limited at its 125 london wall,london EC2Y 5AJ office as security for the chargor's obligations under the counter indemnity;and (b) any account opened by the bank pursuant to clause 7 of the deposit agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank
    Transazioni
    • 21 ago 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deposit agreement
    Creato il 29 mag 1997
    Consegnato il 17 giu 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under or pursuant to the counter-indemnity (as defined) or the deposit agreement
    Brevi particolari
    All right title and interest in and to all monies standing to the credit of any account from time to time opened to effect certain time deposits to be made with chase manhattan international limited and any account opened by the bank pursuant to clause 7 of the deposit agreement and all rights and benefits accruing or arising in connection with the deposits. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Chase Manhattan Bank
    Transazioni
    • 17 giu 1997Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 nov 1997Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0