PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED

PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Società estera
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaSocietà estera
    Numero di società FC021877
    Numero di registrazione esternoCR 89715
    GiurisdizioneRegno Unito
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Dove si trova PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Maples And Calder
    Ugland House PO BOX 309
    George Town
    Grand Cayman Cayman Islands
    Cayman Islands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al15 ago 2021

    PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED è una società estera

    Requisiti contabili per le società estere
    Tipo di conto esteroNon si applicano i requisiti contabili del paese di origine
    Condizioni di pubblicazione dei contiData di riferimento contabile assegnata da Companies House
    Attività commercialeToissue Debt Securities & On-Lend Proceeds
    Forma giuridicaExempt Company Withg Limited Liability
    È un istituto di credito o finanziarioNo
    Regolato daCayman Islands
    Paese di registro di origineCAYMAN ISLANDS
    Luogo di registrazioneRegister Of Cayman Islands Companies
    Numero di societàCR 89715

    Quali sono le ultime deposizioni per PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Chiusura dell'istituzione nel Regno Unito BR005024 e della società estera FC021877 il 27 mar 2023

    3 pagineOSDS01

    Cessazione della carica di Francesca Ann Appleby come segretario in data 22 ago 2022

    2 pagineOSTM02

    Bilancio redatto al 15 ago 2021

    22 pagineAA

    Cessazione della carica di Daniel Jonathan Wynne come amministratore in data 30 giu 2021

    2 pagineOSTM01

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    3 pagineMR04

    Bilancio redatto al 16 ago 2020

    21 pagineAA

    Bilancio redatto al 18 ago 2019

    22 pagineAA

    Bilancio redatto al 19 ago 2018

    22 pagineAA

    Bilancio redatto al 19 ago 2017

    25 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Daniel Jonathan Wynne il 05 dic 2017

    3 pagineOSCH03

    Nomina di Mr Daniel Jonathan Wynne come direttore il 21 apr 2017

    3 pagineOSAP01

    Cessazione della carica di Mark Howard Filer come amministratore in data 21 apr 2017

    2 pagineOSTM01

    Bilancio redatto al 22 ago 2016

    24 pagineAA

    Bilancio redatto al 22 ago 2015

    23 pagineAA

    Bilancio redatto al 23 ago 2014

    22 pagineAA

    Cessazione della carica di Wilmington Trust Sp Services (London) Limited come amministratore in data 09 ott 2014

    2 pagineOSTM01

    Cessazione della carica di Dean Edward John Merritt come amministratore in data 08 ott 2014

    2 pagineOSTM01

    Cessazione della carica di Claire Louise Harris come segretario in data 07 ott 2014

    2 pagineOSTM02

    Nomina di Francesca Ann Appleby come segretario il 07 ott 2014

    3 pagineOSAP03

    Nomina di un direttore

    3 pagineOSAP01

    Nomina di un direttore

    3 pagineOSAP01

    Bilancio redatto al 17 ago 2013

    21 pagineAA

    Cessazione della carica di Stephen Billingham come amministratore

    2 pagineOSTM01

    Chi sono gli amministratori di PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector131551840002
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector152083750001
    APPLEBY, Francesca Ann
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    British191946720001
    ARMITAGE, Helen Tyrrell
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    British166847910001
    CROSS, Anthony
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    Segretario
    38 The Lane
    Spinkhill
    S21 3YF Sheffield
    South Yorkshire
    British1812400001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    British175820210001
    RUDD, Susan Clare
    23 Whitehouse Drive
    WS13 8FE Lichfield
    Staffordshire
    Segretario
    23 Whitehouse Drive
    WS13 8FE Lichfield
    Staffordshire
    British81789210002
    STEWART, Claire Susan
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Uk
    Segretario
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Uk
    British117216940001
    BILLINGHAM, Stephen Robert
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    UkBritishDirector163365820001
    BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    Amministratore
    8 Moore Street
    SW3 2QN London
    United KingdomBritishCompany Director53682420001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Uk
    Amministratore
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton On Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Uk
    United KingdomBritishDirector141395280001
    FILER, Mark Howard
    c/o Wilmington Trust Sp Services (London) Limited
    1 Kings Arms Yard
    EC2R 7AF London
    Third Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Wilmington Trust Sp Services (London) Limited
    1 Kings Arms Yard
    EC2R 7AF London
    Third Floor
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector108927600003
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Amministratore
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    BritishDirector42019620001
    MERRITT, Dean Edward John
    c/o Talbot Highes Mckillop Llp
    Snow Hill
    EC1A 2AY London
    6
    United Kingdom
    Amministratore
    c/o Talbot Highes Mckillop Llp
    Snow Hill
    EC1A 2AY London
    6
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant141247230001
    PRESTON, Neil David
    Postern Road
    Tatenhill
    DE13 9SJ Burton On Trent
    57
    Staffordshire
    Amministratore
    Postern Road
    Tatenhill
    DE13 9SJ Burton On Trent
    57
    Staffordshire
    United KingdomBritishDirector63043630002
    SANDS, John Robert
    11 Falcon Lane
    Norton
    TS20 1LS Stockton On Tees
    Amministratore
    11 Falcon Lane
    Norton
    TS20 1LS Stockton On Tees
    United KingdomBritishManaging Director141561650001
    THORLEY, Giles Alexander
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Gb-EngBritishDirector81928120001
    TURNBULL, Ronald
    16 Willow Road
    Dairy Lane Estate
    DH4 5QF Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    Amministratore
    16 Willow Road
    Dairy Lane Estate
    DH4 5QF Houghton Le Spring
    Tyne & Wear
    BritishChartered Accountant63331360001
    WHITESIDE, Roger Mark
    Second Avenue
    Centrum One Hundred
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    Amministratore
    Second Avenue
    Centrum One Hundred
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector128819260001
    WYNNE, Daniel Jonathan
    c/o Wilmington Ttust Sp Services (London) Limited
    1 King's Arm Yard
    EC2R 7AF London
    Third Floor
    Amministratore
    c/o Wilmington Ttust Sp Services (London) Limited
    1 King's Arm Yard
    EC2R 7AF London
    Third Floor
    EnglandBritishDirector101879110005
    WILMINGTON TRUST SP SERVICES (LONDON) LIMITED
    King's Arms Yard
    EC2R 7AF London
    Third Floor 1
    Amministratore
    King's Arms Yard
    EC2R 7AF London
    Third Floor 1
    24311810024

    PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    The eighth supplemental issuer deed of charge
    Creato il 01 ago 2005
    Consegnato il 12 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the issuer security trustee, the note trustee, the class a noteholders and all other parties as defined on the form 395 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its right, title, interest and benefit, present and future, in, to and under the second new notes subscription agreement, the seventh supplemental punch taverns b deed of charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited (The Issuer Security Trustee)
    Transazioni
    • 12 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Seventh supplemental issuer deed of charge
    Creato il 09 mag 2005
    Consegnato il 10 mag 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the issuer security trustee, the note trustee, the class a noteholders and all other parties as defined on the form 395 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All right title interest and benefit in and to all moneys standing to the credit of the issuer transaction account, the issuer cash collateral account and the prefunding account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Trustee Company Limited (The Issuer Security Trustee and Borrower Security Trustee)
    Transazioni
    • 10 mag 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Second supplemental issuer deed of charge made between the company, bankers trustee company limited and deutsche bank international trust co. (Jersey) limited (the note trustee)
    Creato il 23 dic 1999
    Consegnato il 12 gen 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) under the second supplemental deed of charge
    Brevi particolari
    All rights title interest and benefit present and future in to and under the supplemental pubmaster deed of charge including all rights to receive payment of any amounts which may become payable to the issuer thereunder and all payments received by the issuer thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bankers Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 12 gen 2000Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 lug 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0