PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED
Panoramica
Nome della società | PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED |
---|---|
Stato della società | Convertita/Chiusa |
Forma giuridica | Società estera |
Numero di società | FC021877 |
Numero di registrazione esterno | CR 89715 |
Giurisdizione | Regno Unito |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Dove si trova PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Maples And Calder Ugland House PO BOX 309 George Town Grand Cayman Cayman Islands Cayman Islands |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 15 ago 2021 |
PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED è una società estera
Requisiti contabili per le società estere | |
---|---|
Tipo di conto estero | Non si applicano i requisiti contabili del paese di origine |
Condizioni di pubblicazione dei conti | Data di riferimento contabile assegnata da Companies House |
Attività commerciale | Toissue Debt Securities & On-Lend Proceeds |
Forma giuridica | Exempt Company Withg Limited Liability |
È un istituto di credito o finanziario | No |
Regolato da | Cayman Islands |
Paese di registro di origine | CAYMAN ISLANDS |
Luogo di registrazione | Register Of Cayman Islands Companies |
Numero di società | CR 89715 |
Quali sono le ultime deposizioni per PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
---|---|---|---|---|
Chiusura dell'istituzione nel Regno Unito BR005024 e della società estera FC021877 il 27 mar 2023 | 3 pagine | OSDS01 | ||
Cessazione della carica di Francesca Ann Appleby come segretario in data 22 ago 2022 | 2 pagine | OSTM02 | ||
Bilancio redatto al 15 ago 2021 | 22 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Daniel Jonathan Wynne come amministratore in data 30 giu 2021 | 2 pagine | OSTM01 | ||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 3 pagine | MR04 | ||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 3 pagine | MR04 | ||
Bilancio redatto al 16 ago 2020 | 21 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 18 ago 2019 | 22 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 19 ago 2018 | 22 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 19 ago 2017 | 25 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Daniel Jonathan Wynne il 05 dic 2017 | 3 pagine | OSCH03 | ||
Nomina di Mr Daniel Jonathan Wynne come direttore il 21 apr 2017 | 3 pagine | OSAP01 | ||
Cessazione della carica di Mark Howard Filer come amministratore in data 21 apr 2017 | 2 pagine | OSTM01 | ||
Bilancio redatto al 22 ago 2016 | 24 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 22 ago 2015 | 23 pagine | AA | ||
Bilancio redatto al 23 ago 2014 | 22 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Wilmington Trust Sp Services (London) Limited come amministratore in data 09 ott 2014 | 2 pagine | OSTM01 | ||
Cessazione della carica di Dean Edward John Merritt come amministratore in data 08 ott 2014 | 2 pagine | OSTM01 | ||
Cessazione della carica di Claire Louise Harris come segretario in data 07 ott 2014 | 2 pagine | OSTM02 | ||
Nomina di Francesca Ann Appleby come segretario il 07 ott 2014 | 3 pagine | OSAP03 | ||
Nomina di un direttore | 3 pagine | OSAP01 | ||
Nomina di un direttore | 3 pagine | OSAP01 | ||
Bilancio redatto al 17 ago 2013 | 21 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Stephen Billingham come amministratore | 2 pagine | OSTM01 | ||
Chi sono gli amministratori di PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BASHFORTH, Edward Michael | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton On Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 131551840002 | ||||
DANDO, Stephen Peter | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton On Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 152083750001 | ||||
APPLEBY, Francesca Ann | Segretario | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire | British | 191946720001 | ||||||
ARMITAGE, Helen Tyrrell | Segretario | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire | British | 166847910001 | ||||||
CROSS, Anthony | Segretario | 38 The Lane Spinkhill S21 3YF Sheffield South Yorkshire | British | 1812400001 | ||||||
HARRIS, Claire Louise | Segretario | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire | British | 175820210001 | ||||||
RUDD, Susan Clare | Segretario | 23 Whitehouse Drive WS13 8FE Lichfield Staffordshire | British | 81789210002 | ||||||
STEWART, Claire Susan | Segretario | Second Avenue DE14 2WF Burton On Trent Jubilee House Staffordshire Uk | British | 117216940001 | ||||||
BILLINGHAM, Stephen Robert | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire | Uk | British | Director | 163365820001 | ||||
BRACKENBURY, Frederick Edwin John Gedge | Amministratore | 8 Moore Street SW3 2QN London | United Kingdom | British | Company Director | 53682420001 | ||||
DUTTON, Philip | Amministratore | Second Avenue DE14 2WF Burton On Trent Jubilee House Staffordshire Uk | United Kingdom | British | Director | 141395280001 | ||||
FILER, Mark Howard | Amministratore | c/o Wilmington Trust Sp Services (London) Limited 1 Kings Arms Yard EC2R 7AF London Third Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 108927600003 | ||||
MCDONALD, Robert James | Amministratore | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | Director | 42019620001 | |||||
MERRITT, Dean Edward John | Amministratore | c/o Talbot Highes Mckillop Llp Snow Hill EC1A 2AY London 6 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 141247230001 | ||||
PRESTON, Neil David | Amministratore | Postern Road Tatenhill DE13 9SJ Burton On Trent 57 Staffordshire | United Kingdom | British | Director | 63043630002 | ||||
SANDS, John Robert | Amministratore | 11 Falcon Lane Norton TS20 1LS Stockton On Tees | United Kingdom | British | Managing Director | 141561650001 | ||||
THORLEY, Giles Alexander | Amministratore | Charlton Manor Ashley Road Charlton Kings GL52 6NS Cheltenham Gloucestershire | Gb-Eng | British | Director | 81928120001 | ||||
TURNBULL, Ronald | Amministratore | 16 Willow Road Dairy Lane Estate DH4 5QF Houghton Le Spring Tyne & Wear | British | Chartered Accountant | 63331360001 | |||||
WHITESIDE, Roger Mark | Amministratore | Second Avenue Centrum One Hundred DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House Staffordshire | England | British | Director | 128819260001 | ||||
WYNNE, Daniel Jonathan | Amministratore | c/o Wilmington Ttust Sp Services (London) Limited 1 King's Arm Yard EC2R 7AF London Third Floor | England | British | Director | 101879110005 | ||||
WILMINGTON TRUST SP SERVICES (LONDON) LIMITED | Amministratore | King's Arms Yard EC2R 7AF London Third Floor 1 | 24311810024 |
PUNCH TAVERNS FINANCE B LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
The eighth supplemental issuer deed of charge | Creato il 01 ago 2005 Consegnato il 12 ago 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the issuer security trustee, the note trustee, the class a noteholders and all other parties as defined on the form 395 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All its right, title, interest and benefit, present and future, in, to and under the second new notes subscription agreement, the seventh supplemental punch taverns b deed of charge. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Seventh supplemental issuer deed of charge | Creato il 09 mag 2005 Consegnato il 10 mag 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the issuer security trustee, the note trustee, the class a noteholders and all other parties as defined on the form 395 under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All right title interest and benefit in and to all moneys standing to the credit of the issuer transaction account, the issuer cash collateral account and the prefunding account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Second supplemental issuer deed of charge made between the company, bankers trustee company limited and deutsche bank international trust co. (Jersey) limited (the note trustee) | Creato il 23 dic 1999 Consegnato il 12 gen 2000 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee (the security trustee) under the second supplemental deed of charge | |
Brevi particolari All rights title interest and benefit present and future in to and under the supplemental pubmaster deed of charge including all rights to receive payment of any amounts which may become payable to the issuer thereunder and all payments received by the issuer thereunder. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0