NTL UK CABLECOMMS HOLDINGS LLC

NTL UK CABLECOMMS HOLDINGS LLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Società estera
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNTL UK CABLECOMMS HOLDINGS LLC
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaSocietà estera
    Numero di società FC023130
    GiurisdizioneRegno Unito
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Dove si trova NTL UK CABLECOMMS HOLDINGS LLC?

    Indirizzo della sede legale
    251 Little Falls Drive
    Wilmington
    Delaware De 19808
    United States
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di NTL UK CABLECOMMS HOLDINGS LLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    NTL UK CABLECOMMS HOLDINGS, INC.11 apr 200111 apr 2001

    Quali sono gli ultimi bilanci di NTL UK CABLECOMMS HOLDINGS LLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2016

    NTL UK CABLECOMMS HOLDINGS LLC è una società estera

    Requisiti contabili per le società estere
    Tipo di conto esteroNon si applicano i requisiti contabili del paese di origine
    Condizioni di pubblicazione dei contiData di riferimento contabile assegnata da Companies House
    Attività commercialeTo Act As Management Holding And Investment Company
    Forma giuridicaPrivate General Corporation With Limited Liability
    È un istituto di credito o finanziarioNo
    Regolato daGeneral Corprorate Law Of The State Of Delaware
    Paese di registro di origineUNITED STATES
    Luogo di registrazioneOffice Of Secretary Of State Of Delaware
    Numero di societàNONE

    Quali sono le ultime deposizioni per NTL UK CABLECOMMS HOLDINGS LLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Chiusura dell'istituzione nel Regno Unito BR006008 e della società estera FC023130 il 02 nov 2017

    2 pagineOSDS01

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    3 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    18 pagineAA

    Dettagli modificati per una società estera - 2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware De 19808, Usa

    4 pagineOSCH02

    Nomina di Ntl Cablecomms Group Limited come direttore il 16 dic 2016

    3 pagineOSAP02

    Cessazione della carica di Gillian Elizabeth James come segretario in data 16 dic 2016

    2 pagineOSTM02

    Cessazione della carica di Mine Ozkan Hifzi come amministratore in data 16 dic 2016

    2 pagineOSTM01

    Cessazione della carica di Robert Dominic Dunn come amministratore in data 16 dic 2016

    2 pagineOSTM01

    Cambio della denominazione sociale" di una società estera in data 15 mar 2017 da {change_name}

    4 pagineOSNM01

    Modifiche ai documenti costitutivi" in data 16 dic 2016

    13 pagineOSCC01

    Dettagli modificati per una sede nel Regno Unito - BR006008 Name Change Ntl uk cablecomms holdings, inc.,16 dic 2016

    3 pagineOSCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    18 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    3 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    19 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    19 pagineAA

    Nomina di un direttore

    3 pagineOSAP01

    Cessazione della carica di Caroline Withers come amministratore

    2 pagineOSTM01

    Cessazione della carica di Robert Gale come amministratore

    2 pagineOSTM01

    Nomina di un direttore

    3 pagineOSAP01

    Dettagli modificati per una società estera - 160 Greentree Drive, Suite 101, Dover Delaware 19904, Usa, United States

    4 pagineOSCH02

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    29 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di NTL UK CABLECOMMS HOLDINGS LLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NTL CABLECOMMS GROUP LIMITED
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3024703
    230221650001
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    British72139660003
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Segretario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Amministratore
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    DEW, Bryony
    2 Winton Road
    GU9 9QW Farnham
    Surrey
    Amministratore
    2 Winton Road
    GU9 9QW Farnham
    Surrey
    British70776760001
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish179134020002
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish182167230001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Amministratore
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    ROBERTS, Gareth Nigel Christopher
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    Amministratore
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    British145824690001
    ROSS, Stuart
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    Amministratore
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    EnglandBritish20168110001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164134250001
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish140137570002

    NTL UK CABLECOMMS HOLDINGS LLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Confirmation deed
    Creato il 15 apr 2010
    Consegnato il 29 apr 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 29 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An alternative bridge charge over shares
    Creato il 16 giu 2006
    Consegnato il 29 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interest in and to the shares and all rights moneys benefits and other property which mat accrue. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Alternative Bridge Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 29 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 03 mar 2006
    Consegnato il 10 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its rights title and interest in and to the shares by way of first equitable charge. By way of first fixed charge all rights moneys benefits and other property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 10 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A pledge agreement
    Creato il 13 apr 2004
    Consegnato il 21 apr 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any of the obligors to the secured party, any receiver or delegate, the facility agent or any of the lenders under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A first priority security interest in the pledged collateral. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston
    Transazioni
    • 21 apr 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Share charge agreement between the company and chase manhattan international limited as second security trustee for the secured parties (the "second security trustee")
    Creato il 27 set 2001
    Consegnato il 05 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligation due or to become due from any obligor (as defined to any secured party under the finance party whether present or future actual or contingent (and whether solely or jointly as principal or surety or in some other capacity)
    Brevi particolari
    11 deferred shares of £1 each & 11 warrant bearer ordinary shares of us$0.01 Each in ntl sideoffer limited, 9 deferred shares of £1 each and 9 warrant bearer shares of us$0.01 Each in ntl streetwarm services limited tgether with all dividends interest and other monies payable thereunder (for full details of all charged shares please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited
    Transazioni
    • 05 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Pledge agreement
    Creato il 27 set 2001
    Consegnato il 10 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums,liabilities and obligations whatsoever due or to become due from any of the obligors (as defined) to the secured party,any receiver or delegate (all terms as defined),the chargee or any of the term banks 9AS defined) under the finance documents (as defined) including those amounts arising by way of guarantee and indemnity under the credit agreement (as defined)
    Brevi particolari
    All rights,title and interest in any shares or other equity interests in any corporations including all stocks,certificates or other documents thereunder. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited,London,as Second Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 10 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 27 set 2001
    Consegnato il 10 ott 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All sums,liabilities and obligations whatsoever due or to become due from any of the obligors (as defined) to the secured party,any receiver or delegate (all terms as defined),the chargee or any of the term banks 9AS defined) under the finance documents (as defined) including those amounts arising by way of guarantee and indemnity under the credit agreement (as defined)
    Brevi particolari
    All right,title and interest into all accounts,inventory,general intangibles,documents and all instruments; all property,equipment,fixtures,deposits accounts and all books,records,files,etc. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Chase Manhattan International Limited,London,as Second Security Trustee for the Secured Parties
    Transazioni
    • 10 ott 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0