NTL (TRIANGLE) LLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Società estera
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNTL (TRIANGLE) LLC
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaSocietà estera
    Numero di società FC023131
    Numero di registrazione esternoNONE
    GiurisdizioneRegno Unito
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Dove si trova NTL (TRIANGLE) LLC?

    Indirizzo della sede legale
    251 Little Falls Drive
    Wilmington
    Delaware De 19808
    United States
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di NTL (TRIANGLE) LLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    NTL (TRIANGLE) LLC è una società estera

    Requisiti contabili per le società estere
    Tipo di conto esteroNon si applicano i requisiti contabili del paese di origine
    Condizioni di pubblicazione dei contiData di riferimento contabile assegnata da Companies House
    Attività commercialeBank Borrowing, Investment And Inter-Company Funding
    Forma giuridicaPrivate Limited Liability Company
    È un istituto di credito o finanziarioNo
    Regolato daLimited Liability Act Of State Of Delaware
    Paese di registro di origineUNITED STATES
    Luogo di registrazioneOffice Of The Secretary Of State Of Delaware
    Numero di societàNONE

    Quali sono le ultime deposizioni per NTL (TRIANGLE) LLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Chiusura dell'istituzione nel Regno Unito BR006009 e della società estera FC023131 il 02 dic 2020

    2 pagineOSDS01

    Cessazione della carica di Severina-Pompilia Pascu come amministratore in data 16 nov 2020

    2 pagineOSTM01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    3 pagineMR04

    Nomina di Caroline Bernadette Elizabeth Withers come direttore il 23 apr 2020

    3 pagineOSAP01

    Nomina di Roderick Gregor Mcneil come direttore il 09 mar 2020

    3 pagineOSAP01

    Nomina di Severina-Pompilia Pascu come direttore il 03 mar 2020

    3 pagineOSAP01

    Cessazione della carica di William Thomas Castell come amministratore in data 09 mar 2020

    2 pagineOSTM01

    Dettagli modificati per una sede nel Regno Unito - BR006009 Address Change Media house bartley wood, business park, hook, hampshire, RG27 9UP,02 dic 2019

    3 pagineOSCH01

    Nomina di William Thomas Castell come direttore il 09 set 2019

    3 pagineOSAP01

    Cessazione della carica di Robert Dominic Dunn come amministratore in data 09 set 2019

    2 pagineOSTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    21 pagineAA

    Dettagli modificati per una società estera - Ic Change 17/05/19

    4 pagineOSCH02

    Modifiche ai documenti costitutivi" in data 17 mag 2019

    13 pagineOSCC01

    Dettagli modificati per una società estera - Ic Change 17/05/19

    4 pagineOSCH02

    Dettagli modificati per una società estera - Ic Change 10/07/18

    2 pagineOSCH02

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    18 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    18 pagineAA

    Dettagli modificati per una società estera - 2711 Centreville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware De 19808, Usa

    4 pagineOSCH02

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    17 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    3 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    18 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    20 pagineAA

    Nomina di un direttore

    3 pagineOSAP01

    Chi sono gli amministratori di NTL (TRIANGLE) LLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JAMES, Gillian Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Segretario
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    British72139660003
    HIFZI, Mine Ozkan
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish182167230001
    MCNEIL, Roderick Gregor
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    Amministratore
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    EnglandBritish267964620001
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    Amministratore
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    United KingdomBritish248424940001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Segretario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    British47785600002
    CARTER, Stephen Andrew
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    Amministratore
    22 Melville Road
    Barnes
    SW13 9RJ London
    United KingdomBritish59445920002
    CASTELL, William Thomas
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish248424970001
    DUNN, Robert Dominic
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish179134020002
    GALE, Robert Charles
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    EnglandBritish96956740001
    MACKENZIE, Robert Mario
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    Amministratore
    Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    19
    United KingdomBritish47785600002
    PASCU, Severina-Pompilia
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    Amministratore
    Brook Drive
    RG2 6UU Reading
    500
    United Kingdom
    SwitzerlandRomanian267797160001
    ROBERTS, Gareth Nigel Christopher
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    Amministratore
    20 Aspen Lodge
    Abbots Walk
    W8 5UN London
    British145824690001
    ROSS, Stuart
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    Amministratore
    15 Mckay Road
    SW20 0HT London
    EnglandBritish20168110001
    TILLBROOK, Joanne Christine
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164134250001
    WITHERS, Caroline Bernadette Elizabeth
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartley Wood Business Park
    RG27 9UP Hook
    Media House
    Hampshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish140137570002

    NTL (TRIANGLE) LLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Confirmation deed
    Creato il 15 apr 2010
    Consegnato il 29 apr 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors (or any one or more of them) to the senior finance parties (or any one or more of them) on any account whatosover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The chargor acknowledges and agrees to the new sfa and the transactions contemplated thereby and confirm all payment and performance obligations contingent or otherwise and undertakings arising under or in connection with its respective agreements, guarantees, pledges and grants of encumbrances under and subject to the terms of the group intercreditor agreement and each security document to which it is party. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 29 apr 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 10 dic 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    An alternative bridge charge over shares
    Creato il 16 giu 2006
    Consegnato il 29 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee and all monies due or to become due from the alternative bridge obligors (or any one or more of them) to the alternative bridge finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interest in and to the shares and all rights moneys benefits and other property which mat accrue. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Alternative Bridge Trustee for the Beneficiaries
    Transazioni
    • 29 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge
    Creato il 03 mar 2006
    Consegnato il 10 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due to the chargee, from the obligors (or any one or more of them) to the finance parties (or any one or more of them) on any account whatsoever, from all or any of the obligors to the restructuring swap counterparties and/or the existing hedge counter parties and to the new hedge counterparties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All its rights title and interest in and to the shares by way of first equitable charge. By way of first fixed charge all rights moneys benefits and other property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch (As Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 10 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 nov 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A share charge agreement
    Creato il 23 dic 2004
    Consegnato il 29 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged portfolio being the shares and applicable related assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 29 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A share charge agreement
    Creato il 24 giu 2004
    Consegnato il 30 giu 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors or any of them to the secured parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged portfolio being the shares and applicable related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse First Boston
    Transazioni
    • 30 giu 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 ott 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0