NEVIS LEASING LIMITED

NEVIS LEASING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Società estera
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàNEVIS LEASING LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaSocietà estera
    Numero di società FC026796
    GiurisdizioneRegno Unito
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Dove si trova NEVIS LEASING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    47 Esplanade
    St Helier
    JE1 0BD Jersey
    Channel Islands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di NEVIS LEASING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2015

    NEVIS LEASING LIMITED è una società estera

    Requisiti contabili per le società estere
    Tipo di conto esteroNon si applicano i requisiti contabili del paese di origine
    Condizioni di pubblicazione dei contiData di riferimento contabile assegnata da Companies House
    Attività commercialeOwning And Leasing Vessels
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    È un istituto di credito o finanziarioNo
    Regolato daCompanies (Jersey) Law 1991 (As Amended)
    Paese di registro di origineCHANNEL ISLANDS
    Luogo di registrazioneThe Companies Registry, Jersey
    Numero di società93443

    Quali sono le ultime deposizioni per NEVIS LEASING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Chiusura dell'istituzione nel Regno Unito BR008808 e della società estera FC026796 il 30 giu 2017

    2 pagineOSDS01

    Cessazione della carica di Colin Graham Dowsett come amministratore in data 16 nov 2016

    2 pagineOSTM01

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    3 pagineMR04

    Cessazione della carica di Richard Owen Williams come amministratore in data 19 set 2016

    2 pagineOSTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    14 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    16 pagineAA

    Cessazione della carica di Crills Secretaries Limited come segretario

    2 pagineOSTM02

    Cessazione della carica di Simon Gledhill come amministratore

    2 pagineOSTM01

    Cessazione della carica di Paul Gittins come segretario

    2 pagineOSTM02

    Nomina di Michelle Antoinete Angela Johnson come segretario

    3 pagineOSAP03

    Nomina di un direttore

    3 pagineOSAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    17 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di Andrew Cumming come amministratore

    2 pagineOSTM01

    Nomina di un direttore

    3 pagineOSAP01

    Cessazione della carica per una sede nel Regno Unito - Transaction OSTM03- BR008808 Person Authorised to Represent terminated 30/09/2011 lambertus hendrik veldhuizen

    2 pagineOSTM03

    Cessazione della carica di Lambertus Veldhuizen come amministratore

    2 pagineOSTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2010

    18 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    20 pagineAA

    Cessazione della carica di Aidan Smith come amministratore

    2 pagineOSTM01

    Cessazione della carica di Ian Atkinson come amministratore

    2 pagineOSTM01

    Cessazione della carica di David Shindler come amministratore

    2 pagineOSTM01

    Nomina di un direttore

    3 pagineOSAP01

    Nomina di un direttore

    3 pagineOSAP01

    Chi sono gli amministratori di NEVIS LEASING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    JOHNSON, Michelle Antoinete Angela
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st Floor East Tower House
    Cheshire
    Segretario
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    1st Floor East Tower House
    Cheshire
    British181597670001
    FOX, Gerard Ashley
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United Kingdom
    EnglandBritish179100520001
    GITTINS, Paul
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Charterhall House
    Cheshire
    Segretario
    Charterhall Drive
    CH88 3AN Chester
    Charterhall House
    Cheshire
    British45660860003
    CRILLS SECRETARIES LIMITED
    44 Esplanade
    St. Helier
    Je4 8pn
    Jersey
    Segretario
    44 Esplanade
    St. Helier
    Je4 8pn
    Jersey
    112997890001
    ATKINSON, Ian Muir
    Avalon Gardens
    Linlithgow Bridge
    EH49 7PL Linlithgow
    84
    West Lothian
    Scotland
    Amministratore
    Avalon Gardens
    Linlithgow Bridge
    EH49 7PL Linlithgow
    84
    West Lothian
    Scotland
    ScotlandBritish133052170001
    CARLSSON, Svante Wilhelm
    Terragatan 5
    FOREIGN Se 411 83 Gothenburg
    Sweden
    Amministratore
    Terragatan 5
    FOREIGN Se 411 83 Gothenburg
    Sweden
    SwedenSwedish126524710001
    CUMMING, Andrew John
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    Amministratore
    Gresham Street
    EC2V 7HN London
    25
    United KingdomBritish46297770002
    DOWSETT, Colin Graham
    Aldershot Road
    GU51 3NN Fleet
    26a
    Hampshire
    Amministratore
    Aldershot Road
    GU51 3NN Fleet
    26a
    Hampshire
    EnglandBritish152332230001
    DRURY, Charles Esmond Hill
    Ladywell House
    HR2 0RE Turnastone
    Herefordshire
    Amministratore
    Ladywell House
    HR2 0RE Turnastone
    Herefordshire
    WalesBritish59871850002
    GLEDHILL, Simon Christopher
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United KingdomBritish152766650001
    PERCY, Michael Hugh
    32 Hazlewell Road
    SW15 6LH London
    Amministratore
    32 Hazlewell Road
    SW15 6LH London
    EnglandBritish20962040001
    PETERS, Stephen John
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    Amministratore
    Old Swan Cottage
    9 London Road
    TN16 1BB Westerham
    Kent
    British56296720007
    POUTEAUX, Andrew John
    Thorsby 26
    Crownpits Lane
    GU7 1PB Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Thorsby 26
    Crownpits Lane
    GU7 1PB Godalming
    Surrey
    British62522880002
    SHINDLER, David Lawrence
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Berkeley Close
    WD6 3JN Elstree
    Hertfordshire
    British92235400001
    SMITH, Aidan John
    Terrilands
    HA5 3AJ Pinner
    4
    Middlesex
    Amministratore
    Terrilands
    HA5 3AJ Pinner
    4
    Middlesex
    EnglandBritish131026160001
    VELDHUIZEN, Lambertus Hendrik
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    33
    United KingdomDutch152683120001
    WALSH, Kenton
    Winter House
    83 Hedgerley Lane
    HP9 2JS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Winter House
    83 Hedgerley Lane
    HP9 2JS Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish125918020001
    WILLIAMS, Richard Owen
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    6th Floor 33
    England
    Amministratore
    Old Broad Street
    EC2N 1HZ London
    6th Floor 33
    England
    EnglandBritish164554190001

    NEVIS LEASING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage
    Creato il 04 dic 2007
    Consegnato il 20 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as stena vitae limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    64/64 shares in the ship (being M.V. stena trader) and appurtenances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stena Tulip Limited
    Transazioni
    • 20 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage
    Creato il 04 dic 2007
    Consegnato il 20 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as stena vitae limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    64/64 shares in the ship (being M.V. stena traveller) and appurtenances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stena Anglia Limited
    Transazioni
    • 20 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Lessor proceeds account relating to "stena traveller"
    Creato il 04 dic 2007
    Consegnato il 20 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a stena vitae limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The lessor proceeds account moneys. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stena Anglia Limited
    Transazioni
    • 20 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant re "stena traveller"
    Creato il 04 dic 2007
    Consegnato il 20 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a stena vitae limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The ship and proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stena Anglia Limited
    Transazioni
    • 20 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Lessor proceeds account charge relating to "stena trader"
    Creato il 04 dic 2007
    Consegnato il 20 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a stena vitae limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The lessor proceeds account moneys. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stena Tulip Limited
    Transazioni
    • 20 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenant re M.V. "stena trader"
    Creato il 04 dic 2007
    Consegnato il 20 dic 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a stena vitae limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The ship "stena trader" and all proceeds. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stena Tulip Limited
    Transazioni
    • 20 dic 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of assignment of insurances and requisition compensation
    Creato il 09 ago 2006
    Consegnato il 21 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from stena tulip limited to the banks or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights in and to the insurances of the ship stena trader, requisition compensation,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transazioni
    • 21 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Deed of covenants
    Creato il 09 ago 2006
    Consegnato il 21 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from stena tulip limited to the banks or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights in the ship stena trader official number 737906,. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transazioni
    • 21 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First priority mortgage
    Creato il 07 ago 2006
    Consegnato il 21 ago 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from stena tulip limited to the banks or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Sixty four sixty fourth shares in the ship stena trader official number 737906,. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Dnb Nor Bank Asa
    Transazioni
    • 21 ago 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Novation of receivables purchase agreement
    Creato il 18 mag 2006
    Consegnato il 01 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's rights, title and interest in and to its right under or pursuant to a loan agreement dated 15TH may 2006 relation to the ship. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stena (Switzerland) Ag (the Receivables Purchaser)
    Transazioni
    • 01 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Novation of receivables purchase agreement
    Creato il 18 mag 2006
    Consegnato il 01 giu 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the company's rights, title and interest in and to its right under or pursuant to a loan agreement dated 15TH may 2006 relation to the ship. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Stena (Switzerland) Ag (the Receivables Purchaser)
    Transazioni
    • 01 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0