CARE HOMES NO. 1 LIMITED

CARE HOMES NO. 1 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Società estera
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCARE HOMES NO. 1 LIMITED
    Stato della societàConvertita/Chiusa
    Forma giuridicaSocietà estera
    Numero di società FC027201
    Numero di registrazione esterno71496
    GiurisdizioneRegno Unito
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Dove si trova CARE HOMES NO. 1 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Walkers Corporate Limited Cayman Corporate Centre
    27 Hospital Road
    George Town
    Grand Cayman Ky1-9008
    Cayman Islands
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di CARE HOMES NO. 1 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2020

    CARE HOMES NO. 1 LIMITED è una società estera

    Requisiti contabili per le società estere
    Tipo di conto esteroNon si applicano i requisiti contabili del paese di origine
    Condizioni di pubblicazione dei contiData di riferimento contabile assegnata da Companies House
    Attività commercialeThe Company Holds Long Leasehold Interests In Properties
    Forma giuridicaCompany Limited By Shares
    È un istituto di credito o finanziarioNo
    Regolato daThe Companies Law (2004 Revision) Of The Cayman Islands
    Paese di registro di origineCAYMAN ISLANDS
    Luogo di registrazioneCompany Registry, Cayman Islands
    Numero di società71496

    Quali sono le ultime deposizioni per CARE HOMES NO. 1 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Chiusura dell'istituzione nel Regno Unito BR009123 e della società estera FC027201 il 20 dic 2021

    2 pagineOSDS01

    Bilancio redatto al 30 set 2020

    21 pagineAA

    Nomina di Mr James Walter Tugendhat come direttore il 14 set 2020

    3 pagineOSAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2019

    17 pagineAA

    Cessazione della carica di James Justin Hutchens come amministratore in data 05 feb 2020

    2 pagineOSTM01

    Bilancio redatto al 30 set 2018

    18 pagineAA

    Nomina di Mr James Justin Hutchens come direttore il 26 set 2017

    4 pagineOSAP01
    Note
    DataNota
    15 mar 2018Clarification THIS DOCUMENT IS A SECOND FILING OF THE FORM OSAP01 REGISTERED ON 23/10/2017.

    Bilancio redatto al 30 set 2017

    18 pagineAA

    Nomina di Mr James Justin Hutchens come direttore il 06 ott 2017

    4 pagineOSAP01
    Note
    DataNota
    15 mar 2018Clarification A SECOND FILED OSAP01 WAS REGISTERED ON 15/03/2018.

    Cessazione della carica di Chaitanya Bhupendra Patel come amministratore in data 06 ott 2017

    2 pagineOSTM01

    Dettagli modificati per una società estera - M&C Corporate Services Limited, P.O. Box 309Gt, Ugland House, South Church Street, Grand Cayman, Cayman Islands, Cayman Islands

    4 pagineOSCH02

    Dettagli modificati per una sede nel Regno Unito - BR009123 Address Change Liberty house 222 regent street, london, W1B 5TR,19 set 2017

    3 pagineOSCH01

    Bilancio redatto al 30 set 2016

    17 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 set 2015

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Jeremy Michael Jorgen Malherbe Jensen come amministratore in data 06 feb 2015

    2 pagineOSTM01

    Cessazione della carica di Paul Hugh Thompson come amministratore in data 06 feb 2015

    2 pagineOSTM01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come direttore il 06 feb 2015

    3 pagineOSAP01

    Nomina di Chaitanya Bhupendra Patel come direttore il 06 feb 2015

    3 pagineOSAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2014

    15 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    3 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    3 pagineMR04

    Bilancio redatto al 30 set 2013

    16 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 set 2012

    15 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 set 2011

    15 pagineAA

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    15 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di CARE HOMES NO. 1 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MAPLE SECRETARIES LIMITED
    PO BOX 1093gt
    Queensgate House
    South Church Street
    Grand Cayman
    Caymanislands
    Segretario
    PO BOX 1093gt
    Queensgate House
    South Church Street
    Grand Cayman
    Caymanislands
    117624480001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    Amministratore
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    United KingdomBritish147997950001
    TUGENDHAT, James Walter
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    Amministratore
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    United KingdomBritish218306870001
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Amministratore
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    British98778780002
    FARNELL, Adrian Colin
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    Amministratore
    Whitestrand Gadshill Road
    Charlton Kings
    GL53 8EF Cheltenham
    Gloucestershire
    EnglandBritish43015720002
    GRANT, Michael John
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    Amministratore
    Edwill Way
    BR3 6RY Beckenham
    73
    Kent
    EnglandBritish141668610001
    HENDERSON-CLELAND, Hugh
    91 Carlton Avenue
    Dulwich
    SE21 7DF London
    Amministratore
    91 Carlton Avenue
    Dulwich
    SE21 7DF London
    British117624980001
    HUTCHENS, James Justin
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    Amministratore
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    United KingdomAmerican238334580002
    JENSEN, Jeremy Michael Jorgen Malherbe
    Chiswick Quay
    W4 3UR London
    25
    Amministratore
    Chiswick Quay
    W4 3UR London
    25
    EnglandBritish108268030003
    MIDMER, Richard Neil
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    Amministratore
    The Garden House
    30a Clare Lawn Avenue
    SW14 8BG London
    EnglandBritish110640170001
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Amministratore
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    British98781970001
    NICHOLSON, Daniel Christopher
    181 Seagrave Road
    SW6 1ST London
    Amministratore
    181 Seagrave Road
    SW6 1ST London
    EnglandBritish77890230001
    PATEL, Chaitanya Bhupendra
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    Amministratore
    Archer Street
    DL3 6AH Darlington
    Southgate House
    County Durham
    United Kingdom
    United KingdomBritish63915280004
    TAYLOR, Paul Vincent
    Destiny
    49 The Highway
    SM2 5QS South Sutton
    Surrey
    Amministratore
    Destiny
    49 The Highway
    SM2 5QS South Sutton
    Surrey
    United KingdomBritish71978710001
    THOMPSON, Paul Hugh
    St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    15b
    Kent
    Amministratore
    St Johns Road
    TN13 3LR Sevenoaks
    15b
    Kent
    EnglandBritish100977220001

    CARE HOMES NO. 1 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A deed of mortgage/charge
    Creato il 15 gen 2007
    Consegnato il 01 feb 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h and l/h unregistered property (if any) including without limitation all that property more particularly set out in part ii of schedule 1 to the deed of mortgage and all property registered at land registry of northern ireland including all that property more particularly set out in part iii of schedule 1 to the deed of mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse
    Transazioni
    • 01 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security deed
    Creato il 15 gen 2007
    Consegnato il 30 gen 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Suisse, London Branch
    Transazioni
    • 30 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of mortgage/charge
    Creato il 12 dic 2006
    Consegnato il 21 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rockfield nursing home, windmill road, newry, county down t/n 244L and DN33033050. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Trustee for the Finance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite debenture
    Creato il 12 dic 2006
    Consegnato il 21 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the chargors to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 21 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 gen 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0