HUNTLEIGH RENRAY LIMITED

HUNTLEIGH RENRAY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHUNTLEIGH RENRAY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società NI006709
    GiurisdizioneIrlanda del Nord
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HUNTLEIGH RENRAY LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova HUNTLEIGH RENRAY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Moore Stephens
    Waterford House
    BT52 1NB 32 Lodge Road
    Coleraine
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di HUNTLEIGH RENRAY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HUNTLEIGH RENRAY LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per HUNTLEIGH RENRAY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 10 ott 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 ott 2015

    Stato del capitale al 12 ott 2015

    • Capitale: GBP 8,400,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Christoffer David Erik Franzen come amministratore in data 08 lug 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Harnish Mathuradas Hadani come amministratore in data 08 lug 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Claes Bronsgaard Pedersen come amministratore in data 01 mar 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Nicolaas Wilko Van Den Belt come amministratore in data 01 mar 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 10 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 nov 2014

    Stato del capitale al 10 nov 2014

    • Capitale: GBP 8,400,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013

    12 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    8 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    10 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Nomina di Mr Christoffer David Erik Franzen come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Richard Mark Bloom come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alexander Myers come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 10 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 ott 2013

    Stato del capitale al 10 ott 2013

    • Capitale: GBP 8,400,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Robert Nicolaas Wilko Van Den Belt come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Leif Martensson come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 10 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011

    6 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Richard Mark Bloom il 09 feb 2012

    1 pagineCH03

    Bilancio annuale redatto al 10 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di HUNTLEIGH RENRAY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BLOOM, Richard Mark
    C/O Moore Stephens
    Waterford House
    BT52 1NB 32 Lodge Road
    Coleraine
    Segretario
    C/O Moore Stephens
    Waterford House
    BT52 1NB 32 Lodge Road
    Coleraine
    British118671260002
    BLOOM, Richard Mark
    C/O Moore Stephens
    Waterford House
    BT52 1NB 32 Lodge Road
    Coleraine
    Amministratore
    C/O Moore Stephens
    Waterford House
    BT52 1NB 32 Lodge Road
    Coleraine
    EnglandBritishLegal Counsel118671260002
    HADANI, Harnish Mathuradas
    C/O Moore Stephens
    Waterford House
    BT52 1NB 32 Lodge Road
    Coleraine
    Amministratore
    C/O Moore Stephens
    Waterford House
    BT52 1NB 32 Lodge Road
    Coleraine
    EnglandBritishAccountant168756590001
    PEDERSEN, Claes Bronsgaard
    C/O Moore Stephens
    Waterford House
    BT52 1NB 32 Lodge Road
    Coleraine
    Amministratore
    C/O Moore Stephens
    Waterford House
    BT52 1NB 32 Lodge Road
    Coleraine
    DenmarkDanishCfo196379050001
    NEWBERY, Richard Charles William
    De Freville Avenue
    CB4 1HW Cambridge
    25
    Cambridgeshire
    Segretario
    De Freville Avenue
    CB4 1HW Cambridge
    25
    Cambridgeshire
    British40606130001
    BERG, Carl John Michael
    Viggo Rothes Vej 2
    2920 Charlottenlund
    Denmark
    Amministratore
    Viggo Rothes Vej 2
    2920 Charlottenlund
    Denmark
    SwedishCompany Vice President120256430001
    BIBBY, Geoffrey Frank Harold
    South Dalton, Willington Lane
    Clotton
    CW6 OHQ Nr. Tarporley
    Cheshire
    Amministratore
    South Dalton, Willington Lane
    Clotton
    CW6 OHQ Nr. Tarporley
    Cheshire
    BritishChartered Accountant144417230001
    COX, Geoffrey Alan
    34 Carlton Avenue
    Streetly
    BT74 3JJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    34 Carlton Avenue
    Streetly
    BT74 3JJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector29538330002
    FRANZEN, Christoffer David Erik
    C/O Moore Stephens
    Waterford House
    BT52 1NB 32 Lodge Road
    Coleraine
    Amministratore
    C/O Moore Stephens
    Waterford House
    BT52 1NB 32 Lodge Road
    Coleraine
    EnglandSwedishFinance Director188458510001
    FRISTEDT, Ulf Stefan
    Pannagatan 1
    26263 Angelholm
    Sweden
    Amministratore
    Pannagatan 1
    26263 Angelholm
    Sweden
    SwedishChief Financialo Officer120256180002
    MARTENSSON, Leif Erik
    21618 Malmo
    Linnegatan 116
    Sweden
    Amministratore
    21618 Malmo
    Linnegatan 116
    Sweden
    SwedenSwedishCompany Director153479400001
    MYERS, Alexander Walter
    21774 Malmo
    Vikingsbergsvagen 36
    Sweden
    Amministratore
    21774 Malmo
    Vikingsbergsvagen 36
    Sweden
    SwedenSwedishCompany Director111506420001
    SCHILD, David Lucien
    5 Byron Drive
    London
    N2 0BD
    Amministratore
    5 Byron Drive
    London
    N2 0BD
    BritishCompany Director36272940001
    SCHILD, Julian Dominic
    31 Blomfield Road
    London
    W9 1AA
    Amministratore
    31 Blomfield Road
    London
    W9 1AA
    EnglandBritishChartered Accountant25341360003
    SMITH, Craig Harold
    The Flint House
    131 Abbots Road
    WD5 0BJ Abbots Langley
    Herts, England
    Amministratore
    The Flint House
    131 Abbots Road
    WD5 0BJ Abbots Langley
    Herts, England
    BritishAccountant144417280001
    SOKEL, Jeremy Nigel
    20 Redington Gardens
    Hampstead
    NW3 7SA London
    England
    Amministratore
    20 Redington Gardens
    Hampstead
    NW3 7SA London
    England
    BritishSolicitor144417250001
    SPIEGELBERG, Anthony William Assheton
    Oulton Park House
    Tarporley
    CW6 9BL Cheshire
    Amministratore
    Oulton Park House
    Tarporley
    CW6 9BL Cheshire
    EnglandBritishCompany Secretary24626450001
    VAN DEN BELT, Robert Nicolaas Wilko
    C/O Moore Stephens
    Waterford House
    BT52 1NB 32 Lodge Road
    Coleraine
    Amministratore
    C/O Moore Stephens
    Waterford House
    BT52 1NB 32 Lodge Road
    Coleraine
    SwedenDutchCfo175232950001

    HUNTLEIGH RENRAY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage or charge
    Creato il 29 ott 1997
    Consegnato il 04 nov 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Debenture freehold and leasehold property of the company together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery from time to time on or in any such property. All book debts present and future due or owing to the company. All stocks shares and other interests including loans and goodwill. The undertaking and all other property assets and rights of the company both present and future including ( without prejudice tothe generalityof the fore- going) heritable property and all other property and assets in scotland.
    Persone aventi diritto
    • Renray Limited
    • Huntleigh Nesbit
    Transazioni
    • 04 nov 1997Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 01 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 14 giu 1991
    Consegnato il 24 giu 1991
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Debenture by way of fixed charge the freehold and lease property. See doc 89 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Mr Gfh Bibby
    Transazioni
    • 24 giu 1991Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 26 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 12 mag 1989
    Consegnato il 18 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Debenture the companys property described in the schedule. See doc 76 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Bibby Line Group
    Transazioni
    • 18 mag 1989Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 12 feb 1988
    Consegnato il 01 mar 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Debenture the companys leasehold property described in the attached schedule. See doc 69 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Sir Derek Bibby
    Transazioni
    • 01 mar 1988Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 26 set 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 25 mag 1982
    Consegnato il 11 giu 1982
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage debenture a) a specific equitable charge over the companys estate or interest in all freehold or leasehold properties for the time being belonging to or charged to the company other than the property here inafter described. B) a specific charge over all stocks shares orother securitie in any subsidiary companies for the time being. C) a specific charge over all book and other debts for the time being but so that thecompany shall pay intothe companys account with the bank all moneys which it may receive in respect of such debts and shall not without the prior consent in writing of the bank sell factor discount or other- wise charge or assign the same in favour of any other person or purport to do so and the company shall if called upon to do so by the bank from time to time execute legal assignment of such book debts and other debts to the bank. D) a floating charge over the under- taking and all other property and assets present and future but so that the company shall not without the banks consent create any mortgage or charge ranking in priority to or pari passu with this charge. E) a specific charge over its goodwill and the benefit of any licences.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster
    Transazioni
    • 11 giu 1982Registrazione di un'ipoteca (402 NI)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0