HUNTLEIGH RENRAY LIMITED
Panoramica
Nome della società | HUNTLEIGH RENRAY LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | NI006709 |
Giurisdizione | Irlanda del Nord |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HUNTLEIGH RENRAY LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova HUNTLEIGH RENRAY LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Moore Stephens Waterford House BT52 1NB 32 Lodge Road Coleraine |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di HUNTLEIGH RENRAY LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per HUNTLEIGH RENRAY LIMITED?
Bilancio annuale |
|
---|
Quali sono le ultime deposizioni per HUNTLEIGH RENRAY LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2014 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Christoffer David Erik Franzen come amministratore in data 08 lug 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Harnish Mathuradas Hadani come amministratore in data 08 lug 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Claes Bronsgaard Pedersen come amministratore in data 01 mar 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Robert Nicolaas Wilko Van Den Belt come amministratore in data 01 mar 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 ott 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2013 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 8 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 10 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 5 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Nomina di Mr Christoffer David Erik Franzen come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Richard Mark Bloom come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alexander Myers come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 ott 2013 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2012 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Robert Nicolaas Wilko Van Den Belt come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Leif Martensson come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 ott 2012 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2011 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Richard Mark Bloom il 09 feb 2012 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 10 ott 2011 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di HUNTLEIGH RENRAY LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOOM, Richard Mark | Segretario | C/O Moore Stephens Waterford House BT52 1NB 32 Lodge Road Coleraine | British | 118671260002 | ||||||
BLOOM, Richard Mark | Amministratore | C/O Moore Stephens Waterford House BT52 1NB 32 Lodge Road Coleraine | England | British | Legal Counsel | 118671260002 | ||||
HADANI, Harnish Mathuradas | Amministratore | C/O Moore Stephens Waterford House BT52 1NB 32 Lodge Road Coleraine | England | British | Accountant | 168756590001 | ||||
PEDERSEN, Claes Bronsgaard | Amministratore | C/O Moore Stephens Waterford House BT52 1NB 32 Lodge Road Coleraine | Denmark | Danish | Cfo | 196379050001 | ||||
NEWBERY, Richard Charles William | Segretario | De Freville Avenue CB4 1HW Cambridge 25 Cambridgeshire | British | 40606130001 | ||||||
BERG, Carl John Michael | Amministratore | Viggo Rothes Vej 2 2920 Charlottenlund Denmark | Swedish | Company Vice President | 120256430001 | |||||
BIBBY, Geoffrey Frank Harold | Amministratore | South Dalton, Willington Lane Clotton CW6 OHQ Nr. Tarporley Cheshire | British | Chartered Accountant | 144417230001 | |||||
COX, Geoffrey Alan | Amministratore | 34 Carlton Avenue Streetly BT74 3JJ Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | Director | 29538330002 | ||||
FRANZEN, Christoffer David Erik | Amministratore | C/O Moore Stephens Waterford House BT52 1NB 32 Lodge Road Coleraine | England | Swedish | Finance Director | 188458510001 | ||||
FRISTEDT, Ulf Stefan | Amministratore | Pannagatan 1 26263 Angelholm Sweden | Swedish | Chief Financialo Officer | 120256180002 | |||||
MARTENSSON, Leif Erik | Amministratore | 21618 Malmo Linnegatan 116 Sweden | Sweden | Swedish | Company Director | 153479400001 | ||||
MYERS, Alexander Walter | Amministratore | 21774 Malmo Vikingsbergsvagen 36 Sweden | Sweden | Swedish | Company Director | 111506420001 | ||||
SCHILD, David Lucien | Amministratore | 5 Byron Drive London N2 0BD | British | Company Director | 36272940001 | |||||
SCHILD, Julian Dominic | Amministratore | 31 Blomfield Road London W9 1AA | England | British | Chartered Accountant | 25341360003 | ||||
SMITH, Craig Harold | Amministratore | The Flint House 131 Abbots Road WD5 0BJ Abbots Langley Herts, England | British | Accountant | 144417280001 | |||||
SOKEL, Jeremy Nigel | Amministratore | 20 Redington Gardens Hampstead NW3 7SA London England | British | Solicitor | 144417250001 | |||||
SPIEGELBERG, Anthony William Assheton | Amministratore | Oulton Park House Tarporley CW6 9BL Cheshire | England | British | Company Secretary | 24626450001 | ||||
VAN DEN BELT, Robert Nicolaas Wilko | Amministratore | C/O Moore Stephens Waterford House BT52 1NB 32 Lodge Road Coleraine | Sweden | Dutch | Cfo | 175232950001 |
HUNTLEIGH RENRAY LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Mortgage or charge | Creato il 29 ott 1997 Consegnato il 04 nov 1997 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari All monies. Debenture freehold and leasehold property of the company together with all buildings and fixtures and fixed plant and machinery from time to time on or in any such property. All book debts present and future due or owing to the company. All stocks shares and other interests including loans and goodwill. The undertaking and all other property assets and rights of the company both present and future including ( without prejudice tothe generalityof the fore- going) heritable property and all other property and assets in scotland. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage or charge | Creato il 14 giu 1991 Consegnato il 24 giu 1991 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari All monies. Debenture by way of fixed charge the freehold and lease property. See doc 89 for further details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage or charge | Creato il 12 mag 1989 Consegnato il 18 mag 1989 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari All monies. Debenture the companys property described in the schedule. See doc 76 for further details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage or charge | Creato il 12 feb 1988 Consegnato il 01 mar 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari All monies. Debenture the companys leasehold property described in the attached schedule. See doc 69 for further details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage or charge | Creato il 25 mag 1982 Consegnato il 11 giu 1982 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari All monies. Mortgage debenture a) a specific equitable charge over the companys estate or interest in all freehold or leasehold properties for the time being belonging to or charged to the company other than the property here inafter described. B) a specific charge over all stocks shares orother securitie in any subsidiary companies for the time being. C) a specific charge over all book and other debts for the time being but so that thecompany shall pay intothe companys account with the bank all moneys which it may receive in respect of such debts and shall not without the prior consent in writing of the bank sell factor discount or other- wise charge or assign the same in favour of any other person or purport to do so and the company shall if called upon to do so by the bank from time to time execute legal assignment of such book debts and other debts to the bank. D) a floating charge over the under- taking and all other property and assets present and future but so that the company shall not without the banks consent create any mortgage or charge ranking in priority to or pari passu with this charge. E) a specific charge over its goodwill and the benefit of any licences. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0