AP (NI) (NO.3)

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAP (NI) (NO.3)
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società NI006748
    GiurisdizioneIrlanda del Nord
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AP (NI) (NO.3)?

    • (7499) /

    Dove si trova AP (NI) (NO.3)?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Tughans Solicitors, Marlborough House
    30 Victoria Street
    BT1 3GG Belfast
    Co Antrim Northern Ireland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AP (NI) (NO.3)?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BAIRDS CHEMISTS23 giu 199223 giu 1992
    E.A.BAIRD (HOLYWOOD) LIMITED30 giu 196630 giu 1966

    Quali sono gli ultimi bilanci di AP (NI) (NO.3)?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per AP (NI) (NO.3)?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01
    J134HGWZ

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    6 pagineAA
    J0OA0VS1

    Cessazione della carica di Christopher James Giles come amministratore in data 05 set 2011

    1 pagineTM01
    XY01OY3L

    Nomina di Mr Mark Francis Muller come amministratore in data 05 set 2011

    3 pagineAP01
    JVRKKXY4

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 mag 2011

    Stato del capitale al 31 mag 2011

    • Capitale: GBP 2
    SH01
    XRNLJULU

    legacy

    3 pagineMG02
    JXBLMP0N

    legacy

    3 pagineMG02
    JXEEROL8

    legacy

    3 pagineMG02
    JXK2KNU3

    legacy

    3 pagineMG02
    JXK1PNU7

    legacy

    6 pagineMG02
    JXYYPM4R

    legacy

    5 pagineMG02
    JXYZSM4V

    legacy

    6 pagineMG02
    JXYZRM4U

    legacy

    6 pagineMG02
    JXYO4M4W

    legacy

    6 pagineMG02
    JXYZQM4T

    legacy

    6 pagineMG02
    JXYZPM4S

    legacy

    6 pagineMG02
    JXYZOM4R

    legacy

    6 pagineMG02
    JXZ00M45

    legacy

    6 pagineMG02
    JXYO3M4V

    legacy

    5 pagineMG02
    JXYZZM42

    legacy

    6 pagineMG02
    JXYZYM41

    legacy

    5 pagineMG02
    JXYZXM40

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    XUR2NL1T

    Indirizzo della sede legale modificato da 35-47 Donegal Place Belfast County Antrim BT1 5AD in data 14 giu 2010

    2 pagineAD01
    JYA94KRF

    Chi sono gli amministratori di AP (NI) (NO.3)?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Segretario
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    British150395410001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Amministratore
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritishSolicitor52040210004
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    Amministratore
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    United KingdomBritishDirector63620010002
    JOHNSTON, Colin James
    12 Gowan Heights
    Dunmurry
    BT17 9LZ Belfast
    Segretario
    12 Gowan Heights
    Dunmurry
    BT17 9LZ Belfast
    British144317390001
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Segretario
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    British63620010002
    AU COSEC LIMITED
    Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    Segretario
    Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    68799430002
    AYLWARD, Christopher David
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell Woking
    Surrrey
    Amministratore
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell Woking
    Surrrey
    BritishDirector Of Business Developme144068470001
    BAIRD, Austin Richard
    48 Circular Road
    Belfast
    BT4 2GB
    Amministratore
    48 Circular Road
    Belfast
    BT4 2GB
    Northern IrelandBritishPharmacist143001420001
    GILES, Christopher James
    30 Victoria Street
    BT1 3GG Belfast
    C/O Tughans Solicitors, Marlborough House
    Co Antrim Northern Ireland
    Amministratore
    30 Victoria Street
    BT1 3GG Belfast
    C/O Tughans Solicitors, Marlborough House
    Co Antrim Northern Ireland
    EnglandBritishAccountant149834660001
    HULME, Simon
    The West Wing
    Callaly Castle
    NE66 4TA Whittingham
    Alnwick
    Amministratore
    The West Wing
    Callaly Castle
    NE66 4TA Whittingham
    Alnwick
    United KingdomBritishDirector105524430001
    JOHNSTON, Colin James
    12 Gowan Heights
    Dunmurry
    BT17 9LZ Belfast
    Amministratore
    12 Gowan Heights
    Dunmurry
    BT17 9LZ Belfast
    Northern IrelandBritishChartered Accountant144317390001
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge 15 Oaken Coppice
    Ashtead
    KT21 1DL Surrey
    Amministratore
    Elm Lodge 15 Oaken Coppice
    Ashtead
    KT21 1DL Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant63620010002
    PROSSER, Andrew James Mackenzie
    Tamarind
    Camilla Drive,Westhumble
    RH5 6BU Dorking
    Surrey
    Amministratore
    Tamarind
    Camilla Drive,Westhumble
    RH5 6BU Dorking
    Surrey
    EnglandBritishFinance Director151240810001

    AP (NI) (NO.3) ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 28 giu 2007
    Consegnato il 02 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies debenture. 132/134 sandy row, belfast. 136 sandy row, belfast. 138 and 140 sandy row, belfast. 142 and 144 sandy row, belfast.
    Persone aventi diritto
    • Department for Social Development
    Transazioni
    • 02 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 30 set 2004
    Consegnato il 08 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage / charge land and premises comprised in folio number AN107454 county antrim....... See doc 81 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Ireland
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 08 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 03 ago 2000
    Consegnato il 04 ago 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage. The premises situate at 47 james street, cookstown, county tyrone and 47A james street, cookstown, county tyrone; and by way of assignment the dispensing pharmaceutical licence attached to the premises and by way of fixed security all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment which are not or shall at any time hereafter become the property of the mortgagor.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Markets
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 04 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 28 ago 1998
    Consegnato il 11 set 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Mortgage. Premises situate and known as 2 market square, dungannon, county tyrone together with all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank LTD
    • Ulster Bank Markets
    Transazioni
    • 11 set 1998Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 02 giu 1998
    Consegnato il 04 giu 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Mortgage. Premises situate and known as 3 and 4 market square, dungannon, county tyrone together with the dispensing pharmaceutical licence in relation thereto and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    • Ulster Bank Markets
    Transazioni
    • 04 giu 1998Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 28 gen 1998
    Consegnato il 05 feb 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage. (1) shop and premises situate and known as 47, great james street, londonderry, county londonderry. (2) shop and premises situate at and known as 37, lower road, londonderry, county londonderry. Together with the dispensing pharmaceutical licences in relation thereto and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Markets
    • Ulster Bank LTD
    Transazioni
    • 05 feb 1998Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 09 gen 1998
    Consegnato il 13 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage premises situate at 46, sandy row, belfast in the parish of belfast barony of belfast and county of the city or county borough of belfast together with the dispensing pharmaceutical licence and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment which are now or shall at any time hereafter during the continuance of the mortgage become the property of the company.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank LTD
    • Ulster Bank Markets
    Transazioni
    • 13 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 09 gen 1998
    Consegnato il 13 gen 1998
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage numbers 2 & 4 hillview avenue, cloughfern, newtownabbey in the townland of cloughfern or cloughfern parish of carnmoney barony of lower belfast and county of antrim together with the dispensing pharmaceutical licence and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment which are now or shall at any time hereafter during the continuance of the mortgage become the property of the company.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Markets
    • Ulster Bank LTD
    Transazioni
    • 13 gen 1998Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 11 lug 1997
    Consegnato il 18 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Charge land and premises situate at the shoppin' well shopping centre, 74 main street, ballykelly county londonderry as comprised in land registry folio nos. 20131 and 26447 county londonderry together with all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and together also with the dispensing pharmaceutical licence in respect of the premises.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Markets
    Transazioni
    • 18 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 08 ago 1996
    Consegnato il 12 ago 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage see doc 63 for details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Markets
    Transazioni
    • 12 ago 1996Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 28 giu 1996
    Consegnato il 05 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Assignment of licence licence dated 28/6/96 and made between (1) homefirst community health and social services trust acting on behalf of the department of health and social services for northern ireland and (2) the company in respect of accommodation in the health centre, cushendall road ballymena, county antrim for the provision of pharmaceutical services together with the dispensing phar- maceutical licence in respect of the said accommodation.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank LTD
    Transazioni
    • 05 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 11 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 28 giu 1996
    Consegnato il 04 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage debenture see doc 61 for details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank LTD
    Transazioni
    • 04 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 27 ott 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 27 nov 1995
    Consegnato il 30 nov 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage 70 main street, moira, county down toget her with the dispensing pharmaceutical licence attached thereto and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank LTD
    Transazioni
    • 30 nov 1995Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 31 lug 1995
    Consegnato il 09 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage 76-82 burn road, cookstown, county tyrone and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the despensing pharmaceutical licence attached to 82 burn road, cookstown aforesaid.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Invest. Bank
    Transazioni
    • 09 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 31 lug 1995
    Consegnato il 09 ago 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage 35 james street, cookstown, county tyrone and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and the dispensing pharmaceutical licence attached to the said premises.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Invest. Bank
    Transazioni
    • 09 ago 1995Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 31 dic 1992
    Consegnato il 31 dic 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage debenture see doc 52 fordetails.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Invest. Bank
    Transazioni
    • 31 dic 1992Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 01 lug 1992
    Consegnato il 03 lug 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage debenture see doc 49 for details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Invest. Bank
    Transazioni
    • 03 lug 1992Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0