IRISH FEEDS LIMITED
Panoramica
| Nome della società | IRISH FEEDS LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | NI010146 |
| Giurisdizione | Irlanda del Nord |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di IRISH FEEDS LIMITED?
- Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova IRISH FEEDS LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di IRISH FEEDS LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per IRISH FEEDS LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Modifica dei dettagli di British Salt Limited come persona con controllo significativo il 12 mar 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Dr Ladan Iravanian il 12 mar 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Dr Martin John Ashcroft il 12 mar 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Laurence Abbotts il 12 mar 2020 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Notifica di British Salt Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||||||||||
Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 21 feb 2018 | 2 pagine | PSC09 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2017 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016 | 5 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 11 dic 2015 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Dr Ladan Iravanian come amministratore in data 09 ott 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di John Stephen Melia come amministratore in data 30 set 2015 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Neil Runciman il 01 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per John Stephen Melia il 01 mar 2015 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di IRISH FEEDS LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Segretario | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
| ABBOTTS, Jonathan Laurence | Amministratore | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | United Kingdom | British | 150646060001 | |||||||||
| ASHCROFT, Martin John, Dr | Amministratore | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | England | British | 170663420001 | |||||||||
| IRAVANIAN, Ladan, Dr | Amministratore | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | United Kingdom | British | 151424370002 | |||||||||
| RUNCIMAN, Alan Neil | Amministratore | Winnington Lane CW8 4GW Northwich Natrium House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 151762300001 | |||||||||
| THOMPSON, Christopher William | Segretario | Cranes Lane Lathom L40 5UJ Ormskirk Halfpenny Barn Lancashire United Kingdom | British | 145356080001 | ||||||||||
| VAUGHAN, Mathew Gareth | Segretario | Winnington CW8 4DT Northwich Mond House Cheshire United Kingdom | 151764290001 | |||||||||||
| WARD, David Stuart | Segretario | 2 Ingleton Close Holmes Chapel CW4 7LF Crewe England | 145356020001 | |||||||||||
| BROWN, Timothy Neil | Amministratore | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | England | British | 129108030001 | |||||||||
| CHALLINOR, David | Amministratore | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | United Kingdom | British | 111045130001 | |||||||||
| FORSYTH, Donal A | Amministratore | Ivy Lodge 17 Greenland Drive BT19 6AP Bangor | British | 145356030001 | ||||||||||
| GENT, Alan Stanley | Amministratore | 119 Station Road Marple SK6 6PA Stockport | British | 145356040001 | ||||||||||
| JONES, Robert Owen | Amministratore | Somerford Close Sandbach CW11 1YL Cheshire 7 Uk United Kingdom | United Kingdom | British | 103532410001 | |||||||||
| MELIA, John Stephen | Amministratore | Winnington CW8 4DT Northwich Mond House Cheshire England | United Kingdom | British | 258007910001 | |||||||||
| RUNCIMAN, Alan Neil | Amministratore | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | United Kingdom | British | 151762300001 | |||||||||
| STEVEN, David Andrew, Dr | Amministratore | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | United Kingdom | British | 37384700001 | |||||||||
| THOMPSON, Christopher William | Amministratore | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | England | British | 114283730001 | |||||||||
| VAUGHAN, Mathew Gareth | Amministratore | Sinclair Wharf Stormont Road BT3 9AA Belfast | England | British | 151762730001 | |||||||||
| WESTON, Leslie Derek | Amministratore | Winnington CW8 4DT Northwich Mond House Cheshire | United Kingdom | British | 132971360001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di IRISH FEEDS LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| British Salt Limited | 06 apr 2016 | Winnington Lane CW8 4GW Northwich Natrium House Cheshire United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per IRISH FEEDS LIMITED?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 11 dic 2016 | 20 feb 2018 | La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società. |
IRISH FEEDS LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 18 gen 2011 Consegnato il 25 gen 2011 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery...see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security accession deed | Creato il 18 gen 2011 Consegnato il 25 gen 2011 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery...see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage or charge | Creato il 01 gen 2008 Consegnato il 14 gen 2008 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari All monies a deed of admission supplemental to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 29TH june 2997. any sums or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present and future accounts of the companies or any of them with the bank. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage or charge | Creato il 29 giu 2007 Consegnato il 20 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari All monies composite guarantee and debenture. 1. fixed charges. Each charging company charges and agrees to charge all of its present and future right, title and interest in and to the following assets which are at any time owned by it, or in which it from time to time has an interest:. (A) by wy of legal mortgage:. (I) the property (if any) specified in part 1 of schedule 3 (details of security assets); and. (Ii) all other property (if any) at the date of this deed vested in, or charged to, each charging company (not charged by clause 1 (a) (I));. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage or charge | Creato il 29 giu 2007 Consegnato il 18 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari All monies omnibus guarantee and set-off agreement. The company agreed that it would not assign, mortgage charge or otherwise confer upon any third party any right, title ot interest in all or to all or any of the accounts. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 giu 2007 Consegnato il 18 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari All monies mezzanine debenture. All security created by the chargor as a continuing security for the payment and discharge of the secured obligations. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 29 giu 2007 Consegnato il 18 lug 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari All monies senior debenture. All security created by the chargor as a continuing security for the payment and discharge of the secured obligations. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage or charge | Creato il 04 mar 1992 Consegnato il 13 mar 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari All monies fixed charge on book debts all book debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the charge holder... See doc 49 for further details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage or charge | Creato il 04 mar 1992 Consegnato il 13 mar 1992 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari All monies second floating charge the undertaking of the property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being.. See doc 48 for further details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 25 mag 1988 Consegnato il 01 giu 1988 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Premises at the rear of corporation street and pilot street belfast. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage or charge | Creato il 03 dic 1987 Consegnato il 07 dic 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari All monies allbook debts all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage | Creato il 26 ago 1987 Consegnato il 09 set 1987 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari 63 dock street belfast. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Floating charge | Creato il 21 nov 1979 Consegnato il 26 nov 1979 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The undertaking of the company and all its property. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0