IRISH FEEDS LIMITED

IRISH FEEDS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàIRISH FEEDS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società NI010146
    GiurisdizioneIrlanda del Nord
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di IRISH FEEDS LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova IRISH FEEDS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di IRISH FEEDS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per IRISH FEEDS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2020

    5 pagineAA

    Modifica dei dettagli di British Salt Limited come persona con controllo significativo il 12 mar 2020

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Dr Ladan Iravanian il 12 mar 2020

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Dr Martin John Ashcroft il 12 mar 2020

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jonathan Laurence Abbotts il 12 mar 2020

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di British Salt Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC02

    Revoca di una dichiarazione relativa a una persona con controllo significativo il 21 feb 2018

    2 paginePSC09

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2017

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 dic 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2016

    5 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 mar 2015

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 dic 2015

    Stato del capitale al 16 dic 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Nomina di Dr Ladan Iravanian come amministratore in data 09 ott 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di John Stephen Melia come amministratore in data 30 set 2015

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Neil Runciman il 01 mar 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per John Stephen Melia il 01 mar 2015

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di IRISH FEEDS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione7038430
    146358090001
    ABBOTTS, Jonathan Laurence
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    Amministratore
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    United KingdomBritish150646060001
    ASHCROFT, Martin John, Dr
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    Amministratore
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    EnglandBritish170663420001
    IRAVANIAN, Ladan, Dr
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    Amministratore
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    United KingdomBritish151424370002
    RUNCIMAN, Alan Neil
    Winnington Lane
    CW8 4GW Northwich
    Natrium House
    Cheshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Winnington Lane
    CW8 4GW Northwich
    Natrium House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish151762300001
    THOMPSON, Christopher William
    Cranes Lane
    Lathom
    L40 5UJ Ormskirk
    Halfpenny Barn
    Lancashire
    United Kingdom
    Segretario
    Cranes Lane
    Lathom
    L40 5UJ Ormskirk
    Halfpenny Barn
    Lancashire
    United Kingdom
    British145356080001
    VAUGHAN, Mathew Gareth
    Winnington
    CW8 4DT Northwich
    Mond House
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Winnington
    CW8 4DT Northwich
    Mond House
    Cheshire
    United Kingdom
    151764290001
    WARD, David Stuart
    2 Ingleton Close
    Holmes Chapel
    CW4 7LF Crewe
    England
    Segretario
    2 Ingleton Close
    Holmes Chapel
    CW4 7LF Crewe
    England
    145356020001
    BROWN, Timothy Neil
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    Amministratore
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    EnglandBritish129108030001
    CHALLINOR, David
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    Amministratore
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    United KingdomBritish111045130001
    FORSYTH, Donal A
    Ivy Lodge
    17 Greenland Drive
    BT19 6AP Bangor
    Amministratore
    Ivy Lodge
    17 Greenland Drive
    BT19 6AP Bangor
    British145356030001
    GENT, Alan Stanley
    119 Station Road
    Marple
    SK6 6PA Stockport
    Amministratore
    119 Station Road
    Marple
    SK6 6PA Stockport
    British145356040001
    JONES, Robert Owen
    Somerford Close
    Sandbach
    CW11 1YL Cheshire
    7
    Uk
    United Kingdom
    Amministratore
    Somerford Close
    Sandbach
    CW11 1YL Cheshire
    7
    Uk
    United Kingdom
    United KingdomBritish103532410001
    MELIA, John Stephen
    Winnington
    CW8 4DT Northwich
    Mond House
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Winnington
    CW8 4DT Northwich
    Mond House
    Cheshire
    England
    United KingdomBritish258007910001
    RUNCIMAN, Alan Neil
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    Amministratore
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    United KingdomBritish151762300001
    STEVEN, David Andrew, Dr
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    Amministratore
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    United KingdomBritish37384700001
    THOMPSON, Christopher William
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    Amministratore
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    EnglandBritish114283730001
    VAUGHAN, Mathew Gareth
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    Amministratore
    Sinclair Wharf
    Stormont Road
    BT3 9AA Belfast
    EnglandBritish151762730001
    WESTON, Leslie Derek
    Winnington
    CW8 4DT Northwich
    Mond House
    Cheshire
    Amministratore
    Winnington
    CW8 4DT Northwich
    Mond House
    Cheshire
    United KingdomBritish132971360001

    Chi sono le persone con controllo significativo di IRISH FEEDS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Winnington Lane
    CW8 4GW Northwich
    Natrium House
    Cheshire
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Winnington Lane
    CW8 4GW Northwich
    Natrium House
    Cheshire
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione6398227
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per IRISH FEEDS LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    11 dic 201620 feb 2018La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società.

    IRISH FEEDS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 18 gen 2011
    Consegnato il 25 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery...see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 25 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Security accession deed
    Creato il 18 gen 2011
    Consegnato il 25 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery...see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Standard Chartered Bank
    Transazioni
    • 25 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Mortgage or charge
    Creato il 01 gen 2008
    Consegnato il 14 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies a deed of admission supplemental to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 29TH june 2997. any sums or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present and future accounts of the companies or any of them with the bank.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 16 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 20 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies composite guarantee and debenture. 1. fixed charges. Each charging company charges and agrees to charge all of its present and future right, title and interest in and to the following assets which are at any time owned by it, or in which it from time to time has an interest:. (A) by wy of legal mortgage:. (I) the property (if any) specified in part 1 of schedule 3 (details of security assets); and. (Ii) all other property (if any) at the date of this deed vested in, or charged to, each charging company (not charged by clause 1 (a) (I));.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 20 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 16 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 18 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies omnibus guarantee and set-off agreement. The company agreed that it would not assign, mortgage charge or otherwise confer upon any third party any right, title ot interest in all or to all or any of the accounts.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 16 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 18 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mezzanine debenture. All security created by the chargor as a continuing security for the payment and discharge of the secured obligations.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 16 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 29 giu 2007
    Consegnato il 18 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies senior debenture. All security created by the chargor as a continuing security for the payment and discharge of the secured obligations.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 18 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 16 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 04 mar 1992
    Consegnato il 13 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies fixed charge on book debts all book debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the charge holder... See doc 49 for further details.
    Persone aventi diritto
    • British Salt Limited
    • Middlewich
    Transazioni
    • 13 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 04 mar 1992
    Consegnato il 13 mar 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies second floating charge the undertaking of the property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being.. See doc 48 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Middlewich
    • British Salt LTD
    Transazioni
    • 13 mar 1992Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage
    Creato il 25 mag 1988
    Consegnato il 01 giu 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Premises at the rear of corporation street and pilot street belfast.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited
    Transazioni
    • 01 giu 1988
    • 04 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 03 dic 1987
    Consegnato il 07 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies allbook debts all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank LTD
    Transazioni
    • 07 dic 1987Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage
    Creato il 26 ago 1987
    Consegnato il 09 set 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    63 dock street belfast.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 09 set 1987
    • 04 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Floating charge
    Creato il 21 nov 1979
    Consegnato il 26 nov 1979
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The undertaking of the company and all its property.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited
    Transazioni
    • 26 nov 1979
    • 04 ott 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0