T & A KERNOGHAN (HOLDINGS) LIMITED

T & A KERNOGHAN (HOLDINGS) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàT & A KERNOGHAN (HOLDINGS) LIMITED
    Stato della societàLiquidazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società NI012993
    GiurisdizioneIrlanda del Nord
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di T & A KERNOGHAN (HOLDINGS) LIMITED?

    • Costruzione di edifici residenziali (41202) / Costruzioni
    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova T & A KERNOGHAN (HOLDINGS) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    9 Gibson's Lane
    BT23 4LJ Newtownards
    Co Down
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di T & A KERNOGHAN (HOLDINGS) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    T & A KERNOGHAN LIMITED25 ago 197825 ago 1978

    Quali sono gli ultimi bilanci di T & A KERNOGHAN (HOLDINGS) LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2016
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 dic 2016
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2015

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per T & A KERNOGHAN (HOLDINGS) LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al31 dic 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma14 gen 2017
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per T & A KERNOGHAN (HOLDINGS) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    ScadutoNo

    Quali sono le ultime deposizioni per T & A KERNOGHAN (HOLDINGS) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rendiconto delle entrate e delle uscite al 27 apr 2024

    5 pagine4.69(NI)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite al 27 apr 2023

    5 pagine4.69(NI)

    Stato patrimoniale

    5 pagine2.16B(NI)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite al 27 apr 2022

    5 pagine4.69(NI)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite al 27 apr 2021

    5 pagine4.69(NI)

    Nomina di un liquidatore

    1 pagineVL1

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore al 27 apr 2020

    22 pagine2.24B(NI)

    Notifica di passaggio dall'amministrazione alla liquidazione volontaria dei creditori

    22 pagine2.34B(NI)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore al 02 nov 2019

    22 pagine2.24B(NI)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore al 02 mag 2019

    28 pagine2.24B(NI)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore al 02 nov 2018

    25 pagine2.24B(NI)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore al 02 mag 2018

    23 pagine2.24B(NI)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore al 02 nov 2017

    25 pagine2.24B(NI)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore al 02 mag 2017

    22 pagine2.24B(NI)

    Notifica di proroga del periodo di amministrazione

    1 pagine2.31B(NI)

    Relazione sullo stato di avanzamento dell'amministratore al 02 nov 2016

    10 pagine2.24B(NI)

    Notifica del risultato della riunione dei creditori

    20 pagine2.23B(NI)

    Relazione sulle proposte dell'amministratore

    19 pagine2.17B(NI)

    Indirizzo della sede legale modificato da 5 Blackwater Road Mallusk Newtownabbey Co.Antrim BT36 4TZ a 9 Gibson's Lane Newtownards Co Down BT23 4LJ in data 11 mag 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B(NI)

    Cessazione della carica di Gillian Craig come segretario in data 28 gen 2016

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Richard Thompson il 01 gen 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 31 dic 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital27 gen 2016

    Stato del capitale al 27 gen 2016

    • Capitale: GBP 10,000
    SH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2015

    33 pagineAA

    Cessazione della carica di Rosemary Thompson come amministratore in data 31 mag 2015

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di T & A KERNOGHAN (HOLDINGS) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MCMANUS, Ryan James
    Gibson's Lane
    BT23 4LJ Newtownards
    9
    Co Down
    Amministratore
    Gibson's Lane
    BT23 4LJ Newtownards
    9
    Co Down
    United KingdomBritishQuantity Surveyor195434710001
    THOMPSON, Michael Richard
    Blackwater Road
    BT36 4TZ Newtownabbey
    5
    County Antrim
    Northern Ireland
    Amministratore
    Blackwater Road
    BT36 4TZ Newtownabbey
    5
    County Antrim
    Northern Ireland
    United KingdomBritishManaging Director144089600003
    CRAIG, Gillian
    5 Blackwater Road
    Mallusk
    BT36 4TZ Newtownabbey
    Co.Antrim
    Segretario
    5 Blackwater Road
    Mallusk
    BT36 4TZ Newtownabbey
    Co.Antrim
    198692400001
    MCGINN, Martin
    Rogan Wood
    BT36 4BG Newtownabbey
    9
    County Antrim
    United Kingdom
    Segretario
    Rogan Wood
    BT36 4BG Newtownabbey
    9
    County Antrim
    United Kingdom
    Irish145963170001
    THOMPSON, Rosemary
    15 Twinburn Crescent
    Monkstown
    BT37 0AS Newtownabbey
    Segretario
    15 Twinburn Crescent
    Monkstown
    BT37 0AS Newtownabbey
    144795730001
    WORKMAN, David James
    Maple Lodge
    51 Tullymore Dale
    BT43 7TD Broughshane
    Co Antrim
    Segretario
    Maple Lodge
    51 Tullymore Dale
    BT43 7TD Broughshane
    Co Antrim
    British50964130003
    CRAIG, Gillian Elizabeth
    135 Ard Colgan
    Carndonagh
    Republic Of Ireland
    Amministratore
    135 Ard Colgan
    Carndonagh
    Republic Of Ireland
    Republic Of IrelandBritishDirector163078520001
    CRAIG, Gillian Elizabeth
    904a Antrim Road
    Templpatrick
    BT39 0AH Ballyclare
    Co Antrim
    Amministratore
    904a Antrim Road
    Templpatrick
    BT39 0AH Ballyclare
    Co Antrim
    BritishDevelopment Director144795790001
    KERNOGHAN, Judith
    5 Blackwater Road
    Mallusk
    BT36 4TZ Newtownabbey
    Co.Antrim
    Amministratore
    5 Blackwater Road
    Mallusk
    BT36 4TZ Newtownabbey
    Co.Antrim
    Northern IrelandBritishDirector144466550001
    KERNOGHAN, William Alan
    47 Upper Road
    Greenisland
    BT38 8RH Carrickfergus
    Co.Antrim
    Amministratore
    47 Upper Road
    Greenisland
    BT38 8RH Carrickfergus
    Co.Antrim
    Northern IrelandBritishCo Director7806600001
    LAMBE, David Matthew
    3 Windslow Drive
    Middle Road
    BT38 9BB Carrickfergus
    Co Antrim
    Amministratore
    3 Windslow Drive
    Middle Road
    BT38 9BB Carrickfergus
    Co Antrim
    BritishCompany Director60829280001
    MCNUTT, Gordon
    45 Meadowbank
    Jordanstown
    BT37 0UP Newtownabbey
    Amministratore
    45 Meadowbank
    Jordanstown
    BT37 0UP Newtownabbey
    Northern IrelandBritishCo Director144211180001
    THOMPSON, Rosemary
    15 Twinburn Crescent
    Monkstown
    BT37 0AS Newtownabbey
    Amministratore
    15 Twinburn Crescent
    Monkstown
    BT37 0AS Newtownabbey
    Northern IrelandBritishDirector144795780001
    WORKMAN, David James
    Maple Lodge
    51 Tullymore Dale
    BT43 7TD Broughshane
    Ballymena
    Amministratore
    Maple Lodge
    51 Tullymore Dale
    BT43 7TD Broughshane
    Ballymena
    Northern IrelandBritishDirector & Company Secretary50964130003

    T & A KERNOGHAN (HOLDINGS) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 apr 2015
    Consegnato il 15 mag 2015
    In corso
    Breve descrizione
    All that leasehold land being a parcel of land in the townland of grange of mallusk containing nought decimal five one nought (0.510) of a hectare or thereabouts situate on the east side of blackwater road, hydepark industrial estate, newtownabbey in the county of antrim being all of the land and buildings registered at the land registry with folio number AN1237L county antrim and now known as 5 blackwater road, mallusk.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Hcc International Insurance Company PLC
    Transazioni
    • 15 mag 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Mortgage or charge
    Creato il 25 feb 2009
    Consegnato il 26 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies charge over security account. In connection with a master framework agreement relating to a residential property development at charleville square, tudor 3B, shankill road, belfast.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 26 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (402R NI)
    • 30 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 21 dic 2007
    Consegnato il 02 gen 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage/charge. The property situate at silvio street, jaffa street, harrybrook street and snugville street, belfast being that portion of the lands comprised in folio AN64763, 37892, 34606, 36919 and AN4071 co antrim.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 02 gen 2008Registrazione di un'ipoteca (402R NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 13 gen 2006
    Consegnato il 19 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Mortgage/charge - all monies. 1 by way of charge all that part of the lands comprised in folios an 64763, an 4071, 36919 and 37892 county antrim.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 19 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 04 feb 2005
    Consegnato il 09 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage/charge. Folios AN64753, AN4071, 36919 and 37892 co antrim.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 09 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 26 feb 2004
    Consegnato il 12 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies charge by way of fixed equitable charge all the estate and interest of the company in the remaining lands and the licence(s) and the benefit of all other agreements relating to the remaining lands to which the company is or may become a party or otherwise entitled and all buidlings... See doc 86 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 12 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 04 ago 2003
    Consegnato il 08 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Mortgage that part of the lands comprised in folio AN50247 county antrim comprised in transfer dated 2 july 2003 and made between (1) northern ireland housing executive and (2) t & a kernoghan limited together with by way of fixed security all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment which are now or shall at any time hereafter during the continuance of this security become affixed to or situated at the said lands of the company.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    • East, Belfast
    Transazioni
    • 08 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 11 mar 2003
    Consegnato il 18 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies charge. 1. (a) by way of fixed equitable charge all the estate and interest of the company in the remaining lands and the licence and the benefit of all other agreements relating to the remaining lands to which the company is or may become a party or otherwise entitled and all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery owned by the company and from time to time on or in the remaining land (together "the equitably charged property") and/or the proceeds of sale of the equitably charged property; see doc 82 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Square East
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 18 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Solicitor's letter of undertaking
    Creato il 25 apr 1994
    Consegnato il 29 apr 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property situate in fernagh road, newtownabbey.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 29 apr 1994
    • 30 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge
    Creato il 08 ott 1992
    Consegnato il 15 ott 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Folios 38952 and AN24964 county antrim.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 15 ott 1992
    • 19 ott 1994Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage debenture
    Creato il 08 nov 1988
    Consegnato il 14 nov 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Folio 1237L county antrim fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 14 nov 1988
    • 05 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Equitable mortgage by deposit of title deeds without written instrument
    Creato il 06 nov 1986
    Consegnato il 10 nov 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Property situated at whitehead, county antrim.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 10 nov 1986
    • 30 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Equitable mortgage by deposit of title deeds without written instrument
    Creato il 26 mar 1986
    Consegnato il 03 apr 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Folio AN1237L county antrim.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 03 apr 1986
    • 14 mar 1988Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Equitable mortgage by deposit of title deeds without written instrument
    Creato il 21 set 1983
    Consegnato il 26 set 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Folio 36809 and 35634 county antrim.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 26 set 1983
    • 30 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    T & A KERNOGHAN (HOLDINGS) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    03 mag 2016Inizio dell'amministrazione
    28 apr 2020Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Neil Robert Adair
    9 Gibsons Lane
    BT23 4LJ Newtownards
    County Down
    Praticante
    9 Gibsons Lane
    BT23 4LJ Newtownards
    County Down
    Melanie Reevel Giles
    9 Gibsons Lane
    BT23 4LJ Newtownards
    Co Down
    Praticante
    9 Gibsons Lane
    BT23 4LJ Newtownards
    Co Down
    2
    DataTipo
    28 apr 2020Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Melanie Reevel Giles
    9 Gibsons Lane
    BT23 4LJ Newtownards
    Co Down
    Liquidatore proposto
    9 Gibsons Lane
    BT23 4LJ Newtownards
    Co Down
    Neil Robert Adair
    9 Gibsons Lane
    BT23 4LJ Newtownards
    County Down
    Liquidatore proposto
    9 Gibsons Lane
    BT23 4LJ Newtownards
    County Down
    Melanie Reevel Giles
    9 Gibsons Lane
    BT23 4LJ Newtownards
    Co Down
    Praticante
    9 Gibsons Lane
    BT23 4LJ Newtownards
    Co Down

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0