DUNBIA (NORTHERN IRELAND)

DUNBIA (NORTHERN IRELAND)

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDUNBIA (NORTHERN IRELAND)
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società NI016970
    GiurisdizioneIrlanda del Nord
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?

    • Lavorazione e conservazione della carne (10110) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?

    Indirizzo della sede legale
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DUNGANNON MEATS26 mar 199826 mar 1998
    DUNGANNON MEATS LIMITED05 ott 198305 ott 1983

    Quali sono gli ultimi bilanci di DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2019 al 30 giu 2020

    1 pagineAA01

    Iscrizione dell'ipoteca NI0169700025, creata il 29 lug 2020

    75 pagineMR01

    Cessazione della carica di James George Dobson come amministratore in data 29 lug 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Matthew Samuel Dobson come amministratore in data 29 lug 2020

    1 pagineTM01

    Iscrizione dell'ipoteca NI0169700024, creata il 29 lug 2020

    42 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 gen 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Notifica di Dunbia (Uk) come persona con controllo significativo il 29 nov 2019

    4 paginePSC02

    Cessazione di Dunbia Limited come persona con controllo significativo il 29 nov 2019

    3 paginePSC07

    legacy

    2 pagineSH20

    Stato del capitale al 17 dic 2019

    • Capitale: GBP 1.00
    4 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di variazione dei diritti o del nome delle azioni

    RES12

    Modifica del nome o della denominazione della classe di azioni

    2 pagineSH08

    Bilancio redatto al 30 dic 2018

    31 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    29 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 18 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Sean Breen come segretario in data 27 feb 2018

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 02 apr 2017

    28 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca NI0169700023, creata il 18 dic 2017

    25 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BREEN, Sean
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Amministratore
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrishNone239253300004
    BROWNE, Niall
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Amministratore
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrishNone223137440001
    QUEALLY, Michael
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Amministratore
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrishNone239899450002
    BREEN, Sean
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Segretario
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    239278860001
    DOBSON, James
    98 Old English Road
    Dungannon
    Co Tyrone
    Segretario
    98 Old English Road
    Dungannon
    Co Tyrone
    145673530001
    PROCTOR, John Joseph
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Segretario
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    British145673580002
    CULLEN, Paul Damien
    19 Ravensdale
    Manse Road
    BT36 6FA Carnmoney
    Co Antrim
    Amministratore
    19 Ravensdale
    Manse Road
    BT36 6FA Carnmoney
    Co Antrim
    Northern IrelandNorthern IrishFinance Director143854490001
    DEMPSEY, Liam Joseph
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    United KingdomBritishDirector130963600004
    DOBSON, James George
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishDirector60391230001
    DOBSON, Matthew Samuel
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    United KingdomBritishManaging Director216974160001
    DOBSON, Robert John
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishDirector60768390001
    DORAN, Michael
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishSales Director145673620002
    FARRELL, David Allan Raymond
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishIt Director145673660002
    GRAHAM, Edison Wilson
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandIrishChairman145110860001
    HANGER, Trevor
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    UkBritishDirector163090380001
    MCKEAVNEY, Robert Edward
    25 Coachmans Way
    Culcavy
    BT26 6HQ Hillsborough
    Co Down
    Amministratore
    25 Coachmans Way
    Culcavy
    BT26 6HQ Hillsborough
    Co Down
    Northern IrelandBritishFinancial Director60391320001
    MCKEOWN, Alan
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishOperations Director145673610002
    MILLIGAN, Gordon John
    10 Grangee Road
    Carrowdore
    BT22 2JB Newtownards
    Amministratore
    10 Grangee Road
    Carrowdore
    BT22 2JB Newtownards
    Northern IrelandBritishH R Director145673640001
    POTTS, Colin Edwin
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishCompany Director125726160003
    PROCTOR, John Joseph
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishHuman Resource Manager145673580002
    SWANN, Kenneth Thomas
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishCo Director145673590002
    TWEEDIE, Henry Campbell
    Stonethorpe Cottage
    116 Belfast Road
    BT23 4TY Newtownards
    Co Down
    Amministratore
    Stonethorpe Cottage
    116 Belfast Road
    BT23 4TY Newtownards
    Co Down
    Northern IrelandBritishCo Director48171740001
    YOUNG, Jonathan
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritishDirector148532740002

    Chi sono le persone con controllo significativo di DUNBIA (NORTHERN IRELAND)?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Castle Street
    EX4 3LG Exeter
    Michael House
    Devon
    England
    29 nov 2019
    Castle Street
    EX4 3LG Exeter
    Michael House
    Devon
    England
    No
    Forma giuridicaUnlimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleEngland And Wales
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione03382084
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Dunbia Limited
    Granville Road
    BT70 1NJ Dungannon
    Unit 9
    Northern Ireland
    06 apr 2016
    Granville Road
    BT70 1NJ Dungannon
    Unit 9
    Northern Ireland
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneNorthern Ireland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneUnited Kingdom Companies House
    Numero di registrazioneNi059523
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    DUNBIA (NORTHERN IRELAND) ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 lug 2020
    Consegnato il 11 ago 2020
    In corso
    Breve descrizione
    Factory facilities and offices being land and buildings known as site a, granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone and registered with freehold number TY62002 county tyrone and leasehold folio numbers TY3069L, TY1647L, TY4950L, TY10143L, TY11270L and TY65783L all county tyrone and the retail packing facility being land and buildings known as site b, granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone and registered with leasehold folio number TY13162L county tyrone, specific intellectual property as outlined in the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 11 ago 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 29 lug 2020
    Consegnato il 10 ago 2020
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 10 ago 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 18 dic 2017
    Consegnato il 22 dic 2017
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (The "Lender")
    Transazioni
    • 22 dic 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 ott 2017
    Consegnato il 18 ott 2017
    In corso
    Breve descrizione
    Real property, shares and investments and specified intellectual property, for more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 18 ott 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 ott 2017
    Consegnato il 18 ott 2017
    In corso
    Breve descrizione
    Non-vesting debts. For more details please refer to the instrument.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 18 ott 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 06 ott 2017
    Consegnato il 18 ott 2017
    In corso
    Breve descrizione
    Real property, shares and investments, specific intellectual property, relevant contracts, for more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 18 ott 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 24 lug 2014
    Consegnato il 05 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land and buildings known as granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone being: TY3069L county tyrone, TY1647L county tyrone, TY4950L county tyrone, TY10143L county tyrone, TY11270L county tyrone, TY65783L county tyrone and TY62002 county tyrone.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 27 feb 2014
    Consegnato il 12 mar 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land and buildings known as granville industrial estate, granville road, dungannon, county tyrone being: TY3069L county tyrone, TY1647L county tyrone, TY4950L county tyrone, TY10143L county tyrone, TY11270L county tyrone, TY65783L county tyrone and TY62002 county tyrone together with all buildings, fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery from time to time thereon, all easements, rights and agreements and the benefit of all covenants given in respect thereof.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 12 mar 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 dic 2011
    Consegnato il 23 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 23 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 ott 2010
    Consegnato il 03 nov 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (A) granted and demised unto the bank all of the property described in the schedule hereto to hold so much of same as is of freehold tenure unto the bank...see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 03 nov 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and floating charge
    Creato il 18 ott 2010
    Consegnato il 18 ott 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed equitable charge (I) all purchased debts being any book debts as defined in the agreement, purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement...see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 18 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 mag 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 18 dic 2008
    Consegnato il 23 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    £1,7000,000.00 mortage. The lands comprised in folios 6195 co tyrone, TY9521L co tyrone, TY10143L co tyrone, TY11270L co tyrone and 13070L co antrim.
    Persone aventi diritto
    • Premier Pension Trustees Limited
    Transazioni
    • 23 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (402R NI)
    • 09 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 24 ago 2007
    Consegnato il 31 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies company mortgage and charge. All lands comprised in folio TY65783L co tyrone.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited
    Transazioni
    • 31 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 02 dic 2002
    Consegnato il 09 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage lands comprised in folio TY13162L county tyrone........................... See doc 73 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank LTD
    Transazioni
    • 09 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 18 lug 2001
    Consegnato il 23 lug 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Mortgage - all monies the lands comprised in folio AN12756L co antrim together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforesaid premises.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank LTD
    Transazioni
    • 23 lug 2001Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 11 mag 1989
    Consegnato il 16 mag 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and premises in folio nos ty 3069L and ty 4950L and all machinery utensils chattels.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited
    Transazioni
    • 16 mag 1989
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 09 feb 1988
    Consegnato il 10 feb 1988
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Pieces or parcels of ground at dungannon park dungannon county tyrone all machinery utensils chattels.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited
    Transazioni
    • 10 feb 1988
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 17 dic 1987
    Consegnato il 30 dic 1987
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Portion of ground in the townland of cormullagh folio ty 1647L county tyrone all machinery utensils chattels.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited
    Transazioni
    • 30 dic 1987
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattels mortgage
    Creato il 27 ott 1986
    Consegnato il 27 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Chattels being one jnf power pack serial number FPP6650, fifteen searl coils serial numbers 2 x lci 614/8 x LC5 1014/ 1 x LC3 814/ 3 x SH4 6/6 1 x kgl 180, one baltimore evaporator condensor serial number BC1528.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 27 ott 1986
    • 04 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattels mortgage
    Creato il 24 ott 1986
    Consegnato il 27 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Chattels being one new toyota forklift serial number 10277, one harmonica roller serial number HRC7, one vac pack bags table serial number vpbt 1500/750, ten bag holders, one strip curtain, one breaking bar.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 27 ott 1986
    • 04 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattels mortgage
    Creato il 24 ott 1986
    Consegnato il 27 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Chattels being one atlas copco GA230 compressor one glass fibre tank capacity 3. 8490 litres serial no. GFT38490, one beaumont hot water generator serial no. 5060HZ, one beef hidepuller serial no. 151F0201.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 27 ott 1986
    • 04 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattels mortgage
    Creato il 24 ott 1986
    Consegnato il 27 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All chattels being one 4150CTN/el/fb/ba overhead scale, one 4150CTN/ll/r/kb/bj overhead scale.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 27 ott 1986
    • 04 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Chattels mortgage
    Creato il 24 ott 1986
    Consegnato il 27 ott 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All chattels being bleed rail serial number BR1 rails in slaughterhall marshalling area 8 rails in sides chills quarters chill boning room and detained room for details of further chattels charged please refer to the form.
    Persone aventi diritto
    • Forward Trust Limited
    Transazioni
    • 27 ott 1986
    • 04 ott 1993Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over all book debts
    Creato il 28 nov 1983
    Consegnato il 30 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All book and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited
    Transazioni
    • 30 nov 1983
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Floating charge
    Creato il 28 nov 1983
    Consegnato il 30 nov 1983
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Undertaking & all property & assets present & future, including uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited
    Transazioni
    • 30 nov 1983
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0