B.I.C. SYSTEMS LIMITED

B.I.C. SYSTEMS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàB.I.C. SYSTEMS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società NI017597
    GiurisdizioneIrlanda del Nord
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di B.I.C. SYSTEMS LIMITED?

    • (7260) /

    Dove si trova B.I.C. SYSTEMS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bedford House
    16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    County Antrim
    Northern Ireland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di B.I.C. SYSTEMS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BIC SYSTEMS LIMITED29 mar 199629 mar 1996
    BUSINESS INDUSTRIAL COMPUTER SYSTEMS LIMITED27 giu 198427 giu 1984

    Quali sono gli ultimi bilanci di B.I.C. SYSTEMS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2009

    Quali sono le ultime deposizioni per B.I.C. SYSTEMS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rendiconto delle entrate e delle uscite al 18 mar 2013

    5 pagine4.69(NI)

    Verbale della riunione finale in una liquidazione volontaria dei soci

    3 pagine4.72(NI)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite al 30 set 2012

    5 pagine4.69(NI)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite al 30 mar 2012

    7 pagine4.69(NI)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite al 30 mar 2012

    5 pagine4.69(NI)

    Indirizzo della sede legale modificato da Pp Rt 11.12, Bt Riverside Tower 5 Lanyon Place Belfast BT1 3BT in data 08 apr 2011

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    6 pagine4.71(NI)

    legacy

    2 pagine558(NI)

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    insolvency

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESM(NI)

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Christina Bridget Ryan il 01 feb 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Christopher Challis il 01 feb 2011

    2 pagineCH01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2010 al 30 giu 2010

    1 pagineAA01

    Nomina di Mrs Christina Bridget Ryan come amministratore

    7 pagineAP01

    Nomina di Mr John Christopher Challis come amministratore

    7 pagineAP01

    Cessazione della carica di Robert Wilson come amministratore

    4 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Ellison come amministratore

    4 pagineTM01

    legacy

    6 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 31 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital18 mag 2010

    Stato del capitale al 18 mag 2010

    • Capitale: GBP 72,000
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    14 pagineAA

    legacy

    1 pagine295(NI)

    legacy

    6 pagine371S(NI)

    legacy

    2 pagine296(NI)

    legacy

    17 pagineAC(NI)

    legacy

    5 pagine371A(NI)

    Chi sono gli amministratori di B.I.C. SYSTEMS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ELLISON, John Richard Philip
    83 Ballyholme Road
    Bangor
    BT20 5LB Co Down
    Segretario
    83 Ballyholme Road
    Bangor
    BT20 5LB Co Down
    British145739830001
    CHALLIS, John Christopher
    Bt Centre
    81 Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Pp A9d
    United Kingdom
    Amministratore
    Bt Centre
    81 Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Pp A9d
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Secretary786970002
    RYAN, Christina Bridget
    Bt Centre
    81 Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Pp A9d
    United Kingdom
    Amministratore
    Bt Centre
    81 Newgate Street
    EC1A 7AJ London
    Pp A9d
    United Kingdom
    United KingdomIrishCompany Secretary35354830001
    LILLEY, Alan Richard
    53 Templepatrick Road
    Ballyclare
    BT39 9TX Co Antrim
    Segretario
    53 Templepatrick Road
    Ballyclare
    BT39 9TX Co Antrim
    145739680001
    BOLE, David
    Hermitage Cottage
    5 Ahoghill Road
    BT41 3BJ Randalstown
    Amministratore
    Hermitage Cottage
    5 Ahoghill Road
    BT41 3BJ Randalstown
    Northern IrelandBritishDivisional Director143843720001
    CLYDESDALE, Patricia Anne
    Sunningdale
    2 Upper Station Road
    BT38 8RQ Greenisland
    Amministratore
    Sunningdale
    2 Upper Station Road
    BT38 8RQ Greenisland
    Northern IrelandIrishCompany Director205093100001
    CONVERY, John Finbar
    Marybrook House
    Raleagh Road
    BT30 9JG Crossgar
    Amministratore
    Marybrook House
    Raleagh Road
    BT30 9JG Crossgar
    United KingdomBritishDirector144870900001
    CREIGHTON, Steven Henry
    2 Church Avenue
    Holywood
    BT18 9BJ Co.Down
    Amministratore
    2 Church Avenue
    Holywood
    BT18 9BJ Co.Down
    BritishChartered Accountant145739740001
    ELLISON, John Richard Philip
    83 Ballyholme Road
    Bangor
    BT20 5LB Co. Down
    Amministratore
    83 Ballyholme Road
    Bangor
    BT20 5LB Co. Down
    BritishBt Executive145739830001
    FEENEY, Pamela Georgina
    111 Belfast Road
    Muckamore
    BT41 2AZ Antrim
    Amministratore
    111 Belfast Road
    Muckamore
    BT41 2AZ Antrim
    BritishDirector Human Resources145739760001
    HAMILTON, Alastair David
    37a Ballymecvea Road
    Kells
    BT42 3NH Ballymena
    Amministratore
    37a Ballymecvea Road
    Kells
    BT42 3NH Ballymena
    Northern IrelandBritishHead Of Bt Business177743330001
    LILLEY, Alan Richard
    8 Russell Manor
    Ballyclare
    BT39 9YR Co Antrim
    Amministratore
    8 Russell Manor
    Ballyclare
    BT39 9YR Co Antrim
    BritishAccountant145739770001
    MCGLADE, Desmond Mario
    66a Balmoral Ave
    Belfast
    BT9 6NY
    Amministratore
    66a Balmoral Ave
    Belfast
    BT9 6NY
    BritishDirector145739690001
    MILLING, Paul Samuel
    6 Scolban Road
    Dromore
    BT25 1NZ Co Down
    Amministratore
    6 Scolban Road
    Dromore
    BT25 1NZ Co Down
    Northern IrelandBritishServices Director144870890001
    MONAGHAN, Patrick Brendan
    66 Osborne Drive
    Belfast
    BT9 6LJ
    Amministratore
    66 Osborne Drive
    Belfast
    BT9 6LJ
    Northern IrelandIrishCompany Director145639300001
    TERRINS, Deirdre Rose
    11 Glen Road
    Holywood
    BT18 0HB Co Down
    Amministratore
    11 Glen Road
    Holywood
    BT18 0HB Co Down
    Northern IrelandBritishSales Director155939240001
    VERNON, Ed James
    50 Maryville Park
    Belfast
    BT9 6LP
    Amministratore
    50 Maryville Park
    Belfast
    BT9 6LP
    Northern IrelandNorthern IrishDirector143703680001
    WILSON, Robert Paul
    63 Irish Hill Road
    Ballyclare
    BT39 9NJ Co Antrim
    Amministratore
    63 Irish Hill Road
    Ballyclare
    BT39 9NJ Co Antrim
    Northern IrelandBritishBt Executive145739810001

    B.I.C. SYSTEMS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage or charge
    Creato il 09 apr 2003
    Consegnato il 09 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies fixed and floating charge 1. by way of fixed equitable charge (I) all purchased debts being any book debts as defined in the agreement, purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to the agreement the ownership of which fail to vest absolutley and effectively in the security holder......................... See doc 95 for further details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor And
    • Square North Belfast
    • Of Ireland Donegall
    Transazioni
    • 09 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 31 dic 1998
    Consegnato il 14 gen 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies.indenture of mortgage the premises comprised in an indenture of lease made the 3RD day of november 1997 between mga properties limited of the one part and the company of the other part held by the company for the term of 125 years from 1ST day of may 1997 subject to the yearly rent of #22,000.00 and the covenants and conditions therein and therein described as "the part of the head lease premises situate at and currently known as units 3,4 and 5 airport business park of the complex more particularly delineated and described on the plan annexed hereto and thereon edged red and containing the building currently known as units 3,4 and 5 aforesaid" now known as enterprise house, 201 airport road west, sydenham business park, belfast BT3 9ED. See doc 71 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland
    Transazioni
    • 14 gen 1999Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 23 giu 1997
    Consegnato il 02 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies indenture of mortgage the premises currently known as 3,4, and 5 airport business park.see doc 65.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland
    Transazioni
    • 02 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 08 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 23 giu 1997
    Consegnato il 02 lug 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies debenture the premises currently known as 3,4, and 5 airport business park. See doc 64.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland
    • Bank of Ireland
    Transazioni
    • 02 lug 1997Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 30 nov 1989
    Consegnato il 30 nov 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies debenture the companys undertaking and all its property and assets, whatsoever and wheresoever both present and future including a specific charge affecting book debts, fixed and moveable plant, machinery fixtures implements and utensils, goodwill and all proceeds of insurance receivable by the company, and uncalled capital and all estate or interest legal or equitable in freehold and leasehold property which should at any time thereafter during the contin- uance of the security thereby created become vested in the company.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland
    Transazioni
    • 30 nov 1989
    Mortgage or charge
    Creato il 29 nov 1989
    Consegnato il 06 dic 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies charge over all book debts all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company this debenture is to rank as a first fixed charge on the book debts hereby charged and such cahrge is to be a floating security provided that the company is not to be at liberty to create any mortgage or charge on any of its book debts ranking in priority to or pari passu with this debenture without the previous consent in writing of international factors. The principal monies hereby secured will be paid without regard to any counter- claim or right of set-off.
    Persone aventi diritto
    • International
    Transazioni
    • 06 dic 1989Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 16 mar 1989
    Consegnato il 21 mar 1989
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies charge over all book debts all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company including a specific charge affecting book debts, fixed and moveable plant, machinery fixtures implements and utensils, goodwill and all proceeds of insurance receivable by the company, and uncalled capital and all estate or interest legal or equitable in freehold and leasehold property which should at any time thereafter during the contin- uance of the security thereby created become vested in the company.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 1989Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 21 mag 1986
    Consegnato il 04 giu 1986
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies debenture the companys undertaking and all its property and assets, whatsoever and wheresoever both present and future including a specific charge affecting book debts, fixed and moveable plant, machinery fixtures implements and utensils, goodwill and all proceeds of insurance receivable by the company, and uncalled capital and all estate or interest legal or equitable in freehold and leasehold property which should at any time thereafter during the contin- uance of the security thereby created become vested in the company.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland
    Transazioni
    • 04 giu 1986Registrazione di un'ipoteca (402 NI)

    B.I.C. SYSTEMS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    26 giu 2013Data di scioglimento
    30 mar 2011Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Patrick Joseph Brazzill
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Elizabeth Anne Bingham
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    Ernst & Young
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0