OPEN AND DIRECT INSURANCE SERVICES (DUNGIVEN) LIMITED

OPEN AND DIRECT INSURANCE SERVICES (DUNGIVEN) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàOPEN AND DIRECT INSURANCE SERVICES (DUNGIVEN) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società NI021952
    GiurisdizioneIrlanda del Nord
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di OPEN AND DIRECT INSURANCE SERVICES (DUNGIVEN) LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova OPEN AND DIRECT INSURANCE SERVICES (DUNGIVEN) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1 Regent Street
    Newtownards
    BT23 4AB Co. Down
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di OPEN AND DIRECT INSURANCE SERVICES (DUNGIVEN) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    W.G. O'KANE INSURANCE BROKERS LIMITED09 nov 199009 nov 1990
    W.G. O'KANE INSURANCE SERVICES LTD26 giu 199026 giu 1990
    W.G. O'KANE INSURANCE BROKERS LIMITED27 set 198827 set 1988

    Quali sono gli ultimi bilanci di OPEN AND DIRECT INSURANCE SERVICES (DUNGIVEN) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per OPEN AND DIRECT INSURANCE SERVICES (DUNGIVEN) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per OPEN AND DIRECT INSURANCE SERVICES (DUNGIVEN) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Cessazione della carica di Christian Charles Plumer come segretario in data 27 feb 2015

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Christian Charles Plumer come amministratore in data 27 feb 2015

    1 pagineTM01

    Nomina di Annabel Felicity Wilson come segretario in data 27 feb 2015

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Allister Paul Turner come amministratore in data 27 feb 2015

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Gilles Normand come amministratore in data 17 gen 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Christophe Marie Fred Bardet come amministratore in data 17 gen 2015

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 30 dic 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 feb 2015

    Stato del capitale al 02 feb 2015

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Georges Desray come segretario in data 08 lug 2014

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Georges Desray come amministratore in data 08 lug 2014

    1 pagineTM01

    Nomina di Christian Charles Plumer come segretario in data 08 lug 2014

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Christian Charles Plumer come amministratore in data 08 lug 2014

    2 pagineAP01

    Stato del capitale al 10 lug 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Dichiarazione degli oggetti sociali

    2 pagineCC04

    legacy

    1 pagineSH20

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Share capital sum credited to profit and loss account;power of company to issue shares shall not be restricted to any maximum number or nominal amount. 26/06/2014
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio annuale redatto al 30 dic 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 dic 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Georges Desray il 28 ago 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    5 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di OPEN AND DIRECT INSURANCE SERVICES (DUNGIVEN) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WILSON, Annabel Felicity
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Segretario
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    196038960001
    NORMAND, Gilles
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomFrench175288680001
    TURNER, Allister Paul
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    EnglandBritish86414540001
    CUGGY, Victoria Louise
    63 Ranulf Road
    Little Dunmow
    CM6 3GR Dunmow
    Essex
    Segretario
    63 Ranulf Road
    Little Dunmow
    CM6 3GR Dunmow
    Essex
    British105782010002
    DESRAY, Georges
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Segretario
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    169855840001
    FARMER, Geoffrey Mark
    19 Henryville Manor
    Ballyclare
    BT39 9FP Co Antrim
    N Ireland
    Segretario
    19 Henryville Manor
    Ballyclare
    BT39 9FP Co Antrim
    N Ireland
    Britiish81850640001
    GRIFFIN, Steven Terrance Hunter
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    Segretario
    Holliwell
    Chandlers
    CM0 8NY Burnham On Crouch
    Essex
    143835370001
    HARGREAVES, Sally Anne
    1 Regent Street
    Newtownards
    BT23 4AB Co. Down
    Segretario
    1 Regent Street
    Newtownards
    BT23 4AB Co. Down
    English1778900007
    PLUMER, Christian Charles
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Segretario
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    189564210001
    BARDET, Christophe Marie Fred
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomFrench165770320001
    BELLRINGER, Charles Albert John
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish132720300001
    BRADY, Gareth Michael
    31 Royal Park Lane
    Hillsborough
    BT26 6RG
    Amministratore
    31 Royal Park Lane
    Hillsborough
    BT26 6RG
    Irish143213990001
    CLARE, Anthony Peter
    1 Regent Street
    Newtownards
    BT23 4AB Co. Down
    Amministratore
    1 Regent Street
    Newtownards
    BT23 4AB Co. Down
    United KingdomBritish51441260002
    DESRAY, Georges
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    EnglandFrench167333040002
    DOYLE, Joseph
    8 Rosetta Road East
    Belfast
    BT6 OLP
    Amministratore
    8 Rosetta Road East
    Belfast
    BT6 OLP
    British143835290001
    ELLIOTT, Paul Andrew
    5 Paradise Park
    Parkgate
    BT39 0EG Ballyclare
    Amministratore
    5 Paradise Park
    Parkgate
    BT39 0EG Ballyclare
    Northern IrelandBritish145855630001
    FARMER, Geoffrey Mark
    19 Henryville Manor
    Ballynure Road
    BT39 9FP Ballyclare
    Co Antrim
    Amministratore
    19 Henryville Manor
    Ballynure Road
    BT39 9FP Ballyclare
    Co Antrim
    Britiish81850640001
    FARREN, Kieran
    430 Ballyquin Road
    Dungiven
    BT47 4LX Co Londonderry
    Amministratore
    430 Ballyquin Road
    Dungiven
    BT47 4LX Co Londonderry
    Irish143835260001
    GALLAGHER, Daniel
    13 Rock Road
    Londonderry
    BT48 7PD
    Amministratore
    13 Rock Road
    Londonderry
    BT48 7PD
    Irish143835240001
    HALPIN, Peter Joseph
    1 Regent Street
    Newtownards
    BT23 4AB Co. Down
    Amministratore
    1 Regent Street
    Newtownards
    BT23 4AB Co. Down
    United KingdomBritish38789050002
    LEONARD, Thomas Andrew
    11 Larcom Drive
    Culmore Road
    BT48 8PP Derry
    Co Derry
    Amministratore
    11 Larcom Drive
    Culmore Road
    BT48 8PP Derry
    Co Derry
    Northern IrelandIrish145057260001
    MCEVOY, Colin Alexander
    9 Roseville Park
    Bangor
    BT19 1BY Co Down
    Amministratore
    9 Roseville Park
    Bangor
    BT19 1BY Co Down
    Northern IrelandBritish144528060001
    MULLAN, Elizabeth
    1 Station Road
    Dungiven
    BT47 4LN Derry
    Amministratore
    1 Station Road
    Dungiven
    BT47 4LN Derry
    Northern IrelandIrish142985040001
    MULLAN, Seamus
    1 Station Road
    Dungiven
    BT47 4LN Co Londonderry
    Amministratore
    1 Station Road
    Dungiven
    BT47 4LN Co Londonderry
    Northern IrelandIrish142985030001
    MULLIN, Michael Finbarr
    2 Lackagh Park
    Dungiven
    BT47 4ND Derry
    Amministratore
    2 Lackagh Park
    Dungiven
    BT47 4ND Derry
    Irish143835230001
    PLUMER, Christian Charles
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    Amministratore
    6 Great Marlborough Street
    M1 5SW Manchester
    Swinton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish130813500001
    POTTS, Nicholas
    4 Ringstone
    Krumlin, Barkisland
    HX4 0EU Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    4 Ringstone
    Krumlin, Barkisland
    HX4 0EU Halifax
    West Yorkshire
    EnglandBritish64059360004
    UTLEY, Neil Alan
    Larkins Farm
    199 Nine Ashes Road
    CM4 0JY Blackmore
    Essex
    Amministratore
    Larkins Farm
    199 Nine Ashes Road
    CM4 0JY Blackmore
    Essex
    United Arab EmiratesBritish161350430001

    OPEN AND DIRECT INSURANCE SERVICES (DUNGIVEN) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage or charge
    Creato il 30 apr 2002
    Consegnato il 10 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies debenture.. The charging company, as beneficial owner:. (A) grants and demises to the security trustee so much of the charged property as is of freehold tenure (save any part of the ownership whereof is registered or is in the course of being registered at the land registry ..................). see doc 74 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Old Broad Street
    • Of Scotland
    • The Governor And
    Transazioni
    • 10 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 30 apr 2002
    Consegnato il 08 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies debenture. 1 fixed charges 1.1 the chargor as beneficial owner and as a continuing security for the payment and discharge of the secured liabilities:- see doc 73 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Viridian Group PLC
    • BT9 5HT
    • 120 Malone Road
    Transazioni
    • 08 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 27 mar 1992
    Consegnato il 03 apr 1992
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Charge part of the lands of townparks of magherafelt being the land comprised in folio 10872 co londonderry.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland
    Transazioni
    • 03 apr 1992Registrazione di un'ipoteca (402 NI)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0