AP (NI) (NO.1) LIMITED

AP (NI) (NO.1) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAP (NI) (NO.1) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società NI024802
    GiurisdizioneIrlanda del Nord
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AP (NI) (NO.1) LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova AP (NI) (NO.1) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Tughans Solicitors, Marlborough House
    30 Victoria Street
    BT1 3GG Belfast
    Co Antrim
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AP (NI) (NO.1) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    E.A. BAIRD (N'ARDS) LIMITED06 lug 199506 lug 1995
    WM. MARTIN (N'ARDS) LIMITED12 set 199012 set 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di AP (NI) (NO.1) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Quali sono le ultime deposizioni per AP (NI) (NO.1) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 mag 2012

    Stato del capitale al 14 mag 2012

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    6 pagineAA

    Cessazione della carica di Christopher James Giles come amministratore in data 05 set 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark Francis Muller come amministratore in data 05 set 2011

    3 pagineAP01

    Bilancio annuale redatto al 10 mag 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    13 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    4 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di AP (NI) (NO.1) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Segretario
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    British150395280001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Amministratore
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish52040210004
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    Amministratore
    Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    1
    United KingdomBritish63620010002
    BAIRD, Irene Deirdre
    9,Rosepark East
    Belfast
    BT5 7RL
    Segretario
    9,Rosepark East
    Belfast
    BT5 7RL
    144417380001
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Segretario
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    British63620010002
    AU COSEC LIMITED
    Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    Segretario
    Brooklands
    Weybridge
    KT13 0NY Surrey
    68799430002
    AYLWARD, Christopher David
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell Woking
    Surrey
    Amministratore
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell Woking
    Surrey
    United KingdomBritish59741430002
    BAIRD, Austin Richard
    48 Circular Road
    Belmont
    BT4 2GB Belfast
    County Antrim
    Amministratore
    48 Circular Road
    Belmont
    BT4 2GB Belfast
    County Antrim
    Northern IrelandBritish143001420001
    BAIRD, Catherine Jane
    9 Rosepark East
    Belfast
    BT5 7RL
    Amministratore
    9 Rosepark East
    Belfast
    BT5 7RL
    British144417440001
    BAIRD, Ernest
    9,Rosepark East
    Belfast
    BT5 7RL
    Amministratore
    9,Rosepark East
    Belfast
    BT5 7RL
    British144417390001
    BAIRD, Irene Deirdre
    9 Rosepark East
    Dundonald
    BT5 7RL
    Amministratore
    9 Rosepark East
    Dundonald
    BT5 7RL
    British144417410001
    CASEMENT, Diane Elizabeth
    12 Middle Road
    Saintfield
    BT24 7LP
    Amministratore
    12 Middle Road
    Saintfield
    BT24 7LP
    British144417430001
    GILES, Christopher James
    30 Victoria Street
    BT1 3GG Belfast
    C/O Tughans Solicitors, Marlborough House
    Co Antrim
    Amministratore
    30 Victoria Street
    BT1 3GG Belfast
    C/O Tughans Solicitors, Marlborough House
    Co Antrim
    EnglandBritish150046230001
    HULME, Simon
    The West Wing
    Callaly Castle
    NE66 4TA Whittingham
    Alnwick
    Amministratore
    The West Wing
    Callaly Castle
    NE66 4TA Whittingham
    Alnwick
    United KingdomBritish105524430001
    JOHNSTON, Alison Mary Louise
    12 Gowan Heights
    Dunmurry
    BT17 9LZ Belfast
    Amministratore
    12 Gowan Heights
    Dunmurry
    BT17 9LZ Belfast
    British144417450001
    JOHNSTON, Colin James
    12 Gowan Heights
    Drumbeg Road
    BT17 9LZ Drumbeg
    Belfast
    Amministratore
    12 Gowan Heights
    Drumbeg Road
    BT17 9LZ Drumbeg
    Belfast
    Northern IrelandBritish144317390001
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Amministratore
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish63620010002
    PROSSER, Andrew James Mackenzie
    Tamarind
    Camilla Drive
    RH5 6BU Westhumble
    Dorking
    Amministratore
    Tamarind
    Camilla Drive
    RH5 6BU Westhumble
    Dorking
    EnglandBritish151240810001

    AP (NI) (NO.1) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage or charge
    Creato il 31 gen 2005
    Consegnato il 08 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage/charge. Premises situate at 42 and 44 holywood rad, belfast.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    • Ulster Bank Ireland Limited
    Transazioni
    • 08 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 07 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 23 ago 2004
    Consegnato il 23 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage / charge all that the lands and premises situate at 56A rathmore road, carnalea, bangor, county down BT19 1WL...... See doc 64 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Ireland
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 23 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 18 mar 2003
    Consegnato il 20 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage and counterpart mortgage. All of the land comprised in folio no. Dn 104360 county down and by way of fixed security all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment which are now or shall at any time hereafter during the continuance of the security become the property of the company.
    Persone aventi diritto
    • Dublin 2 and Ulster
    • Donegall Square East
    • Ulster Bank Ireland
    Transazioni
    • 20 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 11 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 04 ott 2002
    Consegnato il 15 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage. The premises at the square 2-4 fair green road marjethill county armagh the dispensing pharmaceutical licence....... ........................................ see doc 59 for further details.
    Persone aventi diritto
    • And Ulster Bank
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 15 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 07 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 27 set 2002
    Consegnato il 02 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage the leasehold premises at units NO3 & 7 sailsbury square, queen street ballymena co antrim............................... See doc 60 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Ireland
    • Bank Limited
    Transazioni
    • 02 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 11 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 13 set 2002
    Consegnato il 23 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage. The premises situate at 97-107, high street, bangor, county down being the lands and premises more particularly described in deed of conveyance and assignment dated the 13TH day of september 2002 and made between stranmillis investments limited of the one part and the mortgagor of the other see doc 56 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Ireland
    • Dublin 2 and Ulster
    • Donegall Square East
    Transazioni
    • 23 set 2002Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 07 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 31 lug 2002
    Consegnato il 02 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage. The leasehold premises at 72 holywood road, belfast, the dispensing pharmaceutical licence attached to the premises; and by way of fixed security all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment which are now or shall at any time hereafter during the continuance of this security become the property of the mortgagor.
    Persone aventi diritto
    • 11-16 Donegall
    • Quay Dublin 2 And
    • Ulster Bank Ireland
    Transazioni
    • 02 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 07 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 29 lug 2002
    Consegnato il 02 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage. The leasehold premises at 13 john mitchel place, newry, county down, the dispensing pharmaceutical licence attached to the premises; and by way of fixed security all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment which are now or shall at any time hereafter during the continuance of this security become the property of the mortgagor.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Ireland
    • 11-16 Donegall
    • Quay, Dublin 2 And
    Transazioni
    • 02 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 07 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 01 lug 2002
    Consegnato il 05 lug 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage. The leasehold premises at 83, the promenade, portstewart, co londonderry, the dispensing pharmaceutical licence attached to the premises; and by way of fixed security all fixed and moveable plant machinery......................... See doc 53 for further details.
    Persone aventi diritto
    • 11-16 Donegall Sq
    • Ulster Bank Ireland
    • Dublin 2 And
    Transazioni
    • 05 lug 2002Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 07 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 31 mag 2002
    Consegnato il 07 giu 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage. All that and those lands situate at chapel hill, lisburn, county antrim as are comprised in deed of conveyance dated 31ST may 2002 and made between thomas hague and pauline hague of the one part and mortgagor of the other part. See doc 52 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Ireland
    Transazioni
    • 07 giu 2002Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 07 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 04 mar 2002
    Consegnato il 12 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Mortgage - all monies. The leasehold premises at 9, high street lurgan........ See doc. No. 51 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Ireland
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 12 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 07 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 01 lug 2000
    Consegnato il 06 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage. Shop and premises situate and known as 80A main street, cullybackey, county antrim together with the dispensing pharmaceutical licence in relation thereto and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment thereon.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Markets
    • Ulster Bank LTD
    Transazioni
    • 06 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 07 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 30 giu 2000
    Consegnato il 05 lug 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage. Shop and premises situate and known as 324 beersbridge road, belfast together with the dispensing pharmaceutical licence in relation thereto and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank LTD
    • Ulster Bank Markets
    Transazioni
    • 05 lug 2000Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 07 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 28 nov 1997
    Consegnato il 02 dic 1997
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage. Premises situate and known as 17 and 19 hillsborough road, dromara, county down together with all fixed and moveable plant and machinery implements utensils furniture and equipment and together also with the dispensing pharmaceutical license.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Markets
    • Ulster Bank LTD
    Transazioni
    • 02 dic 1997Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 07 set 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 31 lug 1996
    Consegnato il 31 lug 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage debenture see doc 31 for details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Markets
    Transazioni
    • 31 lug 1996Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 30 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 23 ago 1995
    Consegnato il 01 set 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage the premises situate and known as nos. 104, 106 and 108 frances street, newtownards. Together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereinafter upon all of the aforesaid premises.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank LTD
    Transazioni
    • 01 set 1995Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 06 giu 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies charge over all book debts.. All book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited
    Transazioni
    • 14 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un'ipoteca in tutto o in parte (411A NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 06 giu 1994
    Consegnato il 14 giu 1994
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies floating charge.. The undertaking of the company and all its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being.. See 402 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank Limited
    Transazioni
    • 14 giu 1994Dichiarazione di soddisfazione di un'ipoteca in tutto o in parte (411A NI)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0