CAPITA HELM CORPORATION LIMITED

CAPITA HELM CORPORATION LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCAPITA HELM CORPORATION LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società NI025165
    GiurisdizioneIrlanda del Nord
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CAPITA HELM CORPORATION LIMITED?

    • Attività di consulenza gestionale diverse dalla gestione finanziaria (70229) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova CAPITA HELM CORPORATION LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bedford House
    16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CAPITA HELM CORPORATION LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TRIBAL HELM CORPORATION LIMITED12 nov 200412 nov 2004
    HELM CORPORATION LIMITED - THE16 set 199116 set 1991
    CSL (N.I.) LIMITED28 dic 199028 dic 1990

    Quali sono gli ultimi bilanci di CAPITA HELM CORPORATION LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per CAPITA HELM CORPORATION LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Verbale della riunione finale in una liquidazione volontaria dei soci

    3 pagine4.72(NI)

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato Bedford House 16 Bedford Street Belfast BT2 7DT

    2 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a Bedford House 16 Bedford Street Belfast BT2 7DT

    2 pagineAD02

    Indirizzo della sede legale modificato da Beacon House 27 Clarendon Road Belfast BT1 3PR a Bedford House 16 Bedford Street Belfast BT2 7DT in data 26 nov 2019

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore

    1 pagineVL1

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.71(NI)

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    insolvency

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESM(NI)

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 28 ott 2019

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2018

    17 pagineAA

    legacy

    201 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mrs Francesca Anne Todd il 15 giu 2018

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Capita Corporate Director Limited il 15 giu 2018

    1 pagineCH02

    Dettagli del segretario cambiati per Capita Group Secretary Limited il 15 giu 2018

    1 pagineCH04

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 31 dic 2017

    19 pagineAA

    legacy

    208 paginePARENT_ACC

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Dichiarazione di conformità presentata il 30 giu 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di CAPITA HELM CORPORATION LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    Segretario
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2376959
    135207160001
    TODD, Francesca Anne
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    Amministratore
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    EnglandBritish72249980003
    CAPITA CORPORATE DIRECTOR LIMITED
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    Amministratore
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5641516
    129795770003
    COLLINS, Richard Hawke
    Halland Road
    GL53 0DJ Cheltenham
    5
    Gloucestershire
    Segretario
    Halland Road
    GL53 0DJ Cheltenham
    5
    Gloucestershire
    British53398040001
    DAVIS, Lorraine Anne
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United Kingdom
    Segretario
    Newman Street
    W1T 3EY London
    87-91
    United Kingdom
    150939630001
    MALLON, Martin Columba
    73 Granville Road
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Segretario
    73 Granville Road
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    143259400001
    BREACH, Stephen Derrick
    Newman Street
    W1T3EY London
    87-91
    United Kingdom
    Amministratore
    Newman Street
    W1T3EY London
    87-91
    United Kingdom
    United KingdomBritish147928530001
    BUCKLEY, William David
    166 Ballymena Road
    Doagh
    BT39 0TN Ballyclare
    Amministratore
    166 Ballymena Road
    Doagh
    BT39 0TN Ballyclare
    United KingdomBritish143259420001
    COTSFORD, Lee Douglas
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish184974410001
    DUFFY, Damian Hugh
    28 Springhill Manor
    Magheralin
    BT67 0UB County Armagh
    Amministratore
    28 Springhill Manor
    Magheralin
    BT67 0UB County Armagh
    Irish143259470001
    FIELD, Andrew
    12 The Mount
    New Malden
    KT3 4HU Surrey
    Amministratore
    12 The Mount
    New Malden
    KT3 4HU Surrey
    EnglandBritish61471170001
    FRAZER, Michael Robert
    129 Upper Road
    Greenisland
    BT38 8RR Carrickfergus
    Amministratore
    129 Upper Road
    Greenisland
    BT38 8RR Carrickfergus
    British61027100001
    GALBRAITH, John
    7 The Coaches
    Brown's Brae
    BT18 0LE Holywood
    Amministratore
    7 The Coaches
    Brown's Brae
    BT18 0LE Holywood
    British67079750001
    LAWTON, Simon Marcus
    Long Ash
    Woodbridge Lane
    GL54 4BP Withington
    Cheltenham, Gloucestershire
    Amministratore
    Long Ash
    Woodbridge Lane
    GL54 4BP Withington
    Cheltenham, Gloucestershire
    British143259480001
    MACGINTY, Thomas Manus
    1 Ardgannon
    Dungannon
    Co Tyrone
    Amministratore
    1 Ardgannon
    Dungannon
    Co Tyrone
    Irish143259430001
    MARTIN, Peter John
    Vine Cottage
    48 High Street
    RG10 8BY Wargrave
    Berkshire, England
    Amministratore
    Vine Cottage
    48 High Street
    RG10 8BY Wargrave
    Berkshire, England
    EnglandBritish176044430001
    RICKATSON, Caroline
    Demesne Court
    88 Main Street
    BT67 0LH Moira
    Helm House
    County Armagh
    Northern Ireland
    Amministratore
    Demesne Court
    88 Main Street
    BT67 0LH Moira
    Helm House
    County Armagh
    Northern Ireland
    ScotlandBritish155008870001
    ROWLING, Keith Peter
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish109045590002
    SHEARER, Richard John
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Amministratore
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    United KingdomBritish132651920002
    SWEENEY, Sean Pacelli
    The Green
    Kilbroney Mill
    Kilbroney Road
    Rostrevor
    Amministratore
    The Green
    Kilbroney Mill
    Kilbroney Road
    Rostrevor
    United KingdomIrish61027110001
    WILLIAMS, Gareth Leslie Arnold
    4 Elsmore Manor
    Belfast
    BT5 7QD
    Amministratore
    4 Elsmore Manor
    Belfast
    BT5 7QD
    United KingdomBritish143259460001
    WYLLIE, Mark Richard John
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    Amministratore
    Rochester Row
    SW1P 1QT London
    17
    United Kingdom
    EnglandBritish62362970002
    WYLLIE, Mark Richard John
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    Amministratore
    Rochester Row
    Westminster
    SW1P 1QT London
    17
    England
    EnglandBritish62362970002

    Chi sono le persone con controllo significativo di CAPITA HELM CORPORATION LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    06 apr 2016
    Berners Street
    W1T 3LR London
    30
    England
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06027254
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CAPITA HELM CORPORATION LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 13 giu 2008
    Consegnato il 20 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage debenture. The company as beneficial owner and as a security for the payment and discharge of the secured obligations.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 04 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 13 giu 2008
    Consegnato il 20 giu 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies deed of accession. The company with full title guarantee has charged with thepayment and discharge to the security trustee as agent and trustee aforesaid of all the secured liabilities.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 20 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 04 mag 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Standard security
    Creato il 30 apr 2007
    Consegnato il 10 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies standard security. Flat 4/07, 5 south frederick street, glasgow G1 1HJ being the subjects registered under title no GLA173070.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 10 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 26 ott 2006
    Consegnato il 16 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies legal mortgage. 17 cottesbrooke park, heartlands, davantry, northants (formerly plot 6) comprised in part NN236150.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 16 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 09 mag 2000
    Consegnato il 10 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies.debenture the following property is specifically referred to:- all that and those the leasehold property known as unit 2, site 3, cromac wood, belfast comprised in a lease dated 9TH may 2000 and made between cusp limited of the one part and the helm corporation limited of the other part and being part of the lands comprised in folio no AN60856L county antrim. See doc 37 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland
    Transazioni
    • 10 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 05 mag 2000
    Consegnato il 10 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies.assignmenmt of life policy all moneys payable from time to time to the company under:- life policy number 10069374 dated 5TH may 2000 held with scottish provident institution on the life of sean pacelli sweeney in the sum of #315,000.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland
    Transazioni
    • 10 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 05 mag 2000
    Consegnato il 10 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies.assignment of life policy all moneys payable from time to time to the company under:- life policy number 10069353 dated 5TH may 2000 held with scottish provident institution on the life of william david buckley in the sum of #131,761.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland
    Transazioni
    • 10 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 05 mag 2000
    Consegnato il 10 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies.assignment of life policy all moneys payable from time to time to the company under:- life policy number 10069364 dated 5TH may 2000 held with scottish provident institution on the life of robert michael frazer in the sum of #315,000.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland
    Transazioni
    • 10 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 05 mag 2000
    Consegnato il 10 mag 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies.assignment of life policy all moneys payable from time to time to the company under:- life policy number 10069347 dated 5TH may 2000 held with scottish provident institution on the life of thomas manus macginty in the sum of #123,900.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Ireland
    Transazioni
    • 10 mag 2000Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 26 lug 1999
    Consegnato il 30 lug 1999
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage/debenture a) a specific equitable charge over all future estates or interests in the property hereinafter described and over the companys estate or interest in all freehold or leasehold properties now or at any time belonging to or charged to the company other than the property hereinafter described.b) a specific charge over all book and other debts for the time being due or owing to the company but so that the company shall pay into the companys account with the bank all moneys which it may receive in respect of such debts and shall not without the prior consent in writing of the bank sell factor discount or other- wise charge or assign the same in favour of any other person or purport to do so and the company shall if called upon to do so by the bank from time to time execute legal assignments of such book debts and other debts to the bank. C) a specific charge over its goodwill and the benefit of any licences and all fixed and moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment for the time being the companys property. D) a floating charge over the undertaking and all other pro- perty and assets present and future but so that the company shall not without the banks consent create any mortgage or charge ranking in priority to or pari passu with this charge.
    Persone aventi diritto
    • East
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 30 lug 1999Registrazione di un'ipoteca (402 NI)

    CAPITA HELM CORPORATION LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 ott 2019Inizio della liquidazione
    09 ott 2020Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Praticante
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praticante
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0