DUNGANNON MEATS (RETAIL PACKS)

DUNGANNON MEATS (RETAIL PACKS)

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDUNGANNON MEATS (RETAIL PACKS)
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società NI025609
    GiurisdizioneIrlanda del Nord
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DUNGANNON MEATS (RETAIL PACKS)?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova DUNGANNON MEATS (RETAIL PACKS)?

    Indirizzo della sede legale
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DUNGANNON MEATS (RETAIL PACKS)?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DUNGANNON MEATS (RETAIL PACKS) LIMITED22 apr 199322 apr 1993
    LAGAN MEATS LIMITED09 lug 199109 lug 1991
    ABEAM AGENCIES LIMITED06 giu 199106 giu 1991

    Quali sono gli ultimi bilanci di DUNGANNON MEATS (RETAIL PACKS)?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per DUNGANNON MEATS (RETAIL PACKS)?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    legacy

    2 pagineSH20

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    Stato del capitale al 07 ott 2019

    • Capitale: GBP 1.00
    5 pagineSH19

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 mar 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 31 dic 2017, non revisionato

    6 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 mar 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Sean Breen come segretario in data 27 feb 2018

    1 pagineTM02

    Bilancio abbreviato redatto al 31 mar 2017, non revisionato

    6 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Michael Queally il 23 nov 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Niall Browne il 23 nov 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Niall Browne il 23 nov 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Sean Breen il 23 nov 2017

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Sean Breen il 23 nov 2017

    1 pagineCH03

    Soddisfazione dell'onere NI0256090010 in pieno

    4 pagineMR04

    Cessazione della carica di Robert John Dobson come amministratore in data 06 ott 2017

    2 pagineTM01

    Nomina di Niall Browne come amministratore in data 06 ott 2017

    3 pagineAP01

    Nomina di Michael Queally come amministratore in data 06 ott 2017

    3 pagineAP01

    Nomina di Sean Breen come amministratore in data 05 ott 2017

    3 pagineAP01

    Nomina di Mr Matthew Samuel Dobson come amministratore in data 06 ott 2017

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Colin Edwin Potts come amministratore in data 06 ott 2017

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Liam Joseph Dempsey come amministratore in data 06 ott 2017

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di DUNGANNON MEATS (RETAIL PACKS)?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BREEN, Sean
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Amministratore
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrish239253300004
    BROWNE, Niall
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Amministratore
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrish223137440001
    DOBSON, James George
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritish60391230001
    DOBSON, Matthew Samuel
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritish216974160001
    QUEALLY, Michael
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Amministratore
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    IrelandIrish239899450002
    BREEN, Sean
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    Segretario
    Grannagh
    Waterford
    C/O Dawn Meats
    Ireland
    239278530001
    DOBSON, James George
    98 Old Eglish Road
    Dungannon
    BT70 1LB
    Segretario
    98 Old Eglish Road
    Dungannon
    BT70 1LB
    143134270001
    PROCTOR, John Joseph
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Segretario
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    British145673580002
    DEMPSEY, Liam Joseph
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    United KingdomBritish130963600004
    DOBSON, Robert John
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritish60768390001
    MCKEAVNEY, Robert Edward
    25 Coachmans Way
    Culcavy
    BT26 6HQ Hillsborough
    Co Down
    Amministratore
    25 Coachmans Way
    Culcavy
    BT26 6HQ Hillsborough
    Co Down
    United KingdomBritish60391320001
    POTTS, Colin Edwin
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    United KingdomBritish125726160003
    PROCTOR, John Joseph
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritish145673580002
    SWANN, Kenneth Thomas
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Amministratore
    Granville Industrial Estate
    Dungannon
    BT70 1NJ Co Tyrone
    Northern IrelandBritish145673590002
    TWEEDIE, Henry Campbell
    Stonethorpe Cottage
    116 Belfast Road
    BT23 4TY Newtownards
    Co Down
    Amministratore
    Stonethorpe Cottage
    116 Belfast Road
    BT23 4TY Newtownards
    Co Down
    Northern IrelandBritish48171740001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DUNGANNON MEATS (RETAIL PACKS)?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Dunbia Limited
    Granville Road
    BT70 1NJ Dungannon
    Unit 9
    Northern Ireland
    06 apr 2016
    Granville Road
    BT70 1NJ Dungannon
    Unit 9
    Northern Ireland
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneNorthern Ireland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneNorthern Ireland
    Numero di registrazioneNi059523
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    DUNGANNON MEATS (RETAIL PACKS) ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 24 lug 2014
    Consegnato il 05 ago 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All of the assets and undertaking of the chargor whatsoever and wheresoever, both present at the date of the debenture and future as charged pursuant to clause 3 of the debenture.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 ago 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 25 ott 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 16 dic 2011
    Consegnato il 23 dic 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 23 dic 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage debenture
    Creato il 19 ott 2010
    Consegnato il 03 nov 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    (A) granted and demised unto the bank all the property described in the schedule hereto to hold so much of same as is of freehold tenure unto the bank...see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor & Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 03 nov 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 25 apr 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 03 mar 2000
    Consegnato il 07 mar 2000
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Solicitors' undertaking - all monies premises situate at 182,188 cambrai street, belfast.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank LTD
    Transazioni
    • 07 mar 2000Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 13 dic 1996
    Consegnato il 31 dic 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    393295
    Brevi particolari
    Chattels mortgage see doc 34 for details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile
    Transazioni
    • 31 dic 1996Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 09 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 29 gen 1996
    Consegnato il 02 feb 1996
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    595858
    Brevi particolari
    Chattels mortgage the goods referred to in the attached schedule and all books, manuals, hand- books, technical data, drawings, schedules and other documentation and any amendments to the goods.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile
    Transazioni
    • 02 feb 1996Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 09 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 28 apr 1995
    Consegnato il 01 mag 1995
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    546000
    Brevi particolari
    Chattel mortgage see doc 29 for details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Mercantile
    Transazioni
    • 01 mag 1995Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 09 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 30 nov 1993
    Consegnato il 17 dic 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Mortgage part of the lands comprised in folio nos 6186, 6189 and 34641 all county tyrone comprised in and demised by an indenture of lease dated 20/10/93 and made between the department of economic development of the of one part and the company of the other part and therein more particularly described as "all that part of the lands comprised in the above mentioned folios containing in the aggregate 10.887 acres or thereabouts as more particularly shown on the map attached hereto and thereon edged red" together with all machinery utensils chattels and things now or at any time hereafter upon all of the aforesaid premises.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank LTD
    Transazioni
    • 17 dic 1993Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 27 set 1993
    Consegnato il 11 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Floating charge the undertaking of the company and all its property whatsoever and wheresoever both present and future including its uncalled capital for the time being. Nb. The company shall not be at liberty without the previous consent in writing of northern bank limited to create any mortgage or charge or confer any lien on its assets or any part thereof or to sell or deal with its book or other debts or securities for money other- wise than for the purpose of getting in and realising the same in the ordinary way of business.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank LTD
    Transazioni
    • 11 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 27 set 1993
    Consegnato il 11 ott 1993
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Charge over all book debts all book debts and other debts now and from time to time hereafter due owing or incurred to the company.
    Persone aventi diritto
    • Northern Bank LTD
    Transazioni
    • 11 ott 1993Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 20 dic 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0