KMB DEVELOPMENTS LIMITED

KMB DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKMB DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società NI027521
    GiurisdizioneIrlanda del Nord
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KMB DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Costruzione di edifici residenziali (41202) / Costruzioni

    Dove si trova KMB DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Grove
    Main Street
    BT31 9DJ Castlewellan
    County Down
    Northern Ireland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di KMB DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per KMB DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2022

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2021

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2020

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2019

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2018

    2 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 giu 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 30 giu 2017

    2 pagineAA

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore giudiziario/gestore al 12 ott 2017

    2 pagine3.08(NI)

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore giudiziario/gestore al 12 ott 2017

    2 pagine3.08(NI)

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    5 pagineRM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore giudiziario/gestore al 12 ott 2017

    2 pagine3.08(NI)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore giudiziario/gestore al 12 ott 2017

    2 pagine3.08(NI)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore giudiziario/gestore al 12 ott 2017

    2 pagine3.08(NI)

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    5 pagineRM02

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    5 pagineRM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite dell'amministratore giudiziario/gestore al 12 ott 2017

    2 pagine3.08(NI)

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    5 pagineRM02

    Chi sono gli amministratori di KMB DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KELLY, James Joseph
    11 Slievehanny Road
    Castlewellan
    BT33 0EJ Co Down
    Segretario
    11 Slievehanny Road
    Castlewellan
    BT33 0EJ Co Down
    Northern Irish145726900001
    BROWN, Colm
    11 Tullybrannigan Road
    Newcastle
    BT33 0HR Co Down
    Amministratore
    11 Tullybrannigan Road
    Newcastle
    BT33 0HR Co Down
    Northern IrelandBritish145726880001
    KELLY, James Joseph
    11 Slievehanny Road
    Castlewellan
    BT33 0EJ Co Down
    Amministratore
    11 Slievehanny Road
    Castlewellan
    BT33 0EJ Co Down
    Northern IrelandNorthern Irish145726900001
    MCEVOY, Gerry
    71 Shan Slieve Drive
    Newcastle
    BT33 0HN Co Down
    Amministratore
    71 Shan Slieve Drive
    Newcastle
    BT33 0HN Co Down
    Northern IrelandBritish145726890001

    Chi sono le persone con controllo significativo di KMB DEVELOPMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr Colm Brown
    Main Street
    BT31 9DJ Castlewellan
    The Grove
    County Down
    Northern Ireland
    06 apr 2016
    Main Street
    BT31 9DJ Castlewellan
    The Grove
    County Down
    Northern Ireland
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Northern Ireland
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Mr James Joseph Kelly
    Main Street
    BT31 9DJ Castlewellan
    The Grove
    County Down
    Northern Ireland
    06 apr 2016
    Main Street
    BT31 9DJ Castlewellan
    The Grove
    County Down
    Northern Ireland
    No
    Nazionalità: Northern Irish
    Paese di residenza: Northern Ireland
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.
    Mr Gerry Mcevoy
    Main Street
    BT31 9DJ Castlewellan
    The Grove
    County Down
    Northern Ireland
    06 apr 2016
    Main Street
    BT31 9DJ Castlewellan
    The Grove
    County Down
    Northern Ireland
    No
    Nazionalità: British
    Paese di residenza: Northern Ireland
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% dei diritti di voto nella società.

    KMB DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Mortgage and charge
    Creato il 04 feb 2010
    Consegnato il 17 feb 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The lands and premises situate at and known as roslyn place, 20-26 bryansford road, newcastle, co. Down which said lands are comprised in folios DN112192, DN137239 and DN123327 all county down...see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 17 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 819 mag 2016Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 826 ott 2017Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 8
    Mortgage or charge
    Creato il 25 mar 2009
    Consegnato il 01 apr 2009
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage and charge. The lands and premises situate at and known as 42 ballinran road, kilkeel, co down which said lands are comprised in folio DN90903L co down.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 01 apr 2009Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 719 mag 2016Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 726 ott 2017Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 7
    Mortgage or charge
    Creato il 19 mar 2009
    Consegnato il 26 mar 2009
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies charge on account. All of the company's rights, title and interest in and to the security account (as defined below) the deposit and the debts represented thereby.. The company covenants with the bank that during the continuance of the security created by the charge:-.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 26 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (402R NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 30 mag 2008
    Consegnato il 03 giu 2008
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage and charge. 5 tullybrannigan crescent, newcastle, co down in folio DN35502L co down.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 03 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 14 apr 2008
    Consegnato il 16 apr 2008
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage and charge. The grove bar and lounge, 46-48 main street, castlewellan, co down comprised in folio DN151797 co down.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 16 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 619 mag 2016Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 615 nov 2017Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 6
    Mortgage or charge
    Creato il 03 mar 2008
    Consegnato il 19 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies charge on account. All of the compay's rights, title and interest in and to the security account, the deposit and the debt represented thereby.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 19 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 03 mar 2008
    Consegnato il 11 mar 2008
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage and charge. 14 causeway road, newcastle, co down comprised in folio DN134280 co down. The lands and premises situate at and known as no 16 causeway road, newcastke, co down now known as good companions hall, causeway road, newcastle, co down.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 11 mar 2008Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 519 mag 2016Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 515 nov 2017Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 5
    Mortgage or charge
    Creato il 11 giu 2007
    Consegnato il 19 giu 2007
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage and charge. All that parcel of land being part of the quarter of halftown of dromise or drumee next burren of maghera.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 19 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 419 mag 2016Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 426 ott 2017Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 4
    Mortgage or charge
    Creato il 05 giu 2007
    Consegnato il 13 giu 2007
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage and charge. " mount carmel ", 20 newcastle road, castlewellan, co down.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 13 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 02 feb 2007
    Consegnato il 14 feb 2007
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage and charge. All that and those that dwelling house and premises situate in the town of newcastle in the townland of ballaghbeg parish of kilcoo barony of upper iveagh lower half and county of down together with all and singular the rights members and appurtenances to said premises belonging to appertaining" which said dwelling house is now known as no. 12 bryansford road, newcastle, co. Down.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 14 feb 2007Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 319 mag 2016Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 326 ott 2017Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 3
    Mortgage or charge
    Creato il 18 ott 2006
    Consegnato il 23 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage and charge. The lands and premises comprised in folio DN107427 co down.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 23 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 04 lug 2006
    Consegnato il 06 lug 2006
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage and charge. All that plot or piece of ground on the south west side of the country road leading from kilkeel to byransford , known as roslyn cottage, 28 bryansford road, newcastle, co down.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 06 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (402R NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 19 mag 2006
    Consegnato il 02 giu 2006
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage and charge. 36,38 & 40 main street, annaghbeg, co down.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 02 giu 2006Registrazione di un'ipoteca (402R NI)
    • 219 mag 2016Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 226 ott 2017Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 2
    Mortgage or charge
    Creato il 08 dic 2004
    Consegnato il 13 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage/charge and counterpart mortgage/charge.. 2.1 mortgages/fixed charges. The mortgagor as beneficial owner as a continuing security for the payment and discharge of the indebtedness hereby:-. (A) property:. (1) grants and demises unto the bank so much of the property as is unregistered land being "all that and those the lands and premises situate at castle avenue and clarmont avenue, castlewellan, county down more particularly comprised in deed of conveyance dated 13TH february 2004 and made between hugh joseph king (1) hugh joseph king, elizabeth frances king and peter malachy king (2) elizabeth frances king and james damien king (3) and the mortgagor (4) and described therein as. See 402 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 13 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 26 nov 2004
    Consegnato il 01 dic 2004
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Al monies mortgage/charge. Folio no DN112204 county down.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 01 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 03 feb 2004
    Consegnato il 30 gen 2004
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies solicitors letter of undertaking to hold in trust the original deeds of property situate at castle avenue and clarmont avenue, castlewellan, county down, which has been purchased by the company.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 30 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 07 nov 2003
    Consegnato il 11 nov 2003
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies deed of charge a specific legal charge over the company's freehold and leasehold lands comprised in folio nos DN110635, DN100678L and DN110634L all county down.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 11 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 119 mag 2016Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
    • 126 ott 2017Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 1
    Mortgage or charge
    Creato il 16 apr 2003
    Consegnato il 25 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage/charge all that part of the lands and premises comprised in folio number DN33700 county down............................. See doc 44 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 25 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 20 ago 2002
    Consegnato il 28 ago 2002
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Certain monies. A solicitor's letter of undertaking hold title deeds of hillyard house 1-5 castle avenue castlewellan county down to the order of ulster bank limited and to forward same upon completion of registration formalities.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 28 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 02 feb 2001
    Consegnato il 16 feb 2001
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Deed of mortgage. A specific mortgage over the company's freehold lands situate in the townland of tollymore barony of upper iveagh (lower half) and county of down more particularly described in indenture of conveyance dated the 2ND day of february 2001 and made between richard brian mclain of the one part and the company of the other part.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    • Belfast
    • Lombard & Ulster LTD
    Transazioni
    • 16 feb 2001Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 02 ott 2000
    Consegnato il 10 ott 2000
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies. Debenture. 1(A) lands known as the quarry at castlewellan road, dundrum, county down containing approx. 2 acres 3 roods. (B) lands at dromara road, dundrum county down containing 3.85 acres or thereabouts see doc 33 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 10 ott 2000Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 02 ago 2000
    Consegnato il 11 ago 2000
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    A specific mortgage over the company's freehold lands situate on the west side of main street, dundrum, parish of kilmegan, barony of lecale and county of down more particularly described in indenture of conveyance dated the 2ND day of august 2000 and made between brian maguire and keith toner of the one part and the company of the other part.
    Persone aventi diritto
    • Lombard & Ulster LTD
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 11 ago 2000Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 14 mag 1999
    Consegnato il 17 mag 1999
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Deed of mortgage - all monies a specific legal mortgage over the company's freehold land situate in the townland of dundrum barony of lecale upper and county of down more particularly described in indenture of conveyance dated the 17TH day of march 1921 and made between the most honourable the marquis of downshire (1) the right honourable william hill and the honourable charles edward hill trevor (2) and john mccafferty (3).
    Persone aventi diritto
    • Lombard & Ulster
    • Ulster Bank LTD
    Transazioni
    • 17 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 30 apr 1999
    Consegnato il 10 mag 1999
    In corso
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Mortgage. No. 64 carrigvale, dromara road, dundrum co down.
    Persone aventi diritto
    • First Active
    Transazioni
    • 10 mag 1999Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 08 set 1997
    Consegnato il 26 set 1997
    In corso
    Importo garantito
    112000
    Brevi particolari
    Mortgage the companys premises known as lot 61 in the townland of dundrum the quarry at castlewellan road, dundrum and dromara road dundrum. See doc 22 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Irish Nationwide
    Transazioni
    • 26 set 1997Registrazione di un'ipoteca (402 NI)

    KMB DEVELOPMENTS LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Ricevitore/gestore
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Ricevitore/gestore
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Ricevitore/gestore
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Ricevitore/gestore
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    3Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Ricevitore/gestore
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Ricevitore/gestore
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    4Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Ricevitore/gestore
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Ricevitore/gestore
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    5Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Ricevitore/gestore
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Ricevitore/gestore
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    6Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Ricevitore/gestore
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Ricevitore/gestore
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    7Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Ricevitore/gestore
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Ricevitore/gestore
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    8Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew Dolliver
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Ricevitore/gestore
    Bedford House 16 Bedford Street
    BT2 7DT Belfast
    Joseph Luke Carleton
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin
    Ricevitore/gestore
    Harcourt Centre Harcourt Street
    4 Dublin

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0