MARCAM PROPERTIES LIMITED

MARCAM PROPERTIES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARCAM PROPERTIES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società NI048417
    GiurisdizioneIrlanda del Nord
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MARCAM PROPERTIES LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova MARCAM PROPERTIES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4a Enterprise Road
    BT19 7TA Bangor
    Down
    Northern Ireland
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARCAM PROPERTIES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per MARCAM PROPERTIES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere NI0484170010 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 07/02/2018
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 09/01/2018
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 30/11/2017
    RES13

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2017

    8 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 06/10/2017
    RES13

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Millar Mccall Wylie Llp Solicitors Imperial House 4-10 Donegall Square East Belfast BT1 5HD Northern Ireland a 4a Enterprise Road Bangor Down BT19 7TA in data 19 lug 2017

    1 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 28/06/2017
    RES13

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    5 pagineMR04

    Nomina di Mr Mark Edward Rebbeck come amministratore in data 22 giu 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 apr 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Stephen David Bell come amministratore in data 09 gen 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sean Gerard Mccann come amministratore in data 09 gen 2017

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Lagan House 19 Clarendon Road Belfast BT1 3BG Northern Ireland a C/O C/O Millar Mccall Wylie Llp Solicitors Imperial House 4-10 Donegall Square East Belfast BT1 5HD in data 23 gen 2017

    1 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 09/01/2017
    RES13

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    10 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 26 mag 2016 al 30 giu 2016

    3 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 21 apr 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 mag 2016

    Stato del capitale al 03 mag 2016

    • Capitale: GBP 1,166,722
    SH01

    Secondo deposito di SH01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio

    6 pagineRP04
    Note
    DataNota
    04 mar 2016Second Filing ALLOTMENT DATE-26/05/2015

    Chi sono gli amministratori di MARCAM PROPERTIES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROWN, Michael James
    Enterprise Road
    BT19 7TA Bangor
    4a
    County Down
    Northern Ireland
    Amministratore
    Enterprise Road
    BT19 7TA Bangor
    4a
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish174874620001
    QUINN, William Paul
    Enterprise Road
    BT19 7TA Bangor
    4a
    County Down
    Northern Ireland
    Amministratore
    Enterprise Road
    BT19 7TA Bangor
    4a
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandNorthern Irish197049610001
    REBBECK, Mark Edward
    Enterprise Road
    BT19 7TA Bangor
    4a
    Northern Ireland
    Amministratore
    Enterprise Road
    BT19 7TA Bangor
    4a
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish149875430002
    MURPHY, Noel Ferris
    152 Warren Road
    Donaghadee
    BT21 0PQ Co Down
    Segretario
    152 Warren Road
    Donaghadee
    BT21 0PQ Co Down
    British145230930001
    BELL, Stephen David
    c/o C/O Millar Mccall Wylie Llp Solicitors
    4-10 Donegall Square East
    BT1 5HD Belfast
    Imperial House
    Northern Ireland
    Amministratore
    c/o C/O Millar Mccall Wylie Llp Solicitors
    4-10 Donegall Square East
    BT1 5HD Belfast
    Imperial House
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish96599120002
    CAMPBELL, Charles Stanley
    301 Killaughey Road
    Donaghadee
    BT21 0LY Co.Down
    Amministratore
    301 Killaughey Road
    Donaghadee
    BT21 0LY Co.Down
    Northern IrelandBritish143650960001
    MCCANN, Sean Gerard
    c/o C/O Millar Mccall Wylie Llp Solicitors
    4-10 Donegall Square East
    BT1 5HD Belfast
    Imperial House
    Northern Ireland
    Amministratore
    c/o C/O Millar Mccall Wylie Llp Solicitors
    4-10 Donegall Square East
    BT1 5HD Belfast
    Imperial House
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish145301830001
    MCPARLAND, Damien
    7 Willowbank Drive
    Belfast
    BT6 OLN
    Amministratore
    7 Willowbank Drive
    Belfast
    BT6 OLN
    British143554140001
    MURPHY, Noel Ferris
    152 Warren Road
    Donaghadee
    BT21 0PQ County Down
    Amministratore
    152 Warren Road
    Donaghadee
    BT21 0PQ County Down
    Northern IrelandBritish145230930001
    RUSH, William
    140 Warren Road
    Donaghadee
    BT21 0PQ Co.Down
    Amministratore
    140 Warren Road
    Donaghadee
    BT21 0PQ Co.Down
    Northern IrelandBritish99727010001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per MARCAM PROPERTIES LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    21 apr 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    MARCAM PROPERTIES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 mag 2015
    Consegnato il 04 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Leasehold land situated at 72 donaghadee road, bangor, county down, BT20 4QX and comprised in folio DN158835L county down.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Situs Asset Management Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 04 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge over bank account
    Creato il 15 mar 2013
    Consegnato il 20 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The account having account number 10242071 held in the name of the chargor with aib group (UK) PLC at 31-35 high street, belfast. As security for the payment, performance and discharge of the secured obligations, the chargor as legal and beneficial owner hereby charges by way of first fixed charge in favour of the lender all the chargor's present and future right, title and interest in and to all sums from time to time standing to the credit of the secured account. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Asset Loan Management Limited
    Transazioni
    • 20 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge over bank account
    Creato il 15 mar 2013
    Consegnato il 20 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The account having account number 61525791 held in the name of the chargor with bank of ireland (UK) PLC at 312 conway square, newtownards, county down. As security for the payment, performance and discharge of the secured obligations, the chargor as legal and beneficial owner hereby charges by way of first fixed charge in favour of the lender all the chargor's present and future right, title and interest in and to all sums from time to time standing to the credit of the secured account. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Asset Loan Management Limited
    Transazioni
    • 20 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 11 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 03 ago 2007
    Consegnato il 06 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage/charge deed. All that the leasehold property known as: 72 donaghadee road, bangor in the county of down,.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 06 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 11 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 12 giu 2007
    Consegnato il 18 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage/charge deed. 74 and 76 donaghadee road, bangor.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 18 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 11 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 04 nov 2005
    Consegnato il 22 nov 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Charge - all monies. 1. all that and those the hereditaments and premises situate at and known as a site at quarry heights, newtownards as more particularly described and comprised in folio dn 64450L county down...........
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transazioni
    • 22 nov 2005Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 11 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 28 gen 2005
    Consegnato il 15 feb 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies legal charge.. The property situate and known as site at rosevale avenue, newtownards being all that part of the lands in folio 43715 county down shown edged red on the map annexed hereto.. See 402 for further details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transazioni
    • 15 feb 2005Registrazione di un'ipoteca (402R NI)
    • 11 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 15 nov 2004
    Consegnato il 22 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies legal charge. All monies legal charge. 39 north road, newtownards county down.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transazioni
    • 22 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 11 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 07 nov 2003
    Consegnato il 12 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies legal mortgage and charge the premises situate at and known as 12 annadale avenue, belfast.
    Persone aventi diritto
    • 10-15 Donegall
    • Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 12 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 07 nov 2003
    Consegnato il 12 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies debenture all freehold and leasehold property of the company both present and future and all building and fixtures (including trade fixtures) plant machinery vehicles computers and office and other equipment.... See doc 5 for further details.
    Persone aventi diritto
    • 10-15 Donegall
    • Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 12 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0