MALONEVIEW DEVELOPMENTS LTD

MALONEVIEW DEVELOPMENTS LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMALONEVIEW DEVELOPMENTS LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società NI050459
    GiurisdizioneIrlanda del Nord
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MALONEVIEW DEVELOPMENTS LTD?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari

    Dove si trova MALONEVIEW DEVELOPMENTS LTD?

    Indirizzo della sede legale
    4a Mar Properties Ltd
    4a Enterprise Road
    BT19 7TA
    BT19 7TA Bangor
    Down
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MALONEVIEW DEVELOPMENTS LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 giu 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per MALONEVIEW DEVELOPMENTS LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere NI0504590007 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere NI0504590008 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 07/02/2018
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 09/01/2018
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 30/11/2017
    RES13

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 giu 2017

    8 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 06/10/2017
    RES13

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 28/06/2017
    RES13

    Nomina di Mr Mark Edward Rebbeck come amministratore in data 22 giu 2017

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O C/O Millar Mccall Wylie Llp Solicitors Imperial House 4-10 Donegall Square East Belfast BT1 5HD Northern Ireland a PO Box BT19 7TA 4a Mar Properties Ltd 4a Enterprise Road Bangor Down BT19 7TA in data 25 mag 2017

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 11 mag 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Lagan House 19 Clarendon Road Belfast BT1 3BG Northern Ireland a C/O C/O Millar Mccall Wylie Llp Solicitors Imperial House 4-10 Donegall Square East Belfast BT1 5HD in data 23 gen 2017

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Stephen David Bell come amministratore in data 09 gen 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Sean Gerard Mccann come amministratore in data 09 gen 2017

    1 pagineTM01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 09/01/2017
    RES13

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    10 pagineAA

    Modifica della data di chiusura dell'esercizio contabile

    3 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 11 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 mag 2016

    Stato del capitale al 25 mag 2016

    • Capitale: GBP 4,018,903
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 26 mag 2015

    8 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 4a Enterprise Road Bangor BT19 7TA a Lagan House 19 Clarendon Road Belfast BT1 3BG in data 12 ott 2015

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr William Quinn il 09 ott 2015

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di MALONEVIEW DEVELOPMENTS LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BROWN, Michael James
    Enterprise Road
    BT19 7TA Bangor
    4a
    County Down
    Northern Ireland
    Amministratore
    Enterprise Road
    BT19 7TA Bangor
    4a
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish174874620001
    QUINN, William Paul
    Enterprise Road
    BT19 7TA Bangor
    4a
    County Down
    Northern Ireland
    Amministratore
    Enterprise Road
    BT19 7TA Bangor
    4a
    County Down
    Northern Ireland
    Northern IrelandNorthern Irish197049610001
    REBBECK, Mark Edward
    Enterprise Road
    BT19 7TA Bangor
    4a
    Northern Ireland
    Amministratore
    Enterprise Road
    BT19 7TA Bangor
    4a
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish149875430002
    SINNAMON, John Alfred
    Berkeley Hall Square
    BT27 5TB Lisburn
    19
    County Antrim
    Northern Ireland
    Segretario
    Berkeley Hall Square
    BT27 5TB Lisburn
    19
    County Antrim
    Northern Ireland
    British143223130001
    C.S. SECRETARIAL SERVICES LTD
    79 Chichester Street
    Belfast
    BT1 4JE
    Segretario
    79 Chichester Street
    Belfast
    BT1 4JE
    70217690001
    BELL, Stephen David
    19 Clarendon Road
    BT1 3BG Belfast
    Lagan House
    Northern Ireland
    Amministratore
    19 Clarendon Road
    BT1 3BG Belfast
    Lagan House
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish96599120002
    HORNER, Robin George
    4a Enterprise Road
    Bangor
    BT19 7TA
    Amministratore
    4a Enterprise Road
    Bangor
    BT19 7TA
    United KingdomBritish145344800001
    MCCANN, Sean Gerard
    19 Clarendon Road
    BT1 3BG Belfast
    Lagan House
    Northern Ireland
    Amministratore
    19 Clarendon Road
    BT1 3BG Belfast
    Lagan House
    Northern Ireland
    Northern IrelandBritish145301830001
    MURPHY, Noel Ferris
    4a Enterprise Road
    Bangor
    BT19 7TA
    Amministratore
    4a Enterprise Road
    Bangor
    BT19 7TA
    Northern IrelandBritish145230930001
    RUSH, William
    4a Enterprise Road
    Bangor
    BT19 7TA
    Amministratore
    4a Enterprise Road
    Bangor
    BT19 7TA
    Northern IrelandBritish99727010001
    SINNAMON, John Alfred
    13 Old Coach Avenue
    Belfast
    BT9 5PY Co Antrim
    Amministratore
    13 Old Coach Avenue
    Belfast
    BT9 5PY Co Antrim
    Northern IrelandBritish143223130001
    STARK, Peter Stanley Robert
    15 Crawford House
    Crawfordsburn
    BT19 1XL Co Down
    Amministratore
    15 Crawford House
    Crawfordsburn
    BT19 1XL Co Down
    Northern IrelandBritish143525320001
    CS DIRECTOR SERVICES LIMITED
    79 Chichester Street
    Belfast
    BT1 4JE
    Amministratore
    79 Chichester Street
    Belfast
    BT1 4JE
    144445660001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per MALONEVIEW DEVELOPMENTS LTD?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    11 mag 2017La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    MALONEVIEW DEVELOPMENTS LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 26 mag 2015
    Consegnato il 04 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    None at the date of the security agreement.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Situs Asset Management Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 04 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 26 mag 2015
    Consegnato il 04 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Land known as units 1, 2, 3 and 4 crabtree manorway, belvedere, DA17 6AT comprised of title numbers SGL626282 (1) and SGL625683 (2).
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Situs Asset Managment Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 04 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 giu 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 23 dic 2013
    Consegnato il 06 gen 2014
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Security assignment over account number 15098122 with sort code 93-80-92 held in the name of the company with aib group (UK) PLC. Notification of addition to or amendment of charge.
    Persone aventi diritto
    • National Asset Loan Management Limited
    Transazioni
    • 06 gen 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 05 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge over bank account
    Creato il 15 mar 2013
    Consegnato il 20 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The account having account number 20119711 held in the same of the chargor with bank of ireland (UK) PLC at 1 donegall square south, belfast, BT1 5LR. As security for the payment, performance and discharge of the secured obligations, the chargor as legal and beneficial owner hereby charges by way of first fixed charge in favour of the lender all the chargor's present and future right, title and interest in and to all sums from time to time standing to the credit of the secured account. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Asset Loan Management Limited
    Transazioni
    • 20 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 08 dic 2005
    Consegnato il 21 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Debenture - all monies. (Firstly) all the freehold land and buildings and all buildings, structures, fixtures ( including) trade fixtures) and fixed plant, machinery and equipment from time to time thereon.. (Secondly) all future freehold and leasehold property of the company and all buildings, structures fixtures ( including trade fixtures) and fixed plant, machinery and equipment from time to time thereon.. (Thirdly) all present nad future goodwill and connection of all businesses carried on by or on behalf..................
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 21 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (402R NI)
    • 05 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 01 lug 2005
    Consegnato il 04 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Mortgage - all monies. 56 north road, newtownards, co down..... See 402 for further details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 04 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    Mortgage or charge
    Creato il 06 ago 2004
    Consegnato il 09 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies legal charge units 1-4 crabtree manorway north belvedere kent registered at the land registry under title numbers SGL626282 and SGL625683.
    Persone aventi diritto
    • Governor & Co. Boi
    Transazioni
    • 09 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 05 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage or charge
    Creato il 23 giu 2004
    Consegnato il 06 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies charge the lands comprised in folio DN97612 county down.
    Persone aventi diritto
    • Governor & Co. Boi
    Transazioni
    • 06 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 05 giu 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0