APT LICENSING LIMITED
Panoramica
Nome della società | APT LICENSING LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | NI054094 |
Giurisdizione | Irlanda del Nord |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | Sì |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di APT LICENSING LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova APT LICENSING LIMITED?
Indirizzo della sede legale | C/O Deloitte (Ni) Limited Lincoln Building 27-45 Great Victoria Street BT2 7AQ Belfast |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di APT LICENSING LIMITED?
Nome della società | Da | A |
---|---|---|
AUDIO PROCESSING TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED | 12 apr 2005 | 12 apr 2005 |
PRIMUS ASSOCIATES LIMITED | 01 mar 2005 | 01 mar 2005 |
Quali sono gli ultimi bilanci di APT LICENSING LIMITED?
Ultimi bilanci | |
---|---|
Ultimi bilanci redatti al | 29 set 2019 |
Quali sono le ultime deposizioni per APT LICENSING LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Rendiconto delle entrate e delle uscite al 11 mag 2021 | 5 pagine | 4.69(NI) | ||||||||||
Verbale della riunione finale in una liquidazione volontaria dei soci | 3 pagine | 4.72(NI) | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 19 Bedford Street Belfast BT2 7EJ a C/O Deloitte (Ni) Limited Lincoln Building 27-45 Great Victoria Street Belfast BT2 7AQ in data 15 apr 2021 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Vistra Company Secretaries Limited come segretario in data 12 feb 2021 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 3 pagine | 4.71(NI) | ||||||||||
Nomina di un liquidatore | 1 pagine | VL1 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Unit 2 Ground Floor South the Legacy Bldg Northern Ireland Science Park Queens Road Queens Island Belfast Co. Antrim BT3 9DT a 19 Bedford Street Belfast BT2 7EJ in data 12 ago 2020 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2019 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Jordan Company Secretaries Limited il 05 apr 2019 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2019 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 24 set 2017 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2018 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Declan Sharkey come amministratore in data 17 nov 2017 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Gordon Thomas Rowe come amministratore in data 17 nov 2017 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Jordan Company Secretaries Limited il 16 ago 2017 | 1 pagine | CH04 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 25 set 2016 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2017 con aggiornamenti | 7 pagine | CS01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 27 set 2015 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mr Declan Sharkey come amministratore in data 16 ott 2015 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Brett Gladden come segretario in data 30 set 2015 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di APT LICENSING LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROWE, Gordon Thomas | Amministratore | Qualcomm Incorporated 5775 Morehouse Drive San Diego C/O Angela Gonzales California 92121 United States | United Kingdom | Canadian | Sr. Director, Finance | 230132290001 | ||||||||
GLADDEN, Brett | Segretario | Garden Close Great Barton IP31 2SY Bury St. Edmunds 4 Suffolk United Kingdom | British | 153218580001 | ||||||||||
KANE, Dorothy May | Segretario | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | British | 77579520001 | ||||||||||
MCKENNA, Noel | Segretario | 57 Ballygrooby Road Magherafelt BT45 7XF Co Derry | 145443600001 | |||||||||||
MCKENNA, Noel Eamon | Segretario | 5 Manor Park Magherafelt BT45 6QE | 145443670001 | |||||||||||
WEIR, Mark | Segretario | 18 Carmavy Road Nutts Corner BT29 4TG Crumlin Co Antrim | 145443630001 | |||||||||||
VISTRA COMPANY SECRETARIES LIMITED | Segretario | Templeback 10 Temple Back BS1 6FL Bristol First Floor |
| 97584300011 | ||||||||||
BEVIS, Alexander Peter | Amministratore | Home Close CB24 9JL Histon 3 Cambridge United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 153431010001 | ||||||||
BOURKE, Gavin | Amministratore | 4 Millmount Avenue Drumcondra Dublin 4 | Ireland | Irish | Investment Associate | 145443700001 | ||||||||
BUEHRING, Klaus Dieter | Amministratore | Northern Ireland Science Park Queens Road Queens Island BT3 9DT Belfast Unit 2 Ground Floor South The Legacy Bldg Co. Antrim | United States Of America | German | Svp Development | 159847790001 | ||||||||
DOHERTY, James Gerald | Amministratore | 170 Dunmore Rd Ballynahinch BT24 8QQ Co Down | Northern Ireland | British | Chief Executive Officer | 144339490001 | ||||||||
GARDINER, Dwight Daniel Willard | Amministratore | SW5 | United Kingdom | British,American | Chief Financial Officer | 76076980002 | ||||||||
HARRISON, Malcolm Joseph | Amministratore | 21 Acre Lane Waringstown BT66 7SG Craigavon Co Armagh | British | I.T. Manager | 145443660001 | |||||||||
HOWARD, Quentin | Amministratore | Stibb Hill House West Levington SN10 4LL Wiltshire England | England | British | Director | 266091690001 | ||||||||
KANE, Dorothy May | Amministratore | 111 Knockview Drive Tandragee BT62 2BL Co Armagh | Northern Ireland | British | Company Director | 77579520001 | ||||||||
LILLYWHITE, John George, Dr | Amministratore | Delicias Pine Walk KT24 5AG Easthorsley Surrey | England | English | Consultant | 12296950001 | ||||||||
MCCLINTOCK, Jonathan | Amministratore | 34 Knockvale Park Belfast BT5 6HU | Northern Ireland | Irish | Commercial Director | 145443690001 | ||||||||
MCKENNA, Noel Eamon | Amministratore | 57 Ballygroovy Road The Loop BT45 7XF Magherafelt Co Derry | Northern Ireland | Irish | Managing Director | 189432870001 | ||||||||
SHARKEY, Declan | Amministratore | Northern Ireland Science Park Queens Road Queens Island BT3 9DT Belfast Unit 2 Ground Floor South The Legacy Bldg Co. Antrim | England | American | Director | 202917160001 | ||||||||
SKELTON, Andrew Keith | Amministratore | Northern Ireland Science Park Queens Road Queens Island BT3 9DT Belfast Unit 2 Ground Floor South The Legacy Bldg Co. Antrim | United Kingdom | British | Finance Director | 172965530001 | ||||||||
TRAINOR, David William | Amministratore | Carlton Hills Carryduff BT8 8BZ Belfast 9 County Antrim Northern Ireland | Northern Ireland | Northern Irish | Director | 146073800001 | ||||||||
VAN BEURDEN, Jozef Aloysius Johannes | Amministratore | Mill Road Harston CB22 7NF Cambridge 2 England | England | Dutch | Chief Executive Officer | 153217710003 | ||||||||
WEIR, Mark | Amministratore | 18 Carmavy Road Nutts Corner BT29 4TG Crumlin Co Antrim | Northern Ireland | British | 144339500001 | |||||||||
WILSON, Henry Richard Ernest | Amministratore | 10 Stockbridge Road Donaghadee BT21 ORN | Northern Ireland | British | Investment Manager | 172372060001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di APT LICENSING LIMITED?
Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cambridge Silicon Radio Holdings Limited | 06 apr 2016 | Cambridge Business Park Cowley Road CB4 0WZ Cambridge Churchill House Cambridgeshire | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
|
APT LICENSING LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 19 giu 2009 Consegnato il 24 giu 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari All monies mortgage debenture. By way of a floating charge all the companys undertaking property and assets whatsoever and wheresoever both present and future including goodwill and its uncalled capital. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Mortgage or charge | Creato il 31 dic 2008 Consegnato il 05 gen 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari All monies charge over trademarks. All future applications for registration of the trademarks made by or on behalf of the chargor and all future rights of the chargor to apply for trademark or similar types of protection in any country of the world and all registration of trademarks granted hereinafter and from time to time in any country of the world as a result of any such applications and all prolongations, renewals, divisionals and extensions of any of the foregoing. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Debenture | Creato il 13 apr 2006 Consegnato il 02 mag 2006 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito 0 | |
Brevi particolari Mortgage debenture - all monies. The company as security for the payment and discharge of the secured obligations (as defined in the mortgage debenture) as beneficial owner hereby:. (I) demises and assigns unto the bank so much of the hereditaments and premises described or referred to in the schedule of the mortgage debenture as are unregistered land to hold as to so much thereof as are freehold unto the bank for the term of ten thousand years from the date hereof without impeachment of waste and as to so much thereof as are leasehold unto the bank for the residue or residues of the term of respective terms of years for which the same are held less the last three days of such term or of each of such terms without impeachment of waste and........................... (F) (I) by way of fixed charge , charges all the bonds, stocks shares and other securities the certificates or other documents of title for which have been deposited by the company with the bank, and which are listed in the second schedule hereto, and any securities substituted with the bank's prior written consent, ( all of which are hereinafter called " the charged shares"), being. Company. Audio processing technology limited. Registered owner. Audio processing technology holdings limited. Holdings. 20,245 ordinary "a" shares of £ 1.00 each. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
APT LICENSING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0