APT LICENSING LIMITED

APT LICENSING LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAPT LICENSING LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società NI054094
    GiurisdizioneIrlanda del Nord
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di APT LICENSING LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova APT LICENSING LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Deloitte (Ni) Limited Lincoln Building
    27-45 Great Victoria Street
    BT2 7AQ Belfast
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di APT LICENSING LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    AUDIO PROCESSING TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED12 apr 200512 apr 2005
    PRIMUS ASSOCIATES LIMITED01 mar 200501 mar 2005

    Quali sono gli ultimi bilanci di APT LICENSING LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 set 2019

    Quali sono le ultime deposizioni per APT LICENSING LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rendiconto delle entrate e delle uscite al 11 mag 2021

    5 pagine4.69(NI)

    Verbale della riunione finale in una liquidazione volontaria dei soci

    3 pagine4.72(NI)

    Indirizzo della sede legale modificato da 19 Bedford Street Belfast BT2 7EJ a C/O Deloitte (Ni) Limited Lincoln Building 27-45 Great Victoria Street Belfast BT2 7AQ in data 15 apr 2021

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di Vistra Company Secretaries Limited come segretario in data 12 feb 2021

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.71(NI)

    Nomina di un liquidatore

    1 pagineVL1

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    insolvency

    Risoluzione speciale per la liquidazione

    LRESM(NI)

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 2 Ground Floor South the Legacy Bldg Northern Ireland Science Park Queens Road Queens Island Belfast Co. Antrim BT3 9DT a 19 Bedford Street Belfast BT2 7EJ in data 12 ago 2020

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 29 set 2019

    9 pagineAA

    Conto per una società dormiente redatto al 30 set 2018

    9 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Jordan Company Secretaries Limited il 05 apr 2019

    1 pagineCH04

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 24 set 2017

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2018 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Cessazione della carica di Declan Sharkey come amministratore in data 17 nov 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Gordon Thomas Rowe come amministratore in data 17 nov 2017

    2 pagineAP01

    Dettagli del segretario cambiati per Jordan Company Secretaries Limited il 16 ago 2017

    1 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 25 set 2016

    9 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 mar 2017 con aggiornamenti

    7 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 27 set 2015

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 01 mar 2016 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital06 mag 2016

    Stato del capitale al 06 mag 2016

    • Capitale: GBP 140,123.17
    SH01

    Nomina di Mr Declan Sharkey come amministratore in data 16 ott 2015

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Brett Gladden come segretario in data 30 set 2015

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di APT LICENSING LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    ROWE, Gordon Thomas
    Qualcomm Incorporated
    5775 Morehouse Drive
    San Diego
    C/O Angela Gonzales
    California 92121
    United States
    Amministratore
    Qualcomm Incorporated
    5775 Morehouse Drive
    San Diego
    C/O Angela Gonzales
    California 92121
    United States
    United KingdomCanadianSr. Director, Finance230132290001
    GLADDEN, Brett
    Garden Close
    Great Barton
    IP31 2SY Bury St. Edmunds
    4
    Suffolk
    United Kingdom
    Segretario
    Garden Close
    Great Barton
    IP31 2SY Bury St. Edmunds
    4
    Suffolk
    United Kingdom
    British153218580001
    KANE, Dorothy May
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    Segretario
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    British77579520001
    MCKENNA, Noel
    57 Ballygrooby Road
    Magherafelt
    BT45 7XF Co Derry
    Segretario
    57 Ballygrooby Road
    Magherafelt
    BT45 7XF Co Derry
    145443600001
    MCKENNA, Noel Eamon
    5 Manor Park
    Magherafelt
    BT45 6QE
    Segretario
    5 Manor Park
    Magherafelt
    BT45 6QE
    145443670001
    WEIR, Mark
    18 Carmavy Road
    Nutts Corner
    BT29 4TG Crumlin
    Co Antrim
    Segretario
    18 Carmavy Road
    Nutts Corner
    BT29 4TG Crumlin
    Co Antrim
    145443630001
    VISTRA COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    Segretario
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione00555893
    97584300011
    BEVIS, Alexander Peter
    Home Close
    CB24 9JL Histon
    3
    Cambridge
    United Kingdom
    Amministratore
    Home Close
    CB24 9JL Histon
    3
    Cambridge
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant153431010001
    BOURKE, Gavin
    4 Millmount Avenue
    Drumcondra
    Dublin 4
    Amministratore
    4 Millmount Avenue
    Drumcondra
    Dublin 4
    IrelandIrishInvestment Associate145443700001
    BUEHRING, Klaus Dieter
    Northern Ireland Science Park
    Queens Road Queens Island
    BT3 9DT Belfast
    Unit 2 Ground Floor South The Legacy Bldg
    Co. Antrim
    Amministratore
    Northern Ireland Science Park
    Queens Road Queens Island
    BT3 9DT Belfast
    Unit 2 Ground Floor South The Legacy Bldg
    Co. Antrim
    United States Of AmericaGermanSvp Development159847790001
    DOHERTY, James Gerald
    170 Dunmore Rd
    Ballynahinch
    BT24 8QQ Co Down
    Amministratore
    170 Dunmore Rd
    Ballynahinch
    BT24 8QQ Co Down
    Northern IrelandBritishChief Executive Officer144339490001
    GARDINER, Dwight Daniel Willard
    SW5
    Amministratore
    SW5
    United KingdomBritish,AmericanChief Financial Officer76076980002
    HARRISON, Malcolm Joseph
    21 Acre Lane
    Waringstown
    BT66 7SG Craigavon
    Co Armagh
    Amministratore
    21 Acre Lane
    Waringstown
    BT66 7SG Craigavon
    Co Armagh
    BritishI.T. Manager145443660001
    HOWARD, Quentin
    Stibb Hill House
    West Levington
    SN10 4LL Wiltshire
    England
    Amministratore
    Stibb Hill House
    West Levington
    SN10 4LL Wiltshire
    England
    EnglandBritishDirector266091690001
    KANE, Dorothy May
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    Amministratore
    111 Knockview Drive
    Tandragee
    BT62 2BL Co Armagh
    Northern IrelandBritishCompany Director77579520001
    LILLYWHITE, John George, Dr
    Delicias
    Pine Walk
    KT24 5AG Easthorsley
    Surrey
    Amministratore
    Delicias
    Pine Walk
    KT24 5AG Easthorsley
    Surrey
    EnglandEnglishConsultant12296950001
    MCCLINTOCK, Jonathan
    34 Knockvale Park
    Belfast
    BT5 6HU
    Amministratore
    34 Knockvale Park
    Belfast
    BT5 6HU
    Northern IrelandIrishCommercial Director145443690001
    MCKENNA, Noel Eamon
    57 Ballygroovy Road
    The Loop
    BT45 7XF Magherafelt
    Co Derry
    Amministratore
    57 Ballygroovy Road
    The Loop
    BT45 7XF Magherafelt
    Co Derry
    Northern IrelandIrishManaging Director189432870001
    SHARKEY, Declan
    Northern Ireland Science Park
    Queens Road Queens Island
    BT3 9DT Belfast
    Unit 2 Ground Floor South The Legacy Bldg
    Co. Antrim
    Amministratore
    Northern Ireland Science Park
    Queens Road Queens Island
    BT3 9DT Belfast
    Unit 2 Ground Floor South The Legacy Bldg
    Co. Antrim
    EnglandAmericanDirector202917160001
    SKELTON, Andrew Keith
    Northern Ireland Science Park
    Queens Road Queens Island
    BT3 9DT Belfast
    Unit 2 Ground Floor South The Legacy Bldg
    Co. Antrim
    Amministratore
    Northern Ireland Science Park
    Queens Road Queens Island
    BT3 9DT Belfast
    Unit 2 Ground Floor South The Legacy Bldg
    Co. Antrim
    United KingdomBritishFinance Director172965530001
    TRAINOR, David William
    Carlton Hills
    Carryduff
    BT8 8BZ Belfast
    9
    County Antrim
    Northern Ireland
    Amministratore
    Carlton Hills
    Carryduff
    BT8 8BZ Belfast
    9
    County Antrim
    Northern Ireland
    Northern IrelandNorthern IrishDirector146073800001
    VAN BEURDEN, Jozef Aloysius Johannes
    Mill Road
    Harston
    CB22 7NF Cambridge
    2
    England
    Amministratore
    Mill Road
    Harston
    CB22 7NF Cambridge
    2
    England
    EnglandDutchChief Executive Officer153217710003
    WEIR, Mark
    18 Carmavy Road
    Nutts Corner
    BT29 4TG Crumlin
    Co Antrim
    Amministratore
    18 Carmavy Road
    Nutts Corner
    BT29 4TG Crumlin
    Co Antrim
    Northern IrelandBritish144339500001
    WILSON, Henry Richard Ernest
    10 Stockbridge Road
    Donaghadee
    BT21 ORN
    Amministratore
    10 Stockbridge Road
    Donaghadee
    BT21 ORN
    Northern IrelandBritishInvestment Manager172372060001

    Chi sono le persone con controllo significativo di APT LICENSING LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Cambridge Business Park
    Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Churchill House
    Cambridgeshire
    06 apr 2016
    Cambridge Business Park
    Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Churchill House
    Cambridgeshire
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleUk
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07624969
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    APT LICENSING LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 19 giu 2009
    Consegnato il 24 giu 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies mortgage debenture. By way of a floating charge all the companys undertaking property and assets whatsoever and wheresoever both present and future including goodwill and its uncalled capital.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 24 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (402 NI)
    • 26 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Mortgage or charge
    Creato il 31 dic 2008
    Consegnato il 05 gen 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    All monies charge over trademarks. All future applications for registration of the trademarks made by or on behalf of the chargor and all future rights of the chargor to apply for trademark or similar types of protection in any country of the world and all registration of trademarks granted hereinafter and from time to time in any country of the world as a result of any such applications and all prolongations, renewals, divisionals and extensions of any of the foregoing.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 05 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (402R NI)
    Debenture
    Creato il 13 apr 2006
    Consegnato il 02 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    0
    Brevi particolari
    Mortgage debenture - all monies. The company as security for the payment and discharge of the secured obligations (as defined in the mortgage debenture) as beneficial owner hereby:. (I) demises and assigns unto the bank so much of the hereditaments and premises described or referred to in the schedule of the mortgage debenture as are unregistered land to hold as to so much thereof as are freehold unto the bank for the term of ten thousand years from the date hereof without impeachment of waste and as to so much thereof as are leasehold unto the bank for the residue or residues of the term of respective terms of years for which the same are held less the last three days of such term or of each of such terms without impeachment of waste and........................... (F) (I) by way of fixed charge , charges all the bonds, stocks shares and other securities the certificates or other documents of title for which have been deposited by the company with the bank, and which are listed in the second schedule hereto, and any securities substituted with the bank's prior written consent, ( all of which are hereinafter called " the charged shares"), being. Company. Audio processing technology limited. Registered owner. Audio processing technology holdings limited. Holdings. 20,245 ordinary "a" shares of £ 1.00 each.
    Persone aventi diritto
    • Ulster Bank Limited
    • Ulster Bank Limited
    Transazioni
    • 02 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (402 NI)

    APT LICENSING LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    06 ago 2020Inizio della liquidazione
    13 ago 2021Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Peter Michael Allen
    19 Bedford Street
    BT2 7EJ Belfast
    County Antrim
    Praticante
    19 Bedford Street
    BT2 7EJ Belfast
    County Antrim

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0