NIHG LIMITED
Panoramica
| Nome della società | NIHG LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | NI072131 |
| Giurisdizione | Irlanda del Nord |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di NIHG LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova NIHG LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | C/O Tughans Llp, The Ewart 3 Bedford Square BT2 7EP Belfast Northern Ireland |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di NIHG LIMITED?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2024 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per NIHG LIMITED?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 02 lug 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 16 lug 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 02 lug 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per NIHG LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Dichiarazione di conformità presentata il 02 lug 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2024 | 28 pagine | AA | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2023 | 29 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 02 lug 2024 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Modifica dei dettagli di Pfi 2005 Limited come persona con controllo significativo il 23 ott 2017 | 2 pagine | PSC05 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2022 | 52 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 22 mar 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Cessazione della carica di John Stephen Gordon come amministratore in data 29 gen 2024 | 1 pagine | TM01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da The Ewart 3 Bedford Square Belfast BT2 7EP Northern Ireland a C/O Tughans Llp, the Ewart 3 Bedford Square Belfast BT2 7EP in data 03 lug 2023 | 1 pagine | AD01 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2021 | 52 pagine | AA | ||
Indirizzo della sede legale modificato da At the Offices of Tughans Marlborough House 30 Victoria Street Belfast BT1 3GS a The Ewart 3 Bedford Square Belfast BT2 7EP in data 05 mag 2023 | 1 pagine | AD01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 30 mar 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Rebecca Michelle Baxter come amministratore in data 31 dic 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Leo William Mckenna come amministratore in data 31 dic 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Leo William Mckenna il 20 lug 2022 | 2 pagine | CH01 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr. Matthew Templeton il 20 lug 2022 | 2 pagine | CH01 | ||
Cessazione della carica di Roger Mark Thompson come amministratore in data 01 apr 2022 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di Mr John Stephen Gordon come amministratore in data 01 apr 2022 | 2 pagine | AP01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 mar 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Resolis Limited come segretario in data 31 gen 2022 | 2 pagine | AP04 | ||
Cessazione della carica di Ailison Louise Mitchell come segretario in data 31 gen 2022 | 1 pagine | TM02 | ||
Bilancio consolidato redatto al 31 dic 2020 | 55 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Leo William Mckenna il 04 gen 2021 | 2 pagine | CH01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 24 mar 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Mr Matthew Templeton come amministratore in data 02 ott 2020 | 2 pagine | AP01 | ||
Chi sono gli amministratori di NIHG LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESOLIS LIMITED | Segretario | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England |
| 285489620001 | ||||||||||
| BAXTER, Rebecca Michelle | Amministratore | 11th Floor 19 Canning Street EH3 8EG Edinburgh C/O Resolis Limited Exchange Tower United Kingdom | United Kingdom | British | 291987410001 | |||||||||
| TEMPLETON, Matthew | Amministratore | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | United Kingdom | British | 175541650001 | |||||||||
| MITCHELL, Ailison Louise | Segretario | 3rd Floor, 3-5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services Ltd United Kingdom | 244773730001 | |||||||||||
| TUGHANS COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 30 Victoria Street BT1 8GS Belfast Marlborough House United Kingdom |
| 77307240001 | ||||||||||
| ELLIOTT, Noel Michael | Amministratore | Whitethorn House,Knockateery Cloverhill Belturbet Cavan County Cavan | Ireland | British | 144958090001 | |||||||||
| EMSDEN, Peter | Amministratore | Clare House, Wood End, CB11 ESN Widdington, Saffron Walden Essex | United Kingdom | British | 143965590001 | |||||||||
| FOOT, David Alexander John | Amministratore | 3 - 5 Charlotte Street M1 4HB Manchester C/O Albany Spc Services, 3rd Floor England | England | British | 246977650001 | |||||||||
| GEARY, Conor James | Amministratore | St Helens 1 Undershaft EC3A 8AB London Aib England | United Kingdom | Irish | 185269010001 | |||||||||
| GORDON, John Stephen | Amministratore | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | Scotland | British | 203724200001 | |||||||||
| GORDON, John Stephen | Amministratore | 35 Melville Street EH3 7JF Edinburgh Dalmore Capital Scotland | Scotland | British | 203724200001 | |||||||||
| HAMEER, Murtaza Gulamabbas | Amministratore | Fsg- Uk Equity Investments, Allied Irish Bank (Gb) St Helens, 1 Undershaft, EC3A 8AB London 1 England | England | British | 183428020001 | |||||||||
| HARRIS, John David | Amministratore | Floor 200 Aldersgate Street EC1A 4HD London 17th United Kingdom | England | British | 174333200001 | |||||||||
| HOLDEN, Mark Geoffrey David | Amministratore | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 England | England | British | 170508700001 | |||||||||
| JONES, Stephen Michael | Amministratore | At The Offices Of Tughans Marlborough House BT1 3GS 30 Victoria Street Belfast | United Kingdom | British | 88268290001 | |||||||||
| MARSDEN, Robert James | Amministratore | Park House 2 Dee Hills Park CH3 5AR Chester England | England | British | 86971250002 | |||||||||
| MCKENNA, Leo William | Amministratore | Caledonian Exchange 19a Canning Street EH3 8EG Edinburgh Dalmore Capital United Kingdom | Northern Ireland | Irish | 164592610002 | |||||||||
| MCNALLY, Michael Alexander | Amministratore | Undershaft EC3A 8AB London 1 England | England | British | 206738890001 | |||||||||
| NEWTON, Robert James | Amministratore | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 England | United Kingdom | British | 295465260001 | |||||||||
| SPRINGETT, Scott | Amministratore | c/o Infrared Capital Partners Limited Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 England | United Kingdom | British | 117580260002 | |||||||||
| SUTHERLAND, Douglas Iain | Amministratore | Clard House Stratton Chase Drive HP8 4NS Chalfond St Giles Buckinghamshire | United Kingdom | British | 257902560001 | |||||||||
| THOMPSON, Roger Mark | Amministratore | Kelsall Road Ashton CH3 8BH Cheshire Stonehaven England | United Kingdom | British | 36473240008 | |||||||||
| THOMPSON, Roger Mark | Amministratore | Kelsall Road Ashton Hayes CH3 8BH Chester Stonehaven United Kingdom | United Kingdom | British | 36473240008 | |||||||||
| WHITEHEAD, Paul Maitland, Mr. | Amministratore | 2nd Floor, St Helen's 1 Undershaft EC3A 8AB London Aib England | England | British | 74321460003 | |||||||||
| FCC CONSTRUCCION S.A. | Amministratore | C/O 3 Balmes 08007 Barcelona No 36 Spain |
| 143965550002 | ||||||||||
| NEVASA INVERSION S L | Amministratore | Avendia General Peron 28020 Madrid No 36 Spain Spain |
| 143965570002 | ||||||||||
| VIALIA SOCIEDAD GESTORA DE CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS S.L. | Amministratore | Avendia General Peron 28020 Madrid No 36 Spain Spain |
| 143965560003 |
Chi sono le persone con controllo significativo di NIHG LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashover Project Investments Limited | 26 nov 2019 | Park Row LS1 5AB Leeds 1 United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Infrastructure Investments General Partner Ltd | 08 mar 2018 | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 Charles Ii Street England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| European Healthcare Projects Limited | 06 apr 2016 | Charles Ii Street SW1Y 4QU London 12 England | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Allied Irish Banks Public Limited Company | 06 apr 2016 | Ballsbridge Dublin 4 Bankcentre Ireland | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Pfi 2005 Limited | 06 apr 2016 | Park Row LS1 5AB Leeds 1 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0