THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP

THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà in accomandita semplice
    Numero di società OC300507
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Dove si trova THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP?

    Indirizzo della sede legale
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al05 apr 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società a responsabilità limitata dal registro

    2 pagineLLDS01

    Cessazione della carica di Trevor Julian Worthington Botham come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Kevin Oliver Udell come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Philip Patrick Smith come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Simon Francis Winn come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Iestyn Milton Williams come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Anthony Bernard St John Webb come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Walter Henry Rupert Wilkes come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Michael James Walker come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Stephen William Vaughan come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Christopher John Wade come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Christopher Vallender come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Anthony Gibson Usher come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Martin Philip Trees come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Gary Gerard Toner come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Daniel Thompson come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Simon Andrew Thorogood come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di David Allan Thorpe come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Geoffrey Michael Stevens come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Clifford Mark Sturt come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Tony Paul Smith come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Jacqueline Stephens come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Stephen Anthony Smith come socio in data 11 apr 2019

    1 pagineLLTM01

    Chi sono gli amministratori di THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INVICTA FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Socio designato di LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4244535
    141180010001
    SOVEREIGN FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Socio designato di LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4244204
    141180020001
    ADRIAN SMITH, Christine
    37 Peter Avenue
    RH8 9LG Oxted
    Socio di LLP
    37 Peter Avenue
    RH8 9LG Oxted
    United Kingdom141213220001
    ANDREW, Jonathan
    Steels Lane
    Cherington
    CV36 5HL Shipston On Stour
    The Thatched Cottage
    Warwickshire
    Socio di LLP
    Steels Lane
    Cherington
    CV36 5HL Shipston On Stour
    The Thatched Cottage
    Warwickshire
    England88713160003
    ANTHONY, Johanne
    Pear Tree Cottage
    Church Way Ecton
    NN6 0QE Northampton
    Socio di LLP
    Pear Tree Cottage
    Church Way Ecton
    NN6 0QE Northampton
    United Kingdom141213460001
    ANTHONY, Nigel Richard Dalton
    Pear Tree Cottage
    Church Way Ecton
    NN6 0QE Northampton
    Socio di LLP
    Pear Tree Cottage
    Church Way Ecton
    NN6 0QE Northampton
    United Kingdom111623810002
    BAIRD, Robert George
    44 Elms Road
    SW4 9EX London
    Socio di LLP
    44 Elms Road
    SW4 9EX London
    United Kingdom32823440001
    BAKER, Martin Keith
    15 Dault Road
    Wandsworth
    SW18 2NH London
    Socio di LLP
    15 Dault Road
    Wandsworth
    SW18 2NH London
    United Kingdom116071820001
    BAKER, Richard Andrew
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Socio di LLP
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    United Kingdom290972040001
    BARNES, Andrew Seton
    1 Upper Cheyne Row
    SW3 5JW London
    The Cottage
    Socio di LLP
    1 Upper Cheyne Row
    SW3 5JW London
    The Cottage
    United Kingdom119126870001
    BEDFORD, Lindsay Paul
    York Road
    RG1 8DX Reading
    54
    Berkshire
    Socio di LLP
    York Road
    RG1 8DX Reading
    54
    Berkshire
    United Kingdom141223660002
    BENNETT, Michael Andrew
    32 Burwood Park Road
    KT12 5LH Walton On Thames
    Socio di LLP
    32 Burwood Park Road
    KT12 5LH Walton On Thames
    United Kingdom56285510001
    BEST, Anthony John
    64 Chester Square
    SW1W 9EA London
    Socio di LLP
    64 Chester Square
    SW1W 9EA London
    United Kingdom141213930001
    BISHOP, Robert
    The Coach House
    4 Manor House Drive
    ME16 8AJ Maidstone
    Socio di LLP
    The Coach House
    4 Manor House Drive
    ME16 8AJ Maidstone
    United Kingdom141213240004
    BOLAND, Stanley
    Litchfield House
    Finch Lane Knotty Green
    HP9 2TL Beaconsfield
    Socio di LLP
    Litchfield House
    Finch Lane Knotty Green
    HP9 2TL Beaconsfield
    United Kingdom141223680001
    BOTHAM, Trevor Julian Worthington
    10 Vanbrugh Fields
    SE3 7TZ London
    Socio di LLP
    10 Vanbrugh Fields
    SE3 7TZ London
    United Kingdom141223590001
    BRERETON, Michael Philip
    3 Pondwicks Close
    AL1 1DG St Albans
    Socio di LLP
    3 Pondwicks Close
    AL1 1DG St Albans
    141213610001
    BRIGDEN, Steve John
    60 Crown Road
    OX33 1UL Wheatley
    Socio di LLP
    60 Crown Road
    OX33 1UL Wheatley
    United Kingdom141213650001
    BROWN, Michael Ross
    1 Ayres End Cottages
    Ayres End Lane
    AL5 1AL Harpenden
    Socio di LLP
    1 Ayres End Cottages
    Ayres End Lane
    AL5 1AL Harpenden
    United Kingdom66293640001
    BRYANT, Clive
    3 Chapel Close
    NN12 8HZ Litchborough
    Socio di LLP
    3 Chapel Close
    NN12 8HZ Litchborough
    United Kingdom141213540001
    CAKEBREAD, Stuart Alan Charles
    Manor Cottage
    The Green
    OX12 0LQ West Hanney
    Socio di LLP
    Manor Cottage
    The Green
    OX12 0LQ West Hanney
    United Kingdom141213960001
    CAMPBELL, Colin William Roderick
    44 Kingfield Road
    S11 9AS Sheffield
    Socio di LLP
    44 Kingfield Road
    S11 9AS Sheffield
    United Kingdom141223650001
    CAMRASS, Roger Jeremy
    34 Stormont Road
    N6 4NP London
    Socio di LLP
    34 Stormont Road
    N6 4NP London
    England45860180002
    CHALK, John William
    Flat 1501 20 Palace Street
    SW1E 5BB London
    Socio di LLP
    Flat 1501 20 Palace Street
    SW1E 5BB London
    United Kingdom74739180015
    CHALK, Peter Henry
    Hopdene Court
    Holmbury St Mary
    RH5 6PE Dorking
    Socio di LLP
    Hopdene Court
    Holmbury St Mary
    RH5 6PE Dorking
    United Kingdom141213880001
    COURTLEY, David John
    25 Mount Pleasant Villas
    Crouch End
    N4 4HH London
    Socio di LLP
    25 Mount Pleasant Villas
    Crouch End
    N4 4HH London
    England141213480001
    CRAWFORD, Philip James
    Cranbourne Lodge
    Drift Road
    SL4 4RP Winkfield
    Socio di LLP
    Cranbourne Lodge
    Drift Road
    SL4 4RP Winkfield
    England61146460001
    CREAGER, David Howard
    25 Tretawn Park
    Mill Hill
    NW7 4PS London
    Socio di LLP
    25 Tretawn Park
    Mill Hill
    NW7 4PS London
    United Kingdom119102510001
    CUSSINS, Peter Ian
    Bitchfield Tower
    Belsay
    NE20 0JP Newcastle Upon Tyne
    Socio di LLP
    Bitchfield Tower
    Belsay
    NE20 0JP Newcastle Upon Tyne
    United Kingdom68297000001
    DENHAM, Andrew Victor
    Manor Farm Cottage
    Tunworth Road
    RG25 0LU Mapledurwell
    Socio di LLP
    Manor Farm Cottage
    Tunworth Road
    RG25 0LU Mapledurwell
    England141213640001
    DOOTSON, David Philip
    158 Manchester Road
    SK9 2JW Wilmslow
    Socio di LLP
    158 Manchester Road
    SK9 2JW Wilmslow
    United Kingdom181912770001
    DUERDEN, John Henry
    1 Elwell Avenue
    HU17 8HJ Beverley
    Socio di LLP
    1 Elwell Avenue
    HU17 8HJ Beverley
    United Kingdom13822610002
    DYSON, Fernley Keith
    Oak House
    Broom Way
    KT13 9TG Weybridge
    Socio di LLP
    Oak House
    Broom Way
    KT13 9TG Weybridge
    63727860003
    EYRE, Raymond Charles
    79 Addison Road
    Holland Park
    W14 8ED London
    Socio di LLP
    79 Addison Road
    Holland Park
    W14 8ED London
    England44367560006
    FEAST, Alan George
    49 Chillerton Road
    SW17 9BE London
    Socio di LLP
    49 Chillerton Road
    SW17 9BE London
    England141213940001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    26 set 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    THE INVICTA FILM PARTNERSHIP NO.4, LLP ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over assets
    Creato il 01 ago 2002
    Consegnato il 05 ago 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the whole and every part of its right title and interest in and to all monies from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with the right to demand the same. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sociiti Ginirale
    Transazioni
    • 05 ago 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over assets
    Creato il 02 mag 2002
    Consegnato il 03 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the whole of the company's rights, title and interest in and to all moneys, the right to demand the same, the debts, any proceeds of the above, all causes of action etc.. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 03 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over assets
    Creato il 02 mag 2002
    Consegnato il 03 mag 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the whole of the company's rights, title and interest in and to all moneys, the right to demand the same, the debts, any proceeds of the above, all causes of action etc.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 03 mag 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over assets
    Creato il 17 apr 2002
    Consegnato il 25 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All monies from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 25 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over assets
    Creato il 05 apr 2002
    Consegnato il 16 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All present and future obligations and liabilities of the borrowers or any of them to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the whole and every part of its right title and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each present and future dedicated account together with the right to demand the same and the debts represented thereby including all interest (if any) any proceeds all causes of action assigns all rights title and interest in and to all present and future minimum revenue entitlement all guarantees all moneys due and payable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale
    Transazioni
    • 16 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Pledge and charge
    Creato il 05 apr 2002
    Consegnato il 15 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    (1) charged (subject only to the rights and interest of parties to the prior agreements and the transcation documents and as otherwise provided in the pledge and charge), all the chargor's right, title and interest in the assigned rights and the licensed rights, and (2) pledged the delivery material to the chargee.
    Persone aventi diritto
    • Sogelease Films, a Partnership Acting Through Its Partners, Alvarengainvestments B.V. and Herfsttafel Incestments B.V.
    Transazioni
    • 15 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over assets
    Creato il 05 apr 2002
    Consegnato il 12 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge over all right,title and interest in and to all moneys standing to the credit of each dedicated account and the debts represented thereby with all interest owing and any proceeds thereof; all minimum revenue entitlement,guarantees,letters of credit,deposits or other security. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale (London Branch)
    Transazioni
    • 12 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over assets
    Creato il 15 mar 2002
    Consegnato il 03 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right title and interest in and to all moneys standing to the credit of each present and future dedicated account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale (London Branch)
    Transazioni
    • 03 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over assets
    Creato il 15 mar 2002
    Consegnato il 03 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from from the borrowers to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right title and interest in and to all moneys standing to the credit of each present and future dedicated account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale (London Branch)
    Transazioni
    • 03 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Pledge and charge
    Creato il 15 mar 2002
    Consegnato il 26 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The delivery material. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sogelease Films, a Partnership Acting Through Its Partners Alvarenga Investments B.V.and Herfsttafel Investments B.V.
    Transazioni
    • 26 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Pledge and charge
    Creato il 15 mar 2002
    Consegnato il 26 mar 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Pledged and the delivery materials to the chargee. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sogelease Films, a Partnership Acting Through Its Partners Alvarenga Investments B.V.and Herfsttafel Investments B.V.
    Transazioni
    • 26 mar 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 apr 2019Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0