THE INVICTA FILM PARTNERSHIP, LLP

THE INVICTA FILM PARTNERSHIP, LLP

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE INVICTA FILM PARTNERSHIP, LLP
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà in accomandita semplice
    Numero di società OC300510
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Dove si trova THE INVICTA FILM PARTNERSHIP, LLP?

    Indirizzo della sede legale
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Middlesex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE INVICTA FILM PARTNERSHIP, LLP?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al05 apr 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per THE INVICTA FILM PARTNERSHIP, LLP?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società a responsabilità limitata dal registro

    3 pagineLLDS01

    Cessazione della carica di Michael Barber come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Iestyn Milton Williams come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Ian Martin Wilkinson come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Ali Abbas Zaidi come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Hannah Wilders come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Stephen William Vaughan come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Alan Malcolm Thompson come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Peter Shearan come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di William Gennydd Thomas come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Ian Charles Sampson come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di James Peter Renwick come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Simon Redmile come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Guy Alexander Radcliffe come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Alvin Stewart Powell come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di John Nicholas Powell come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Michael John Pook come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di David Charles Langrigge Perkins come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Grant Notman come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Michael James Owen come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Wade Rames Newmark come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Steven Neat come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Cessazione della carica di Paul Stanley Mountford come socio in data 13 feb 2019

    1 pagineLLTM01

    Chi sono gli amministratori di THE INVICTA FILM PARTNERSHIP, LLP?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INVICTA FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Socio designato di LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4244535
    141180010001
    SOVEREIGN FILM NOMINEES LIMITED
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Socio designato di LLP
    99 Kenton Road
    HA3 0AN Harrow
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4244204
    141180020001
    ANDREWS, Charles John Maynard
    Wildwood
    Harpsden Woods Harpsden
    RG9 4AD Henley On Thames
    Socio di LLP
    Wildwood
    Harpsden Woods Harpsden
    RG9 4AD Henley On Thames
    United Kingdom141194640001
    ANDREWS, John Martin Hough, Dr
    Grindon
    ST13 7TT Leek
    Deepdale Farm
    Staffordshire
    Socio di LLP
    Grindon
    ST13 7TT Leek
    Deepdale Farm
    Staffordshire
    United Kingdom130189070001
    ANTHONY, Dirk Posthumus
    Tree Tops
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    Socio di LLP
    Tree Tops
    Church Road, Leigh Woods
    BS8 3PG Bristol
    United Kingdom141194480001
    BARBER, Michael
    Church Farm House
    Framingham Lane Bramerton
    NR14 7HF Norwich
    Socio di LLP
    Church Farm House
    Framingham Lane Bramerton
    NR14 7HF Norwich
    United Kingdom62450560001
    BATTISON, Phillip Stephen
    Tudor House
    Main Road
    NN11 5NN Whilton
    Socio di LLP
    Tudor House
    Main Road
    NN11 5NN Whilton
    United Kingdom141194610001
    BIRKHOLM, Peter
    Wood Lane
    Kidmore End
    RG4 9BE Reading
    Cold Norton
    England
    Socio di LLP
    Wood Lane
    Kidmore End
    RG4 9BE Reading
    Cold Norton
    England
    England141194400002
    BRETT, Andrew Jonathan
    Nycolles Wood
    SG1 4GR Stevenage
    3
    England
    Socio di LLP
    Nycolles Wood
    SG1 4GR Stevenage
    3
    England
    England266002360001
    BRIAN, John
    Somerset Lifesyle Retirement Village
    136 Bizweni Avenue
    Somerset West
    Mail Box 25
    7130
    South Africa
    Socio di LLP
    Somerset Lifesyle Retirement Village
    136 Bizweni Avenue
    Somerset West
    Mail Box 25
    7130
    South Africa
    South Africa141194360002
    BRIGDEN, Steve John
    60 Crown Road
    OX33 1UL Wheatley
    Socio di LLP
    60 Crown Road
    OX33 1UL Wheatley
    United Kingdom141213650001
    BRITTON, Christopher David
    9 Church Green
    Barnwell
    PE8 5QH Peterborough
    Le Moine House
    England
    Socio di LLP
    9 Church Green
    Barnwell
    PE8 5QH Peterborough
    Le Moine House
    England
    England141202960002
    BROWN, Kerry Dillon
    Newport Road
    TF9 2AA Market Drayton
    Tyrley Castle Cottage
    England
    Socio di LLP
    Newport Road
    TF9 2AA Market Drayton
    Tyrley Castle Cottage
    England
    United Kingdom141203570002
    CAMPANINI, James Aldo
    Beech Park
    Walters Ash
    HP14 4XL High Wycombe
    16
    Buckinghamshire
    Socio di LLP
    Beech Park
    Walters Ash
    HP14 4XL High Wycombe
    16
    Buckinghamshire
    United Kingdom141194450001
    CAMRASS, Roger Jeremy
    34 Stormont Road
    N6 4NP London
    Socio di LLP
    34 Stormont Road
    N6 4NP London
    England45860180002
    CATTELL, Philip
    Westleigh
    Toot Hill Road, Greensted
    CM5 9LH Ongar
    Socio di LLP
    Westleigh
    Toot Hill Road, Greensted
    CM5 9LH Ongar
    United Kingdom8535140004
    CORCORAN, Andrew Alan
    Burntwood
    CM14 4FJ Brentwood
    5
    England
    Socio di LLP
    Burntwood
    CM14 4FJ Brentwood
    5
    England
    United Kingdom141194420002
    COUPE, Michael Andrew
    6 Driffield Terrace
    YO24 1EJ York
    Socio di LLP
    6 Driffield Terrace
    YO24 1EJ York
    United Kingdom141203090001
    CRAWFORD, Philip James
    Cranbourne Lodge
    Drift Road
    SL4 4RP Winkfield
    Socio di LLP
    Cranbourne Lodge
    Drift Road
    SL4 4RP Winkfield
    England61146460001
    DERBYSHIRE, Gareth Wyn
    Damhead, Lothianburn
    EH10 7DZ Edinburgh
    Pentland View House
    Scotland
    Socio di LLP
    Damhead, Lothianburn
    EH10 7DZ Edinburgh
    Pentland View House
    Scotland
    Scotland141194340002
    ENTWHISTLE, Eric
    Springside Farm
    Springside Road Walmersley
    BL9 5QU Bury
    Socio di LLP
    Springside Farm
    Springside Road Walmersley
    BL9 5QU Bury
    United Kingdom141194330001
    ENTWISTLE, Gary
    Prospect House
    Whalley Road Shuttleworth
    BL0 0ED Ramsbottom
    Socio di LLP
    Prospect House
    Whalley Road Shuttleworth
    BL0 0ED Ramsbottom
    United Kingdom141194440001
    ENTWISTLE, Lorne
    Springside Farm
    Springside Road, Walmersley
    BL9 5QU Bury
    Socio di LLP
    Springside Farm
    Springside Road, Walmersley
    BL9 5QU Bury
    United Kingdom146476930001
    GADSBY, Peter James
    Burley Grange
    Burley Lane
    DE22 5JR Quarndon
    Socio di LLP
    Burley Grange
    Burley Lane
    DE22 5JR Quarndon
    England93167510001
    GILBERT, Paul John Thomas
    Oldfield
    St Marys Road
    WA14 2PJ Bowdon
    Socio di LLP
    Oldfield
    St Marys Road
    WA14 2PJ Bowdon
    United Kingdom141202980001
    HINE, Paul Augustine
    19 Downs Road
    South Wonston
    SO21 3EU Winchester
    Socio di LLP
    19 Downs Road
    South Wonston
    SO21 3EU Winchester
    England141194580001
    JOHNSON, Stephen Richard
    The Old Vicarage
    Lower Dunsforth
    YO26 9SA York
    Socio di LLP
    The Old Vicarage
    Lower Dunsforth
    YO26 9SA York
    England87398750001
    KENDRICK, Graham Douglas
    Dee Hills Park
    CH3 5AU Chester
    Apartment 8 Deeside Court
    United Kingdom
    Socio di LLP
    Dee Hills Park
    CH3 5AU Chester
    Apartment 8 Deeside Court
    United Kingdom
    United Kingdom141194470002
    KING, Bruce Douglas
    Eaton Rise
    Ealing
    W5 2ER London
    42
    Socio di LLP
    Eaton Rise
    Ealing
    W5 2ER London
    42
    England141203050001
    LENNOX, Geoffrey
    Windfield
    Main Road Old Brampton
    S42 7JG Chesterfield
    Socio di LLP
    Windfield
    Main Road Old Brampton
    S42 7JG Chesterfield
    United Kingdom29585680002
    LOWE, Nicholas
    Allington
    Court Lane
    SO24 0DE Ropley
    Hampshire
    Socio di LLP
    Allington
    Court Lane
    SO24 0DE Ropley
    Hampshire
    United Kingdom141221170001
    MAPP, Derek
    Sudbrook Hall Nesfield
    Barlow
    S18 7TB Dronfield
    Socio di LLP
    Sudbrook Hall Nesfield
    Barlow
    S18 7TB Dronfield
    United Kingdom12473610002
    MC LEMAN, David
    Bequia
    The Spinney
    SL5 0AS Sunningdale
    Socio di LLP
    Bequia
    The Spinney
    SL5 0AS Sunningdale
    United Kingdom141203110001
    MCLEOD, Ian James
    Ponte Vedra Boulevard
    Pnte Vedra
    Florida 32082
    1117
    Usa
    Socio di LLP
    Ponte Vedra Boulevard
    Pnte Vedra
    Florida 32082
    1117
    Usa
    United States141194430003
    MOUNTFORD, Paul Stanley
    The Pheasantry
    Bramshill Park
    RG27 0JN Hook
    Socio di LLP
    The Pheasantry
    Bramshill Park
    RG27 0JN Hook
    United Kingdom71600090003

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per THE INVICTA FILM PARTNERSHIP, LLP?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    26 set 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    THE INVICTA FILM PARTNERSHIP, LLP ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over assets
    Creato il 05 apr 2002
    Consegnato il 16 apr 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed charge over all right,title,benefit and interest in and to all monies from time to time standing to the credit of each account of the company pursuant to a lease agreement dated 5/4/2002; floating charge over the business,undertaking,property,assets,revenues and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 16 apr 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2018Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over assets
    Creato il 23 gen 2002
    Consegnato il 29 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the chargors rights title benefit and interest in and to all moneys standing to the credit of each present and future account please refer to form 395 for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2018Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Pledge and charge
    Creato il 10 gen 2002
    Consegnato il 22 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all the right, title and interest in the assigned rights and the licensed rights. Pledged the delivery material.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sogelease Films, a Partnership Acting Through Its Partners, Alvarengainvestments B.V. and Herfsttafel Investments B.V.
    Transazioni
    • 22 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2018Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over assets
    Creato il 10 gen 2002
    Consegnato il 21 gen 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all of the chargor's rights, title, benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each present and future account. By way of first absolute assignment the lease agreement and the guarantee.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 gen 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2018Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)
    Charge over assets
    Creato il 21 nov 2001
    Consegnato il 07 dic 2001
    In corso
    Importo garantito
    All amounts loaned by the chargee to certain members of the chargor ("the members") pursuant to facility letters between the chargee and the members and all obligations and liabilities of the members thereunder
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all rights title benefit and interest in and to all moneys from time to time standing to the credit of each present and future account of the chargor with the chargee ("dedicated account") to which all amounts ("the rental payments") are payable from time to time pursuant to the lease agreement all right title and interest in the lease agreement the guarantee and by way of floating charge the business undertaking property assets revenues and rights present and future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 07 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    Pledge and charge
    Creato il 21 nov 2001
    Consegnato il 06 dic 2001
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the limited liability partnership to the chargee under or pursuant to the partnership lease agreement
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all the chargor's rights, title and interest in the assigned rights and the licensed rights; and pledged the delivery material to the chargee.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sogelease Films, a Partnership Acting by and Through Its Partners, Alvarenga Investements B.V.and Herfsttafel Investments B.V.
    Transazioni
    • 06 dic 2001Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ago 2018Soddisfazione di un'ipoteca (LLMR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0